CITY AND NORTHERN ESTATES LIMITED

CITY AND NORTHERN ESTATES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCITY AND NORTHERN ESTATES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02383492
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CITY AND NORTHERN ESTATES LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich CITY AND NORTHERN ESTATES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Bankside 14 The Watermark
    NE11 9SY Gateshead
    Tyne And Wear
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CITY AND NORTHERN ESTATES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FORKWORTH LIMITED15. Mai 198915. Mai 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CITY AND NORTHERN ESTATES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für CITY AND NORTHERN ESTATES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01
    A62ERX7S

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016

    3 SeitenAA
    X5LUO2GP

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 18. Mai 2016

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01
    X5787MQ2

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015

    3 SeitenAA
    X4M9ARE3

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 20. Mai 2015

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01
    X47RWW9T

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2014

    3 SeitenAA
    X3MXV0NF

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 22. Mai 2014

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01
    X38FJPAB

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Bankside 6 the Watermark Gateshead Tyne and Wear NE11 9SY United Kingdom* am 07. März 2014

    1 SeitenAD01
    X3339DQP

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2013

    3 SeitenAA
    X2MZI73M

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    X29YUOWQ

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2012

    12 SeitenAA
    A20C6HX7

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    X19LGTFC

    Kapitalaufstellung am 27. März 2012

    • Kapital: GBP 1,000
    4 SeitenSH19
    Q15JUF9E

    legacy

    1 SeitenSH20
    A15LY79T

    legacy

    1 SeitenCAP-SS
    Q15JUF7M

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    14 SeitenAA
    A0OR31LT

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Keel Row 3, the Watermark Gateshead Tyne and Wear NE11 9SZ* am 29. Sept. 2011

    1 SeitenAD01
    XVV5EXX0

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    XNDOGU83

    Änderung der Details des Direktors für Catherine Jane Cannon am 16. Mai 2010

    2 SeitenCH01
    XNDOFU82

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    15 SeitenAA
    AUYQPQCJ

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    X8G3EKQC

    Änderung der Details des Direktors für Catherine Jane Cannon am 15. Mai 2010

    2 SeitenCH01
    X8G3DKQB

    Wer sind die Geschäftsführer von CITY AND NORTHERN ESTATES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WARD, Elliott Allan
    Whiteside Grange
    Whalton
    NE61 3XQ Morpeth
    Northumberland
    Sekretär
    Whiteside Grange
    Whalton
    NE61 3XQ Morpeth
    Northumberland
    BritishDirector94095750001
    CANNON, Catherine Jane
    8 Heath Hill
    Heddon-On-The-Wall
    NE15 0DQ Newcastle Upon Tyne
    Linton House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    8 Heath Hill
    Heddon-On-The-Wall
    NE15 0DQ Newcastle Upon Tyne
    Linton House
    United Kingdom
    United KingdomBritishMarketing Director10677590002
    WARD, Elliott Allan
    Whiteside Grange
    Whalton
    NE61 3XQ Morpeth
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Whiteside Grange
    Whalton
    NE61 3XQ Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritishDirector94095750001
    CRAWFORD, Norman
    11 Aydon Crescent
    NE45 5EB Corbridge
    Northumberland
    Sekretär
    11 Aydon Crescent
    NE45 5EB Corbridge
    Northumberland
    British2832580001
    WARD, Elliott
    Locksley Cottage
    East Wallhouses
    NE18 0LL Newcastle
    Sekretär
    Locksley Cottage
    East Wallhouses
    NE18 0LL Newcastle
    BritishSecretary2832590013
    CANNON, Catherine Jane
    South Dissington Farm
    Ponteland
    NE18 0BN Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    South Dissington Farm
    Ponteland
    NE18 0BN Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishCompany Director10677590001
    COMBE, Jonathan Woods
    4 The Broadway
    Tynemouth
    NE30 2LD North Shields
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    4 The Broadway
    Tynemouth
    NE30 2LD North Shields
    Tyne & Wear
    EnglandIrishSolicitor107062500001
    MCCOULL, Elizabeth Ann
    The Heugh
    Barrasford
    NE48 4BX Hexham
    Northumberland
    Geschäftsführer
    The Heugh
    Barrasford
    NE48 4BX Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritishCompany Director7115340001
    WARD, Ann
    Shildon Grange
    NE45 5PT Corbridge
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Shildon Grange
    NE45 5PT Corbridge
    Northumberland
    BritishCompany Director2832600001
    WARD, Elliott
    Locksley Cottage
    East Wallhouses
    NE18 0LL Newcastle
    Geschäftsführer
    Locksley Cottage
    East Wallhouses
    NE18 0LL Newcastle
    United KingdomBritishDirector2832590013

    Hat CITY AND NORTHERN ESTATES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge deed
    Erstellt am 26. März 2004
    Geliefert am 31. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all that f/h land k/a office block a the watermark metro riverside park gateshead tyne & wear t/n TY378719 and all its fixtures by way of specific charge all income in relation to the property, assigns the related rights, by way of floating charge the undertaking and all other property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 31. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Charge deed
    Erstellt am 04. Sept. 2003
    Geliefert am 09. Sept. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a office block 5, the watermark at metro riverside, gateshead t/no. TY378719 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale.assigned to the lender the related rights.fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery.floating charge the undertaking all property and assets.assigned the goodwill and the intellectual property.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of various agreements
    Erstellt am 22. Mai 2003
    Geliefert am 04. Juni 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the companys rights title and interest in and to the agreements meaning the sale agreement dated 22 may 2003 and the assignment of guarantee. All rights and benefits of the company arising out of or in connection with any breach or default.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 04. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Charge deed
    Erstellt am 22. Mai 2003
    Geliefert am 04. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that freehold land lying to the north of riverside way gateshead title number TY382762 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale.assigned to the lender the related rights.fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery.floating charge the undertaking all property and assets.assigned the goodwill and the intellectual property.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 04. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Dez. 2001
    Geliefert am 03. Jan. 2002
    Teilweise erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the chaarge
    Kurze Angaben
    Phases ii and iii metro riverside park gateshead tyne and wear.
    Berechtigte Personen
    • J F Miller Properties Limited
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Dez. 2001
    Geliefert am 12. Dez. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the f/h property k/a the watermark, land to the west of metro riverside park, gateshead, tyne & ware, NE11 9SZ.. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2000
    Geliefert am 03. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement or this legal charge (of even date)
    Kurze Angaben
    The freehold property known as land at metro riverside park gateshead tyne and wear title number TY315222.
    Berechtigte Personen
    • John Mowlem & Company PLC
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0