BURNT TREE GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBURNT TREE GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02384046
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BURNT TREE GROUP LIMITED?

    • Vermietung und Leasing von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen (77110) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
    • Vermietung und Leasing von Lkw und anderen schweren Fahrzeugen (77120) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich BURNT TREE GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o STEVE YOUNG
    Enterprise House
    Vicarage Road
    TW20 9FB Egham
    Surrey
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BURNT TREE GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BURNT TREE CONTRACT HIRE LIMITED30. Aug. 198930. Aug. 1989
    CRAMTRAN LIMITED15. Mai 198915. Mai 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BURNT TREE GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Juli 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für BURNT TREE GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Beendigung der Bestellung von Teresa Anne Holderer als Sekretär am 30. Apr. 2020

    1 SeitenTM02

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Juli 2019

    16 SeitenAA

    legacy

    28 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    2 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Mai 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Juli 2018

    16 SeitenAA

    legacy

    27 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    2 SeitenGUARANTEE2

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Mai 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Juli 2017

    16 SeitenAA

    legacy

    27 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    2 SeitenGUARANTEE2

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Juli 2016

    17 SeitenAA

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Mai 2017 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    legacy

    27 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Ernennung von Ricky Allan Short als Direktor am 31. Juli 2016

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von BURNT TREE GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHORT, Ricky Allan, Mr.
    c/o Steve Young
    Vicarage Road
    TW20 9FB Egham
    Enterprise House
    Surrey
    Geschäftsführer
    c/o Steve Young
    Vicarage Road
    TW20 9FB Egham
    Enterprise House
    Surrey
    United StatesAmerican211402680001
    ASHWORTH, Keith William
    Overdale
    Clive Avenue
    SY6 7BL Church Stretton
    Salop
    Sekretär
    Overdale
    Clive Avenue
    SY6 7BL Church Stretton
    Salop
    British12136320002
    ASHWORTH, Keith William
    Overdale
    Clive Avenue
    SY6 7BL Church Stretton
    Salop
    Sekretär
    Overdale
    Clive Avenue
    SY6 7BL Church Stretton
    Salop
    British12136320002
    DENNISS, Roger Anthony
    Oakfield Hope Valley
    Minsterley
    SY5 0JX Shrewsbury
    Shropshire
    Sekretär
    Oakfield Hope Valley
    Minsterley
    SY5 0JX Shrewsbury
    Shropshire
    British46329110001
    DOUGLASS, Ian Leslie
    10 Borrowdale Close
    DY5 3RW Brierley Hill
    West Midlands
    Sekretär
    10 Borrowdale Close
    DY5 3RW Brierley Hill
    West Midlands
    British61669260001
    HOLDERER, Teresa Anne
    c/o Steve Young
    Vicarage Road
    TW20 9FB Egham
    Enterprise House
    Surrey
    Sekretär
    c/o Steve Young
    Vicarage Road
    TW20 9FB Egham
    Enterprise House
    Surrey
    211392140001
    LAFFEY, Thomas Paul
    c/o Steve Young
    Vicarage Road
    TW20 9FB Egham
    Enterprise House
    Surrey
    England
    Sekretär
    c/o Steve Young
    Vicarage Road
    TW20 9FB Egham
    Enterprise House
    Surrey
    England
    British191859740001
    PURKIS, Stephen Robert
    Knights Way
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3AB Shrewsbury
    Salop
    Sekretär
    Knights Way
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3AB Shrewsbury
    Salop
    169346660001
    ASHWORTH, Keith William
    Berwick Road
    SY1 2LP Shrewsbury
    Severn View
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Berwick Road
    SY1 2LP Shrewsbury
    Severn View
    Shropshire
    EnglandBritish142261590001
    DOUGLASS, Ian Leslie
    10 Borrowdale Close
    DY5 3RW Brierley Hill
    West Midlands
    Geschäftsführer
    10 Borrowdale Close
    DY5 3RW Brierley Hill
    West Midlands
    EnglandBritish61669260001
    HOWELL, Mark Nigel
    The Briars
    36 Catisfield Road
    PO15 5LP Fareham
    1
    Hampshire
    England
    Geschäftsführer
    The Briars
    36 Catisfield Road
    PO15 5LP Fareham
    1
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish59882560010
    HULL, Mark Richard
    105 Braithwell Road
    Ravenfield
    S65 4LP Rotherham
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    105 Braithwell Road
    Ravenfield
    S65 4LP Rotherham
    South Yorkshire
    British67760170001
    JACKSON, Michael Peter
    1 Whitfield Crescent
    OL16 4NA Newhey
    Rochdale
    Geschäftsführer
    1 Whitfield Crescent
    OL16 4NA Newhey
    Rochdale
    EnglandBritish101396440001
    JONES, Gareth John
    Chapel Lane
    Cronton
    WA8 4NX Widnes
    24
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Chapel Lane
    Cronton
    WA8 4NX Widnes
    24
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish107800940002
    KAPLAN, Lee Richard, Mr.
    c/o Steve Young
    Vicarage Road
    TW20 9FB Egham
    Enterprise House
    Surrey
    England
    Geschäftsführer
    c/o Steve Young
    Vicarage Road
    TW20 9FB Egham
    Enterprise House
    Surrey
    England
    United StatesAmerican190858230001
    LAFFEY, Thomas Paul, Mr.
    c/o Steve Young
    Vicarage Road
    TW20 9FB Egham
    Enterprise House
    Surrey
    England
    Geschäftsführer
    c/o Steve Young
    Vicarage Road
    TW20 9FB Egham
    Enterprise House
    Surrey
    England
    UsaAmerican190858560001
    METCALFE, Richard
    Hillock Lane
    Dalton
    WN8 7RJ Wigan
    Hillock House
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Hillock Lane
    Dalton
    WN8 7RJ Wigan
    Hillock House
    Lancashire
    EnglandEnglish60901930003
    PATERICK, Edward Ian Wilson
    Plas Y Bryn
    Cardington Moor Cardington
    SY6 7LL Church Stretton
    Salop
    Geschäftsführer
    Plas Y Bryn
    Cardington Moor Cardington
    SY6 7LL Church Stretton
    Salop
    British54776460001
    PURKIS, Stephen Robert
    Knights Way
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3AB Shrewsbury
    Salop
    Geschäftsführer
    Knights Way
    Battlefield Enterprise Park
    SY1 3AB Shrewsbury
    Salop
    EnglandBritish135467600002
    SHARP, Christopher
    Little Manor House
    Manor Lane
    CV35 8NH Claverdon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Little Manor House
    Manor Lane
    CV35 8NH Claverdon
    Warwickshire
    United KingdomBritish89287360001
    SIMMONDS, John Nicholas Antony
    8 North Hermitage
    SY3 7JW Shrewsbury
    Salop
    Geschäftsführer
    8 North Hermitage
    SY3 7JW Shrewsbury
    Salop
    British65065990001
    SMITH, Juliet May
    The Old School House
    SY5 0DU Minsterley
    Shropshire
    Geschäftsführer
    The Old School House
    SY5 0DU Minsterley
    Shropshire
    EnglandBritish125363190003
    SNYDER, William Wayne
    c/o Steve Young
    Vicarage Road
    TW20 9FB Egham
    Enterprise House
    Surrey
    England
    Geschäftsführer
    c/o Steve Young
    Vicarage Road
    TW20 9FB Egham
    Enterprise House
    Surrey
    England
    UsaAmerican190858380001
    THOMAS, William Francis
    Lakeside House
    Allfield
    SY5 7AP Church Stretton
    Salop
    Geschäftsführer
    Lakeside House
    Allfield
    SY5 7AP Church Stretton
    Salop
    EnglandBritish112321700001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BURNT TREE GROUP LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Enterprise Rent-A-Car Uk Limited
    Vicarage Road
    TW20 9FB Egham
    Steve Young, Enterprise House
    Surrey
    England
    06. Apr. 2016
    Vicarage Road
    TW20 9FB Egham
    Steve Young, Enterprise House
    Surrey
    England
    Nein
    RechtsformLimited Liability Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageThe Laws Of England And Wales
    RegistrierungsortCompanies House Uk
    Registrierungsnummer02946689
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat BURNT TREE GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 05. Juni 2014
    Geliefert am 06. Juni 2014
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Handelsbanken Finans Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 06. Juni 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 13. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 31. Jan. 2014
    Geliefert am 05. Feb. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    None. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Lease N.V.
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 13. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 31. Jan. 2014
    Geliefert am 05. Feb. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    None. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Lease N.V.
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 13. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 10. Dez. 2013
    Geliefert am 14. Dez. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Handelsbanken Finans Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 14. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 13. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 02. Dez. 2013
    Geliefert am 17. Dez. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    None. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Handelsbanken Finans Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 13. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 26. Nov. 2013
    Geliefert am 07. Dez. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    None. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 07. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 13. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 26. Nov. 2013
    Geliefert am 07. Dez. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    None. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Handelsbanken Finans Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 07. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 13. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 29. Okt. 2013
    Geliefert am 30. Okt. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    N/A. notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Handelsbanken Finans Ab(Publ)
    Transaktionen
    • 30. Okt. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 13. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of assignment
    Erstellt am 07. Dez. 2012
    Geliefert am 08. Dez. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the customer to the companies on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest present and future in and to the assigned contracts from time to time including the finance rentals and the right to receive all monies due and to become due under the assigned contracts see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 13. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Master assignment
    Erstellt am 19. März 2012
    Geliefert am 22. März 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any and each of the mortgagees under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies due and to become due under the sub-hire agreements entered into pursuant to the master assignment and the benefit of all assignments guarantees indemnities negotiable instruments and securities in connection with the assigned agreements.
    Berechtigte Personen
    • Santander Asset Finance PLC
    Transaktionen
    • 22. März 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 13. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over sub-hire agreements
    Erstellt am 28. Okt. 2010
    Geliefert am 10. Nov. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    As security for the due and punctual, payment, repayment, satisfaction, performance and discharge of the secured obligations, charges by way of first fixed charge and assigns and agrees to assign absolutely the secured property meaning all rights, title and interest in the sub-hire agreements see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 13. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Master assignment
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 28. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefits of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Juli 2007
    Geliefert am 04. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The subcontracts relating to the vehicles or other goods, the full benefit and advantage of all the monies payable under the subcontracts, the benefit of all guarantees, indemnities, negotiable instruments and securities in connection with the subcontracts, the benefit of all insurances and the benefit of all supplemental or collateral agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Man Financial Services PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 16/01/01 and
    Erstellt am 23. Apr. 2007
    Geliefert am 05. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies due or to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefits of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreements.
    Berechtigte Personen
    • Alliance & Leicester Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge and assignment of sub-agreements
    Erstellt am 07. Juli 2005
    Geliefert am 09. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The sub-agreements - date:07/05/2003 hire agreement palmers LTD, equipment:daf vehicle ref no:DX03LUY. Date:31/07/2003 hire agreement palmers LTD, equipment:daf vehicle ref: DN03SJU. Date:05/08/2003 hire agreement palmers LTD, equipment:daf vehicle ref: DN03SJV for details of further equipment charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 09. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Certificate of assignment
    Erstellt am 15. Apr. 2005
    Geliefert am 20. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies due and to become due to the company under sub-hire agreement number fka 003 made between the company and mcnicholas PLC, described in the schedule attached to form 395, and the benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assigned agreement;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Certificate of assignment
    Erstellt am 11. März 2005
    Geliefert am 19. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreement number BAR021/163 as specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assignment agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 10. Feb. 2005
    Geliefert am 28. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (A) the sub hire agreements and the full benefit and advantage thereof (b) all monies now or hereafter payable under the sub hire agreements (c) the benefit of all guarantees indemnities and other securities taken by the company in connection with the sub hire agreement(s) (d) the benefit of all insurance effected in respect of the goods pursuant to the terms of the sub hire agreement(s).
    Berechtigte Personen
    • Scania Finance Great Britain Limited
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 31. Jan. 2005
    Geliefert am 02. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1) the sub hire agreements and the full benefit and advantage thereof, 2) all monies now or hereafter payable under the sub hire agreements, 3) the benefit of all guarantees indemnities and other securities and other securities taken by the company in connection with the sub hire agreements, 4) the benefit of all insurances effected in respect of the goods pursuant to the terms of the sub hire agreements,.
    Berechtigte Personen
    • Scania Finance Great Britain Limited
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 24. Jan. 2005
    Geliefert am 27. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (A)the sub hire agreements and the full benefit and advantage thereof (b)all monies now or hereafter payable under the sub hire agreements (c)the benefit of all guarantees indemnities and other securities taken by the company in connection with the sub hire agreement(s) (d)the benefit of all insurance effected in respect of the goods pursuant to the terms of the sub hire agreement(s).
    Berechtigte Personen
    • Scania Finance Great Britain Limited
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Certificate of assignment made pursuant to a master assignment dated 15 april 2003 and
    Erstellt am 29. Juli 2004
    Geliefert am 04. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies due under the sub-hire agreements specified in the schedule to the assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Certificate of assignment made pursuant to a master assignment dated 28 april 2003
    Erstellt am 08. Juni 2004
    Geliefert am 11. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies now and hereafter to become due to the company under the sub-hire agreement number 01 070 04601 075 in the name of mcnicholas, and the benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities in connection with the assigned agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental schedule
    Erstellt am 20. Mai 2004
    Geliefert am 21. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the companys rights title and interest in sub-hire agreements and related contracts at any time entered into in respect of the goods and in any other contracts at any time entered in to in respect of such goods all the companys rights title and interest in the sub-hire agreements from time to time briefly described in the supplementary schedules executed pursuant to the deed and all related contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transaktionen
    • 21. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Floating charge
    Erstellt am 09. März 2004
    Geliefert am 11. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All sub-hiring agreements entered into by the company relating to goods owned by vwfs but let by vwfs to the company under hire-purchase agreements or lease purchase agreements or contract hire agreements or any other hire agreement.
    Berechtigte Personen
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transaktionen
    • 11. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge
    Erstellt am 05. Jan. 2004
    Geliefert am 08. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (A)the sub hire agreements and the full benefit and advantage thereof (b)all monies now or hereafter payable under the sub hire agreements (c)the benefit of all guarantees indemnities and other securities taken by the company in connection with the sub hire agreement(s) (d)the benefit of all insurance effected in respect of the goods pursuant to the terms of the sub hire agreement(s).
    Berechtigte Personen
    • Scania Finance Great Britain Limited
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0