INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED

INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameINNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02384773
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED?

    • Sonstiges Druckwesen (18129) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Lower Ground Floor, Park House, 16/18
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    K2 DIRECT LIMITED26. Feb. 200926. Feb. 2009
    K2 GROUP LIMITED16. Okt. 200316. Okt. 2003
    K2 DIRECT LIMITED09. Aug. 200209. Aug. 2002
    K2 DIRECT MAIL LIMITED23. Mai 199523. Mai 1995
    PICKFIELD PRINTING COMPANY LIMITED09. Mai 199009. Mai 1990
    K2 GRAPHICS LIMITED01. März 199001. März 1990
    CRAMWARD LIMITED16. Mai 198916. Mai 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. Juni 2024
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. März 2025
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2023

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis20. Apr. 2025
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung04. Mai 2025
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis20. Apr. 2024
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Beendigung der Bestellung von Richard Joseph Cahill als Sekretär am 28. Juni 2024

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Sarah Crean als Sekretär am 28. Juni 2024

    2 SeitenAP03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Laurent Thierry Salmon am 15. Okt. 2023

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2023

    14 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2022

    19 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Apr. 2022 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2021

    23 SeitenAA

    Cessation of Dsicmm Group Limited as a person with significant control on 22. Dez. 2021

    1 SeitenPSC07

    Notification of Paragon Customer Communications Limited as a person with significant control on 22. Dez. 2021

    2 SeitenPSC02

    Kapitalaufstellung am 15. Dez. 2021

    • Kapital: GBP 1.00
    5 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenSH20

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Änderung der Aktienrechte oder der Bezeichnung

    RES12
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Einzelheiten zur Änderung der an Aktien geknüpften Rechte

    2 SeitenSH10

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    34 SeitenMA

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Beschluss zur Kapitalisierung oder Ausgabe von Gratisaktien

    Re-bonus issue 81000 new ord shares of £1 each 12/10/2021
    RES14
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 12. Okt. 2021

    • Kapital: GBP 486,179
    5 SeitenSH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Patrick James Crean am 06. Apr. 2021

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2020

    22 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2019

    23 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Jeremy Edward Charles Walters am 12. Nov. 2019

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CREAN, Sarah
    Sandyford Road
    Dublin 16
    The Grenadier Suite, Imi
    Ireland
    Sekretär
    Sandyford Road
    Dublin 16
    The Grenadier Suite, Imi
    Ireland
    325321730001
    CREAN, Patrick James
    Irish Management Institute
    Sandyford Road
    Dublin D16 X8c3
    The Paragon Suite
    Ireland
    Geschäftsführer
    Irish Management Institute
    Sandyford Road
    Dublin D16 X8c3
    The Paragon Suite
    Ireland
    United KingdomIrishCompany Director54812330034
    SALMON, Laurent Thierry
    Irish Management Institute
    Sandyford Road
    Dublin D16 X8c3
    The Paragon Suite
    Ireland
    Geschäftsführer
    Irish Management Institute
    Sandyford Road
    Dublin D16 X8c3
    The Paragon Suite
    Ireland
    LuxembourgFrenchFinance Director152744200002
    WALTERS, Jeremy Edward Charles
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    Lower Ground Floor, Park House, 16/18
    England
    Geschäftsführer
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    Lower Ground Floor, Park House, 16/18
    England
    EnglandBritishCompany Director234484880013
    CAHILL, Richard Joseph
    Irish Management Institute
    Sandyford Road
    Dublin D16 X8c3
    The Paragon Suite
    Ireland
    Sekretär
    Irish Management Institute
    Sandyford Road
    Dublin D16 X8c3
    The Paragon Suite
    Ireland
    230760630001
    COLEMAN, Kevan
    Bellacasa Prestbury Road
    SK9 2LJ Wilmslow
    Cheshire
    Sekretär
    Bellacasa Prestbury Road
    SK9 2LJ Wilmslow
    Cheshire
    British43009960001
    WHELDRICK, Rodney
    33 Hall Close
    Meltham
    HD9 4EL Huddersfield
    West Yorkshire
    Sekretär
    33 Hall Close
    Meltham
    HD9 4EL Huddersfield
    West Yorkshire
    British30284930003
    COLEMAN, Claire Louise
    Bellacasa
    Prestbury Road
    SK9 2LJ Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Bellacasa
    Prestbury Road
    SK9 2LJ Wilmslow
    Cheshire
    BritishCommercial Director86089940001
    COLEMAN, Kevan
    Bellacasa Prestbury Road
    SK9 2LJ Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Bellacasa Prestbury Road
    SK9 2LJ Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishChairman43009960001
    DIXON, Nicolas William
    Forster Road
    Holly Mount
    GU2 9AE Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Forster Road
    Holly Mount
    GU2 9AE Guildford
    3
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishC.E.O.24161370007
    FELSTEAD, Mark Thomas
    Worthy Vale Manor
    PL32 9TT Camelford
    Cornwall
    Geschäftsführer
    Worthy Vale Manor
    PL32 9TT Camelford
    Cornwall
    EnglandBritishDirector100187010001
    GIDLEY, Vincent
    43 Old Kiln Lane
    Grotton
    OL4 5RZ Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    43 Old Kiln Lane
    Grotton
    OL4 5RZ Oldham
    Lancashire
    United KingdomBritishProduction Director74274710001
    GIVENS, Gregg
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    Lower Ground Floor, Park House, 16/18
    England
    Geschäftsführer
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    Lower Ground Floor, Park House, 16/18
    England
    UsaAmericanAccountant165815500001
    HUSBAND, Richard
    1 Alderwood Fold
    Lees
    OL4 5RW Oldham
    Geschäftsführer
    1 Alderwood Fold
    Lees
    OL4 5RW Oldham
    BritishSales Director33981110004
    ILLINGWORTH, Kevin Newton
    Gretna 2 Daylesford Road
    SK8 1LF Cheadle
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Gretna 2 Daylesford Road
    SK8 1LF Cheadle
    Cheshire
    EnglandBritishManaging Director2381010003
    LIOW, Susan Phaik Suan
    Cambridge Road
    UB8 1BG Uxbridge
    2
    Middlesex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Cambridge Road
    UB8 1BG Uxbridge
    2
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomMalaysianChief Financial Officer113186220001
    MACLEAN, Alastair Duncan
    Mill Pond Cottage
    3 Mill Pond Road Dunton Green
    TN13 2UZ Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Mill Pond Cottage
    3 Mill Pond Road Dunton Green
    TN13 2UZ Sevenoaks
    Kent
    BritishDirector122964670001
    MILLION, David
    14 Stamford Drive
    Whittle Le Woods
    PR6 7HP Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    14 Stamford Drive
    Whittle Le Woods
    PR6 7HP Chorley
    Lancashire
    BritishCompany Director55410980001
    MONKS, David Keith
    Tudor Rose 11 Hareswood Close
    CW7 2TP Winsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Tudor Rose 11 Hareswood Close
    CW7 2TP Winsford
    Cheshire
    BritishCompany Director73697660002
    NOBLE, Yolanda Jane
    Goat Hill Farm Well Hill Lane
    Chelsfield
    BR6 7JQ Orpington
    Kent
    Geschäftsführer
    Goat Hill Farm Well Hill Lane
    Chelsfield
    BR6 7JQ Orpington
    Kent
    United KingdomBritishDirector51018390001
    SNOW, Lee Wade
    Bridge End Barn
    Chapel Lane Acton Bridge
    CW8 3QS Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Bridge End Barn
    Chapel Lane Acton Bridge
    CW8 3QS Northwich
    Cheshire
    BritishIt Director59769560003
    TEER, Phil
    13 Wrigley Fold Silverbirch View
    Middleton
    M24 5XA Manchester
    Geschäftsführer
    13 Wrigley Fold Silverbirch View
    Middleton
    M24 5XA Manchester
    BritishOperations Director52249520001
    WATSON, Colin Graham
    Oak House Bott House Lane
    BB8 8LN Colne
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Oak House Bott House Lane
    BB8 8LN Colne
    Lancashire
    BritishFinancial Director52249390001
    WHELDRICK, Rodney
    33 Hall Close
    Meltham
    HD9 4EL Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    33 Hall Close
    Meltham
    HD9 4EL Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishFinance Director30284930003
    WRIGHTSON, Martin Francis
    2 Copper Beech Court
    Main Road, Woolsington
    NE13 8BL Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    2 Copper Beech Court
    Main Road, Woolsington
    NE13 8BL Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritishGroup Sales & Marketing Direct110903630001
    YOUNG, Andrew
    Springfield Farm
    Uley
    GL11 5AN Dursley
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Springfield Farm
    Uley
    GL11 5AN Dursley
    Gloucestershire
    EnglandBritishNone33320050003

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    Lower Ground Floor, Park House, 16/18
    England
    22. Dez. 2021
    Finsbury Circus
    EC2M 7EB London
    Lower Ground Floor, Park House, 16/18
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageEngland & Wales
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer07262428
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Dsicmm Group Limited
    St. Marks Hill
    KT6 4QD Surbiton
    Dst House,
    England
    03. Jan. 2017
    St. Marks Hill
    KT6 4QD Surbiton
    Dst House,
    England
    Ja
    RechtsformLimited Company
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    An omnibus letter of set-off
    Erstellt am 21. Mai 2009
    Geliefert am 22. Mai 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    All assets debenture
    Erstellt am 24. Dez. 2008
    Geliefert am 02. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 02. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 24. Dez. 2008
    Geliefert am 02. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 2009
    • 03. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 24. Dez. 2008
    Geliefert am 02. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts are in the sole name of any of the companies or in the joint names of two or more companies, including any accounts in the bank’s name with any designation which includes the name of the companies or any one or more of the companies.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Loan agreement
    Erstellt am 31. Dez. 2006
    Geliefert am 11. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £615,000.00 due or to become due from the company to
    Kurze Angaben
    Mitsubishi diamond 3000LS 5+c+e/d printing press serial no 3149,. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cit Group (UK) Limited
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 06. Sept. 2006
    Geliefert am 08. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Cnc two end unreel & tension section type hd-web paper turn & feed s/n 402 185, 5 two colour double stack units and jet webb in-line glueing section for further details of other chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 08. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Jan. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Sept. 2006
    Geliefert am 08. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 08. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 19. Mai 1999
    Geliefert am 20. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The goods one heidelberg speedmaster 102 spp press serial number 528656.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 25. Okt. 1996
    Geliefert am 29. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge any debt purchased by the chargee pursuant to the agreement which fails to vest absolutely together with the related rights by way of floating charge all the undertaking and all the property rights and assets of the company including the company's stock in trade and its uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 29. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Jan. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Okt. 1996
    Geliefert am 10. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Jan. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Sept. 1992
    Geliefert am 07. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture containing fixed & floating charge
    Erstellt am 31. Aug. 1989
    Geliefert am 06. Sept. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Sept. 1989Registrierung einer Belastung
    • 18. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Aug. 1989
    Geliefert am 04. Sept. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Stock in trade work in progress pre-payments. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC
    Transaktionen
    • 04. Sept. 1989Registrierung einer Belastung
    • 18. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0