INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02384773 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED?
- Sonstiges Druckwesen (18129) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Lower Ground Floor, Park House, 16/18 Finsbury Circus EC2M 7EB London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
K2 DIRECT LIMITED | 26. Feb. 2009 | 26. Feb. 2009 |
K2 GROUP LIMITED | 16. Okt. 2003 | 16. Okt. 2003 |
K2 DIRECT LIMITED | 09. Aug. 2002 | 09. Aug. 2002 |
K2 DIRECT MAIL LIMITED | 23. Mai 1995 | 23. Mai 1995 |
PICKFIELD PRINTING COMPANY LIMITED | 09. Mai 1990 | 09. Mai 1990 |
K2 GRAPHICS LIMITED | 01. März 1990 | 01. März 1990 |
CRAMWARD LIMITED | 16. Mai 1989 | 16. Mai 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Juni 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. März 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 20. Apr. 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 04. Mai 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 20. Apr. 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beendigung der Bestellung von Richard Joseph Cahill als Sekretär am 28. Juni 2024 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Ernennung von Sarah Crean als Sekretär am 28. Juni 2024 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Laurent Thierry Salmon am 15. Okt. 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2023 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2022 | 19 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Apr. 2022 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2021 | 23 Seiten | AA | ||||||||||||||
Cessation of Dsicmm Group Limited as a person with significant control on 22. Dez. 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||||||
Notification of Paragon Customer Communications Limited as a person with significant control on 22. Dez. 2021 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 15. Dez. 2021
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Einzelheiten zur Änderung der an Aktien geknüpften Rechte | 2 Seiten | SH10 | ||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 34 Seiten | MA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 12. Okt. 2021
| 5 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Patrick James Crean am 06. Apr. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2020 | 22 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 23 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jeremy Edward Charles Walters am 12. Nov. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREAN, Sarah | Sekretär | Sandyford Road Dublin 16 The Grenadier Suite, Imi Ireland | 325321730001 | |||||||
CREAN, Patrick James | Geschäftsführer | Irish Management Institute Sandyford Road Dublin D16 X8c3 The Paragon Suite Ireland | United Kingdom | Irish | Company Director | 54812330034 | ||||
SALMON, Laurent Thierry | Geschäftsführer | Irish Management Institute Sandyford Road Dublin D16 X8c3 The Paragon Suite Ireland | Luxembourg | French | Finance Director | 152744200002 | ||||
WALTERS, Jeremy Edward Charles | Geschäftsführer | Finsbury Circus EC2M 7EB London Lower Ground Floor, Park House, 16/18 England | England | British | Company Director | 234484880013 | ||||
CAHILL, Richard Joseph | Sekretär | Irish Management Institute Sandyford Road Dublin D16 X8c3 The Paragon Suite Ireland | 230760630001 | |||||||
COLEMAN, Kevan | Sekretär | Bellacasa Prestbury Road SK9 2LJ Wilmslow Cheshire | British | 43009960001 | ||||||
WHELDRICK, Rodney | Sekretär | 33 Hall Close Meltham HD9 4EL Huddersfield West Yorkshire | British | 30284930003 | ||||||
COLEMAN, Claire Louise | Geschäftsführer | Bellacasa Prestbury Road SK9 2LJ Wilmslow Cheshire | British | Commercial Director | 86089940001 | |||||
COLEMAN, Kevan | Geschäftsführer | Bellacasa Prestbury Road SK9 2LJ Wilmslow Cheshire | England | British | Chairman | 43009960001 | ||||
DIXON, Nicolas William | Geschäftsführer | Forster Road Holly Mount GU2 9AE Guildford 3 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | C.E.O. | 24161370007 | ||||
FELSTEAD, Mark Thomas | Geschäftsführer | Worthy Vale Manor PL32 9TT Camelford Cornwall | England | British | Director | 100187010001 | ||||
GIDLEY, Vincent | Geschäftsführer | 43 Old Kiln Lane Grotton OL4 5RZ Oldham Lancashire | United Kingdom | British | Production Director | 74274710001 | ||||
GIVENS, Gregg | Geschäftsführer | Finsbury Circus EC2M 7EB London Lower Ground Floor, Park House, 16/18 England | Usa | American | Accountant | 165815500001 | ||||
HUSBAND, Richard | Geschäftsführer | 1 Alderwood Fold Lees OL4 5RW Oldham | British | Sales Director | 33981110004 | |||||
ILLINGWORTH, Kevin Newton | Geschäftsführer | Gretna 2 Daylesford Road SK8 1LF Cheadle Cheshire | England | British | Managing Director | 2381010003 | ||||
LIOW, Susan Phaik Suan | Geschäftsführer | Cambridge Road UB8 1BG Uxbridge 2 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | Malaysian | Chief Financial Officer | 113186220001 | ||||
MACLEAN, Alastair Duncan | Geschäftsführer | Mill Pond Cottage 3 Mill Pond Road Dunton Green TN13 2UZ Sevenoaks Kent | British | Director | 122964670001 | |||||
MILLION, David | Geschäftsführer | 14 Stamford Drive Whittle Le Woods PR6 7HP Chorley Lancashire | British | Company Director | 55410980001 | |||||
MONKS, David Keith | Geschäftsführer | Tudor Rose 11 Hareswood Close CW7 2TP Winsford Cheshire | British | Company Director | 73697660002 | |||||
NOBLE, Yolanda Jane | Geschäftsführer | Goat Hill Farm Well Hill Lane Chelsfield BR6 7JQ Orpington Kent | United Kingdom | British | Director | 51018390001 | ||||
SNOW, Lee Wade | Geschäftsführer | Bridge End Barn Chapel Lane Acton Bridge CW8 3QS Northwich Cheshire | British | It Director | 59769560003 | |||||
TEER, Phil | Geschäftsführer | 13 Wrigley Fold Silverbirch View Middleton M24 5XA Manchester | British | Operations Director | 52249520001 | |||||
WATSON, Colin Graham | Geschäftsführer | Oak House Bott House Lane BB8 8LN Colne Lancashire | British | Financial Director | 52249390001 | |||||
WHELDRICK, Rodney | Geschäftsführer | 33 Hall Close Meltham HD9 4EL Huddersfield West Yorkshire | British | Finance Director | 30284930003 | |||||
WRIGHTSON, Martin Francis | Geschäftsführer | 2 Copper Beech Court Main Road, Woolsington NE13 8BL Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British | Group Sales & Marketing Direct | 110903630001 | ||||
YOUNG, Andrew | Geschäftsführer | Springfield Farm Uley GL11 5AN Dursley Gloucestershire | England | British | None | 33320050003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragon Customer Communications Limited | 22. Dez. 2021 | Finsbury Circus EC2M 7EB London Lower Ground Floor, Park House, 16/18 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Dsicmm Group Limited | 03. Jan. 2017 | St. Marks Hill KT6 4QD Surbiton Dst House, England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat INNOVATIVE OUTPUT SOLUTIONS (MANCHESTER) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
An omnibus letter of set-off | Erstellt am 21. Mai 2009 Geliefert am 22. Mai 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
All assets debenture | Erstellt am 24. Dez. 2008 Geliefert am 02. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 24. Dez. 2008 Geliefert am 02. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 24. Dez. 2008 Geliefert am 02. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts are in the sole name of any of the companies or in the joint names of two or more companies, including any accounts in the bank’s name with any designation which includes the name of the companies or any one or more of the companies. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Loan agreement | Erstellt am 31. Dez. 2006 Geliefert am 11. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £615,000.00 due or to become due from the company to | |
Kurze Angaben Mitsubishi diamond 3000LS 5+c+e/d printing press serial no 3149,. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 06. Sept. 2006 Geliefert am 08. Sept. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Cnc two end unreel & tension section type hd-web paper turn & feed s/n 402 185, 5 two colour double stack units and jet webb in-line glueing section for further details of other chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 06. Sept. 2006 Geliefert am 08. Sept. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 19. Mai 1999 Geliefert am 20. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The goods one heidelberg speedmaster 102 spp press serial number 528656. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 25. Okt. 1996 Geliefert am 29. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of fixed equitable charge any debt purchased by the chargee pursuant to the agreement which fails to vest absolutely together with the related rights by way of floating charge all the undertaking and all the property rights and assets of the company including the company's stock in trade and its uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Okt. 1996 Geliefert am 10. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 23. Sept. 1992 Geliefert am 07. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture containing fixed & floating charge | Erstellt am 31. Aug. 1989 Geliefert am 06. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. Aug. 1989 Geliefert am 04. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Stock in trade work in progress pre-payments. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0