TERMINUS 4 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTERMINUS 4 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02384870
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TERMINUS 4 LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich TERMINUS 4 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Apex Business Centre
    Boscombe Road
    LU5 4SB Dunstable
    Bedfordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TERMINUS 4 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    POLESTAR PACKAGING LIMITED06. Nov. 199806. Nov. 1998
    BPC PACKAGING LTD18. Jan. 199418. Jan. 1994
    BPCC PACKAGING LTD.07. Nov. 198907. Nov. 1989
    TREEWIN LIMITED16. Mai 198916. Mai 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TERMINUS 4 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für TERMINUS 4 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beschlüsse

    Resolutions
    5 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 09. Mai 2011

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Okt. 2010

    Kapitalaufstellung am 20. Okt. 2010

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Alan Goodwin am 31. Juli 2009

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Alan Goodwin am 31. Juli 2009

    2 SeitenCH01

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008

    10 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007

    11 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006

    11 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    4 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005

    13 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    Wer sind die Geschäftsführer von TERMINUS 4 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GOODWIN, Alan
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    Sekretär
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    BritishCompany Secretary98921850001
    GOODWIN, Alan James
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    Geschäftsführer
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    United KingdomBritishCompany Secretary98921850003
    HEARN, Catherine Ann
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishGroup Hr Director83713930001
    HIBBERT, Barry Alan
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    Geschäftsführer
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer68122470005
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    Geschäftsführer
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    EnglandBritishFinance Director138015860001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Sekretär
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British987230001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant987230001
    BRINDLE, William Alan
    18 Arbor Meadows
    Winnersh
    RG11 5ED Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    18 Arbor Meadows
    Winnersh
    RG11 5ED Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritishDirector152374680001
    BROWN, Frederick James
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishChief Executive Officer16105360002
    DUNKLEY, Rodney Patrick
    20 Aviemore Gardens
    NN4 9XJ Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    20 Aviemore Gardens
    NN4 9XJ Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishFinancial Director70777180001
    GARWOOD, Geoffrey William
    Woollards
    Church Green Broomfield
    CM1 7BD Chelmsford
    Essex
    Geschäftsführer
    Woollards
    Church Green Broomfield
    CM1 7BD Chelmsford
    Essex
    EnglandBritishPersonnel Director121479850001
    GREEN, Lewis Holmer
    The Knoll
    Skiplake
    RG9 3JT Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Knoll
    Skiplake
    RG9 3JT Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishSales Director16174580001
    HILL, Gavin Mcdonald
    The Oaks West Field Close
    RG26 3YG Tadley
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Oaks West Field Close
    RG26 3YG Tadley
    Hampshire
    BritishFinance Director59743530001
    HOLLORAN, Peter John
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishGroup Chief Executive61418710001
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    Geschäftsführer
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    BritishGroup Finance Director83714120001
    KENT, Alan Roy
    Norbreck Altwood Bailey
    SL6 4PQ Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Norbreck Altwood Bailey
    SL6 4PQ Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritishDirector16174600001
    ROBERTSON, Malcolm Murray
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director39155140002
    RUDSTON, Anthony
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    EnglandBritishGroup Chief Executive44908110001
    STEWART, Terence David
    Pond Meadow 17a Lower Road
    Stoke Mandeville
    HP21 5XA Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Pond Meadow 17a Lower Road
    Stoke Mandeville
    HP21 5XA Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishPersonnel Director15331120001
    SZAWLOWSKI, Bruce Sulima
    31 Hedingham Mews
    All Saints Avenue
    SL6 6ET Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    31 Hedingham Mews
    All Saints Avenue
    SL6 6ET Maidenhead
    Berkshire
    BritishManaging Director62373580002
    TIMMINS, Richard Keith
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    Geschäftsführer
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    United KingdomBritishDirector127238050003
    WALMSLEY, Thomas Michael
    The Sycamores Church Lane
    Bramshall
    ST14 5BQ Uttoxeter
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    The Sycamores Church Lane
    Bramshall
    ST14 5BQ Uttoxeter
    Staffordshire
    BritishOperations Director1807670001

    Hat TERMINUS 4 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 19TH june 1998
    Erstellt am 27. Sept. 2006
    Geliefert am 30. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998
    Erstellt am 28. Okt. 2004
    Geliefert am 10. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) as Security Trusteefor Itself and the Other Secured Parties or Such Other Person as May from Time to Time Be Appointed Security Trustee
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Restated amendment of and accession to the composite guarantee & debenture dated 19/06/98
    Erstellt am 28. Okt. 2004
    Geliefert am 10. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) or Such Otherperson as May from Time to Time Be Appointed Security Agent and Trustee
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    A composite guarantee and debenture between polestar,the polestar corporation PLC,certain subsidiaries of polestar and J.P.morgan europe limited
    Erstellt am 28. Jan. 2002
    Geliefert am 15. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys and liabilities due or to become due from the company to the secured parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including (I) unit B5 blenheim industrial park estate,bury st.edmunds,suffolk; (ii) unit 14 luton stadium estate,craddock rd,luton,bedfordshire; bd 77546; (iii) wigman rd,aspley,nottingham; NT78782 and NT180765; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • J.P.Morgan Europe Limited,as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    A composite guarantee and debenture between the chargor, the polestar corporation PLC, certain subsidiaries of the chargor and chase manhattan international limited
    Erstellt am 26. Okt. 2001
    Geliefert am 14. Nov. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited (As Security Trustee for Itself and Investcorp Fundinglimited)
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 19. Juni 1998
    Geliefert am 10. Juli 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys and discharging of all liabilities now or hereafter due, owing or incurred by the company and/or all or any of the other companies named therein (the "original UK charging subsidiaries") to the chargee in its capacity as security trustee for the banks, the agent, the security trustee, the arranger, the ancillary banks and the hedge counterparties (all as defined therein) or any of them including, without limitation, all moneys, liabilities due, owing or incurred under or pursuant to the facilities agreement, the debenture, the ancillary documents and/or any of the other finance documents
    Kurze Angaben
    F/H 5 culley way maidenhead t/n BK111256, f/h 71 portlock road maidenhead t/n BK30684, 2 fielding road maidenhead t/n BK130387, for details of the further properties in england and the l/h property in scotland charged please refer to form M395, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery, see ch microfiche for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited
    Transaktionen
    • 10. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 28. Dez. 1995
    Geliefert am 08. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chemical Investment Bank Limitedas Security Agent (As Defined Therein)
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 28. Dez. 1995
    Geliefert am 05. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the british printing company LTD to the chargee under the terms of the restated facilities (as defined therein) and this deed
    Kurze Angaben
    Charged under the security documents (as defined) to which the company is a party. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank Therein)as Agent and Trustee for the Lenders (As Defined
    Transaktionen
    • 05. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 29. Dez. 1989
    Geliefert am 17. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from bucsmere limited now k/a bpcc LTD tothe chargee under the terms of a loan agreement dated 21ST december 1988 this charge.
    Kurze Angaben
    (See form 395. ref M259 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlanddraft Banks).(As Agent and Trustee for the Banks and the Over
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    • 22. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 29. Dez. 1989
    Geliefert am 17. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from bucksmere limited now k/a bpcc LTD to the chargee under terms of a loan agreement dated 2ST december 1988 and this charge.
    Kurze Angaben
    (See form 395. ref M238 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank(As Agent and Trustee for the Mezzanire Lenders)
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 10. Feb. 1989
    Geliefert am 24. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from bpcc LTD to the chargee under a loan agreement dated 21ST dec 1988 secured on property acquired by bpcc packaging LTD on the 5TH january 1990.
    Kurze Angaben
    (See doc M400 - ref M186C for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Mezzanine Lenders
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 10. Feb. 1989
    Erworben am 05. Jan. 1990
    Geliefert am 24. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from bpcc LTD and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under a loan agreement dated 21-12-88 and the facilities agreeement secured on property acquired by bpcc packaging LTD on the 5TH january 1990.
    Kurze Angaben
    (See doc M400 - ref 187C for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Banks of Scotlandraft Bank as Defined.as Agent and Trustee for the Banks and the Overd
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    • 08. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0