TERMINUS 36 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTERMINUS 36 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02385062
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TERMINUS 36 LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich TERMINUS 36 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Apex Business Centre
    Boscombe Road
    LU5 4SB Dunstable
    Bedfordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TERMINUS 36 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    POLESTAR NEWS & CONSUMER LIMITED03. Juli 200003. Juli 2000
    POLESTAR POWERPRINT LIMITED22. Juni 199922. Juni 1999
    POLESTAR GRAVURE LIMITED06. Nov. 199806. Nov. 1998
    BPC CATALOGUES LTD18. Jan. 199418. Jan. 1994
    BPCC CATALOGUES LTD08. Nov. 198908. Nov. 1989
    WIDESHINE LIMITED16. Mai 198916. Mai 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TERMINUS 36 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für TERMINUS 36 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beschlüsse

    Resolutions
    5 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 09. Mai 2011

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Okt. 2010

    Kapitalaufstellung am 20. Okt. 2010

    • Kapital: GBP 50,001,002
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Alan Goodwin am 31. Juli 2009

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Alan Goodwin am 31. Juli 2009

    2 SeitenCH01

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008

    12 SeitenAA

    legacy

    29 Seiten395

    legacy

    28 Seiten395

    legacy

    4 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von TERMINUS 36 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GOODWIN, Alan
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    Sekretär
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    British98921850001
    GOODWIN, Alan James
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    Geschäftsführer
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    United KingdomBritish98921850003
    HEARN, Catherine Ann
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish83713930001
    HIBBERT, Barry Alan
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    Geschäftsführer
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    United KingdomBritish68122470005
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    Geschäftsführer
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    EnglandBritish138015860001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Sekretär
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British987230001
    ADLEM, Philip
    4 Upton Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HX Cheadle
    Cheshire
    Geschäftsführer
    4 Upton Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7HX Cheadle
    Cheshire
    British70694890001
    ALDREN, Stephen
    59 Seward Road
    WR11 7HQ Badsey
    Evesham
    Geschäftsführer
    59 Seward Road
    WR11 7HQ Badsey
    Evesham
    United KingdomBritish105696350001
    BRAMLEY, Christopher John
    6 Park Farm Court
    Longwell Green
    BS30 7EE Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    6 Park Farm Court
    Longwell Green
    BS30 7EE Bristol
    Avon
    British67411960001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British987230001
    BROWN, Frederick James
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British16105360002
    CLARK, Stephen John
    Beaumont House Evesham Road
    Salford Priors
    WR11 5UU Evesham
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Beaumont House Evesham Road
    Salford Priors
    WR11 5UU Evesham
    Worcestershire
    British49702240002
    GARNHAM, Peter John Jennings
    121 Selby Road
    NG2 7BB West Bridgford
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    121 Selby Road
    NG2 7BB West Bridgford
    Nottinghamshire
    British73519870001
    GWILLIAM, Paul Raymond
    The Hazel The Briars
    Hawkridge
    BA14 6AD Yarnbrook
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    The Hazel The Briars
    Hawkridge
    BA14 6AD Yarnbrook
    Wiltshire
    British63643220001
    HOLLORAN, Peter John
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish61418710001
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    Geschäftsführer
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    British83714120001
    MEDLER, Christopher Robert
    Harvest House
    Salters Meadow Tolleshunt Darcy
    CM9 8JE Maldon
    Essex
    Geschäftsführer
    Harvest House
    Salters Meadow Tolleshunt Darcy
    CM9 8JE Maldon
    Essex
    British32618460001
    MILES, Steven
    13 Simon De Montfort Drive
    WR11 4NR Evesham
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    13 Simon De Montfort Drive
    WR11 4NR Evesham
    Worcestershire
    British70694940001
    PAVEY, Ian Malcolm
    The Old Post Office
    Ardens Grafton
    B49 6DS Alcester
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Old Post Office
    Ardens Grafton
    B49 6DS Alcester
    Warwickshire
    British73168740003
    PAVLOSKY, Christopher John
    HP17 9LT Askett
    Askett House
    Bucks
    Geschäftsführer
    HP17 9LT Askett
    Askett House
    Bucks
    United KingdomBritish151956700001
    PIGOTT, Neil
    179 Harrow Road
    Wollaton Park
    NG8 1FL Nottingham
    Geschäftsführer
    179 Harrow Road
    Wollaton Park
    NG8 1FL Nottingham
    British37801830001
    PURCELL, John Carlsson
    Wharfedale 3 Beaufort Close
    HP21 9BB Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Wharfedale 3 Beaufort Close
    HP21 9BB Aylesbury
    Buckinghamshire
    British70644890001
    ROBERTSON, Malcolm Murray
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritish39155140002
    RUDSTON, Anthony
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    EnglandBritish44908110001
    STATON, David Montague
    23 Southfield Drive
    Hazlemere
    HP15 6HB High Wycombe
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    23 Southfield Drive
    Hazlemere
    HP15 6HB High Wycombe
    Buckinghamshire
    British15853080001
    SWATMAN, Kenneth John
    3 Trevelyan Way
    HP4 1JG Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    3 Trevelyan Way
    HP4 1JG Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish73145410001
    TIMMINS, Richard Keith
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    Geschäftsführer
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    United KingdomBritish127238050003

    Hat TERMINUS 36 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 26. Nov. 2008
    Geliefert am 08. Dez. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of properties charged please refer to the form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited as Agent and Trustee for the Benefit of the Lenders
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Amendment agreement relating to the security agreement dated 13 december 2006 and
    Erstellt am 25. Nov. 2008
    Geliefert am 08. Dez. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For properties charged please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited as Agent and Trustee for the Benefit of the Lenders
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security agreement
    Erstellt am 13. Dez. 2006
    Geliefert am 22. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P.Morgan Europe Limited for Itself and as Agent and Trustee for Each of the Secured Creditors
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 19TH june 1998
    Erstellt am 27. Sept. 2006
    Geliefert am 30. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998
    Erstellt am 28. Okt. 2004
    Geliefert am 10. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) as Security Trusteefor Itself and the Other Secured Parties or Such Other Person as May from Time to Time Be Appointed Security Trustee
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Restated amendment of and accession to the composite guarantee & debenture dated 19/06/98
    Erstellt am 28. Okt. 2004
    Geliefert am 10. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) or Such Otherperson as May from Time to Time Be Appointed Security Agent and Trustee
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A composite guarantee and debenture between polestar,the polestar corporation PLC,certain subsidiaries of polestar and J.P.morgan europe limited
    Erstellt am 28. Jan. 2002
    Geliefert am 15. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and liabilities due or to become due from the chargor to the secured parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including (I) l/hold over unit B5 blenheim industrial park estate,bury st edmunds,suffolk; (ii) l/hold unit 14 luton stadium estate,craddock rd,luton,bedfordshire; BD77546; (iii) l/hold over wigman rd,aspley,nottingham; t/nos NT78782 and NT180765; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • J.P.Morgan Europe Limited,as Security Trstee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A composite guarantee and debenture between the chargor, the polestar corporation PLC, certain subsidiaries of the chargor and chase manhattan international limited
    Erstellt am 26. Okt. 2001
    Geliefert am 14. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited (As Security Trustee for Itself and Investcorp Fundinglimited)
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 19. Juni 1998
    Geliefert am 10. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and discharging of all liabilities now or hereafter due, owing or incurred by the company and/or all or any of the other companies named therein (the "original UK charging subsidiaries") to the chargee in its capacity as security trustee for the banks, the agent, the security trustee, the arranger, the ancillary banks and the hedge counterparties (all as defined therein) or any of them including, without limitation, all moneys, liabilities due, owing or incurred under or pursuant to the facilities agreement, the debenture, the ancillary documents and/or any of the other finance documents
    Kurze Angaben
    F/H 5 culley way maidenhead t/n BK111256, f/h 71 portlock road maidenhead t/n BK30684, 2 fielding road maidenhead t/n BK130387, for details of the further properties in england and the l/h property in scotland charged please refer to form M395, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery, see ch microfiche for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited
    Transaktionen
    • 10. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 28. Dez. 1995
    Geliefert am 08. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chemical Investment Bank Limitedas Security Agent (As Defined Therein)
    Transaktionen
    • 08. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 28. Dez. 1995
    Geliefert am 05. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the british printing company LTD to the chargee under the terms of the restated facilities (as therein defined) and this deed
    Kurze Angaben
    Charged under the security documents (as defined) to which the company is a party. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Lenders (As Defined Therein)
    Transaktionen
    • 05. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 29. Dez. 1989
    Geliefert am 17. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from bucksmere limited now k/a bpcc LTD.to the chargee under the terms of a loan agreement dated 21 december 1988 and this charge.
    Kurze Angaben
    (For full details - see form 395- ref M241). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bank(As Agent and Trustee for the Mezzanine Lenders)
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 29. Dez. 1989
    Geliefert am 17. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from bucksmere limited now k/a bpcc LTD.to the chargee under the terms of a loan agreement dated 21 december 1988 and this charge.
    Kurze Angaben
    (For full details - see form 395. ref M262). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.(As Agent and Trustee for the Banks and the Overdraft Bank)
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    • 22. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 13. Jan. 1989
    Erworben am 20. Jan. 1990
    Geliefert am 09. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from bpcc LTD to each of the mezzanine lenders under a loan agreement dated 21/12/88
    Kurze Angaben
    (See doc M658C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Mezzanine Lenders
    Transaktionen
    • 09. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 13. Jan. 1989
    Erworben am 20. Jan. 1990
    Geliefert am 09. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from bpcc LTD to each of the mezzanine lenders under a loan agreement dated 21/12/88 and from the company and/or all or any of the other companies named therein under the facilities agreement (as defined)
    Kurze Angaben
    (See doc M664C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Banks (As Defined)
    Transaktionen
    • 09. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 16. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 13. Jan. 1989
    Erworben am 05. Jan. 1990
    Geliefert am 24. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from bpcc LTD and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under a loan agreement dated 21ST december 1988 and the facilities agreement secured on property acquired by bpcc catalogues LTD on the 5TH january 1990.
    Kurze Angaben
    (See doc M400- ref M200C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent & Trustee for the Banks and the Overdraft Bank as Defined.
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    • 08. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 13. Jan. 1989
    Erworben am 05. Jan. 1990
    Geliefert am 24. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from bpcc LTD to the chargee under a loan agreement dated 21-12-88 secured on property acquired by bpcc catalogues limited on the 5-1-1990.
    Kurze Angaben
    (See doc M400- ref M207C for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Mezzanine Lenders
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    • 26. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0