ASCRIBE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ASCRIBE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02394847 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ASCRIBE LIMITED?
- Entwicklung von Geschäfts- und Haushaltssoftware (62012) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich ASCRIBE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Pkf Gm, 3rd Floor One Park Row LS1 5HN Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ASCRIBE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ASC COMPUTER SOFTWARE LIMITED | 14. Juni 1989 | 14. Juni 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASCRIBE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ASCRIBE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 16 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Sept. 2023 | 18 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 10. Okt. 2022
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA England zum Pkf Gm, 3rd Floor One Park Row Leeds LS1 5HN am 03. Okt. 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Zweite Einreichung für die Ernennung von Mr Paul Stewart zum Geschäftsführer | 3 Seiten | RP04AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Paul Stewart als Direktor am 20. Juli 2022 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew John Thorburn als Geschäftsführer am 20. Juli 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Suzanne Marie Foster als Geschäftsführer am 20. Juli 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 30 Seiten | AA | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA England zum Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 28 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ASCRIBE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENSON, Christine | Sekretär | One Park Row LS1 5HN Leeds Pkf Gm, 3rd Floor | 239350110001 | |||||||
| SOUTHBY, Peter John | Geschäftsführer | One Park Row LS1 5HN Leeds Pkf Gm, 3rd Floor | England | British | 116859780002 | |||||
| STEWART, Paul | Geschäftsführer | One Park Row LS1 5HN Leeds Pkf Gm, 3rd Floor | England | British | 262072580001 | |||||
| FARBRIDGE, Caroline Louise | Sekretär | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | 193500130001 | |||||||
| JONES, Christopher Kenneth | Sekretär | 12 Cherry Tree Avenue WA13 0NS Lymm Cheshire | English | 29059120001 | ||||||
| LEE, Jeremy Stephen William | Sekretär | 10 Hodge Fold SK14 6BL Broadbottom Cheshire | British | 98814590001 | ||||||
| MOTTRAM, Mandy Joanne | Sekretär | Constable Drive Marple Bridge SK6 5BG Stockport 18 Cheshire England | 166860490001 | |||||||
| RUSCOE, Antony Myles | Sekretär | 21 Sycamore Close Endmoor LA8 0NY Kendal Cumbria | British | 49371150003 | ||||||
| WAITE, Simon Nicholas | Sekretär | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House | 213728810001 | |||||||
| BRADSHAW, Arthur Richard | Geschäftsführer | 4 The Spinney Horrobin Lane Turton BL7 0JA Bolton Lancashire | British | 5411670002 | ||||||
| CRITCHLOW, Anthony Stephen | Geschäftsführer | Grange Farm Grange Road Bromley Cross BL7 9AX Bolton | United Kingdom | British | 101716720002 | |||||
| DICKSON, Christopher John | Geschäftsführer | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | England | British | 100748280003 | |||||
| FOSTER, Suzanne Marie | Geschäftsführer | Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds Fulford Grange England | England | British | 262072440001 | |||||
| GARRINGTON, Stephen John | Geschäftsführer | 15 Chesterton Close Hunt End B97 5XS Redditch Worcestershire | British | 45513680001 | ||||||
| HUGHES, David Michael | Geschäftsführer | Lea House Patshull Road, Albrighton WV7 3BH Wolverhampton | England | British | 12292930002 | |||||
| JOHNSON, Paul Thomas | Geschäftsführer | 51 Glebe Lane ST20 0HG Gnosall Staffordshire | British | 74821110001 | ||||||
| JONES, Christopher Kenneth | Geschäftsführer | 43 Moorland Drive Rise Haslingden BB4 6UA Rossendale Lancashire | English | 29059120002 | ||||||
| KELLY, Mark William | Geschäftsführer | 129 Regent Road BL6 4DX Bolton Lancashire | British | 79084160001 | ||||||
| LAWRENCE, Duane Stephen | Geschäftsführer | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | England | British,American | 195658640003 | |||||
| LEE, Jeremy Stephen William | Geschäftsführer | 10 Hodge Fold SK14 6BL Broadbottom Cheshire | United Kingdom | British | 98814590001 | |||||
| MELLOR, Marcus Irving | Geschäftsführer | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | England | United Kingdom | 156959810001 | |||||
| RUSCOE, Antony Myles | Geschäftsführer | 21 Sycamore Close Endmoor LA8 0NY Kendal Cumbria | Uk | British | 49371150003 | |||||
| SALTER, Richard Leonard James | Geschäftsführer | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | England | British | 181746490001 | |||||
| SPENCER, Christopher Michael Kennedy | Geschäftsführer | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | England | British | 4742550002 | |||||
| STENTON, Raymond | Geschäftsführer | 2 Old Hall Lane Worsley M28 2FG Manchester | British | 97198410001 | ||||||
| TAMBLYN, Christina | Geschäftsführer | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | England | British | 191028210001 | |||||
| TAYLOR, Ian Albert | Geschäftsführer | Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds Fulford Grange England | United Kingdom | British | 237425740001 | |||||
| THORBURN, Andrew John | Geschäftsführer | Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds Fulford Grange England | United Kingdom | British | 124801800001 | |||||
| TOWNEND, Nicholas Adam | Geschäftsführer | Ascribe House Branker Street Westhoughton BL5 3JD Bolton Lancashire | England | British | 154577090001 | |||||
| WILLIAMS, Jane | Geschäftsführer | 163 Smithy Lane L40 8HJ Scarisbrick Lancashire | British | 79289770001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ASCRIBE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascribe Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds Fulford Grange England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ASCRIBE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 26. März 2009 Geliefert am 01. Apr. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. März 2009 Geliefert am 01. Apr. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A specific security deed | Erstellt am 26. März 2009 Geliefert am 01. Apr. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The securities, the rights, all proceeds of any securities or rights and all documents of the title relating to any securities or rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of mortgage of marketable securities | Erstellt am 26. März 2009 Geliefert am 01. Apr. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the issued capital of asc computer software pty. LTD (abn 75 075 121 028) held by the mortgagor, which as at the date of the deed consists of 1,000 fully paid ordinary shares of $1.00 each see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. März 2006 Geliefert am 17. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 17. Juni 1997 Geliefert am 19. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ASCRIBE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0