GL SETTLE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | GL SETTLE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02396127 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GL SETTLE LIMITED?
- Sonstige Software-Veröffentlichungen (58290) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich GL SETTLE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 25 Canada Square E14 5LQ London United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GL SETTLE LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MISYS SECURITIES TRADING SYSTEMS LIMITED | 21. Nov. 2001 | 21. Nov. 2001 |
SOFT OPTION SYSTEMS LIMITED | 16. Juni 1989 | 16. Juni 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GL SETTLE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GL SETTLE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung am 29. Juni 2021
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
Ernennung von Charles Harrison Keller als Direktor am 03. Mai 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Marc Mayo als Geschäftsführer am 30. Apr. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ann Maria Vasileff am 01. Dez. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Marc Mayo am 01. Dez. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Martin Robert Boyd am 01. Dez. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Howard Wallis am 01. Dez. 2018 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Level 39 25 Canada Square London E14 5LQ zum 25 Canada Square London E14 5LQ am 29. Juni 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Notification of Fidelity National Information Services, Inc. as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Withdrawal of a person with significant control statement on 27. Juli 2017 | 2 Seiten | PSC09 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GL SETTLE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALLIS, Howard | Sekretär | c/o Fis Corporate Legal Canada Square E14 5LQ London 25 England | British | 154724020001 | ||||||
BOYD, Martin Robert | Geschäftsführer | c/o Fis Corporate Legal Canada Square E14 5LQ London 25 England | England | British | Business Executive | 88627530004 | ||||
KELLER, Charles Harrison | Geschäftsführer | c/o Fis Legal Department Canada Square Canary Wharf E14 5LQ London Level 40, 25 England | United States | American | Attorney | 283440470001 | ||||
VASILEFF, Ann Maria | Geschäftsführer | c/o Fis Corporate Legal Canada Square E14 5LQ London 25 England | United States | American | Financial Officer | 243562940001 | ||||
BISHTON, Roger John | Sekretär | 96 Argyle Road Ealing W13 8EL London | British | Finance Director | 89188220002 | |||||
DURRANT, Zoe Vivienne | Sekretär | Beehive Cottage Radford Road, Rous Lench WR11 4UL Evesham Worcestershire | British | 68141090001 | ||||||
HAM, Richard Laurence | Sekretär | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | British | 136433670001 | ||||||
HELLAL, Smahil | Sekretär | c/o Legal Department Mail Drop 39-50 25 Canada Square E14 5LQ Canary Wharf Level 39 London United Kingdom | French | 106688920003 | ||||||
HORNE, Ralph James | Sekretär | 163 Woodyates Road Lee SE12 9JJ London | British | Director | 47997220003 | |||||
MCFARLANE, James Baxter | Sekretär | 19 New Street Hill BR1 5AU Bromley | British | 24635370002 | ||||||
WATERS, Paul Christopher | Sekretär | The Old Vicarage High Street B50 4BQ Bidford On Avon Warwickshire | British | 67435560001 | ||||||
BRAHIM, Yassine | Geschäftsführer | c/o Legal Department Mail Drop 39-50 25 Canada Square E14 5LQ Canary Wharf Level 39 London United Kingdom | United Kingdom | French | Group Coo | 121064850001 | ||||
CALDER, Stuart James | Geschäftsführer | Hillbrick Barn Lenborough MK18 4BP Buckingham | British | Managing Director | 84470180001 | |||||
COUTURIER, Jason Lydell | Geschäftsführer | Riverside Avenue Jacksonville 601 Florida 32204 Usa | Usa | American | Certified Public Accountant | 203467010001 | ||||
ERICKSON, Eric George | Geschäftsführer | c/o Sungard Legal 25 Canada Square Canary Wharf E14 5LQ London Level 39 Mail Drop 39-50 | Usa | Usa | Corporate Executive | 224104020001 | ||||
FONSECA, Anselm Joseph Paul | Geschäftsführer | c/o Sungard Legal 25 Canada Square Canary Wharf E14 5LQ London Level 39 Mail Drop 39-50 United Kingdom | England | British | Business Executive | 165294580001 | ||||
GATIGNOL, Pierre | Geschäftsführer | c/o Legal Department Mail Drop 39-50 25 Canada Square E14 5LQ Canary Wharf Level 39 London United Kingdom | France | French | Company Director | 93772340001 | ||||
GLEDHILL, Stephen | Geschäftsführer | Wisteria Cottage 6 Hillfield Mews Hillfield B91 3QA Solihull | British | Financial Director | 61147620002 | |||||
GLUYAS, Dean Barry | Geschäftsführer | c/o Fis Legal Level 39, Mail Drop 39-50 Canary Wharf E14 5LQ London 25 Canada Square United Kingdom | Switzerland | British | Corporate Executive | 156978860001 | ||||
HORNE, Ralph James | Geschäftsführer | 163 Woodyates Road Lee SE12 9JJ London | British | Director | 47997220003 | |||||
HUGHES, David Michael | Geschäftsführer | Natsfield House Nurton Hill Road Pattingham WV6 7HQ Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | Company Director | 12292930001 | ||||
LEVY, Nicolas Jean | Geschäftsführer | 1 Prebend Gardens W4 1TN London | French | Company Director | 93772400002 | |||||
MANN, Andrew Howard | Geschäftsführer | 84 Lots Road Chelsea SW10 0QD London | British | Technical Consultant | 24635390001 | |||||
MARTIN, Ivan | Geschäftsführer | 90 Ranelagh Road Ealing W5 5RP London | England | British | Director | 123233030001 | ||||
MAYO, Marc | Geschäftsführer | c/o Fis Corporate Legal Canada Square E14 5LQ London 25 England | United States | American | Attorney | 60818410001 | ||||
MCFARLANE, James Baxter | Geschäftsführer | 19 New Street Hill BR1 5AU Bromley | British | Director | 24635370002 | |||||
MILLER JR, Henry Morton | Geschäftsführer | c/o Sungard Legal Mail Drop 39-50 25 Canada Square E14 5LQ London Level 39 United Kingdom | United States Of America | United States | Financial Executive | 168297330001 | ||||
MOLONEY, Barry William | Geschäftsführer | Little Chantry Bull Lane SL9 8RH Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 48187880001 | ||||
MURRAY, Andrew | Geschäftsführer | 42 Lewisham Way New Cross SE14 6NP London | British | Company Director | 39939130001 | |||||
OBETZ, Richard James | Geschäftsführer | c/o Sungard Legal Mail Drop 39-50 25 Canada Square Canary Wharf E14 5LQ London Level 39 United Kingdom | Usa | American | Corporate Executive | 158287890001 | ||||
PECKER, Rudolf | Geschäftsführer | 8 Somali Road NW2 3RL West Hampstead London | Australian | Director | 86034970001 | |||||
PEDDER, Clive Thomas | Geschäftsführer | c/o Sungard Legal Mail Drop 39-50 25 Canada Square Canary Wharf E14 5LQ London Level 39 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 71955460001 | ||||
REDGRAVE, Jonathan Matthew | Geschäftsführer | 19 Manor Road TW9 1YA Richmond Surrey | British | Analyst/Programmer | 39547530001 | |||||
RIDLEY, John Henry | Geschäftsführer | 117 Highfield Way WD3 2PL Rickmansworth Hertfordshire | United Kingdom | British | Software Development Director | 44295640001 | ||||
SOAMES, Rupert Christopher | Geschäftsführer | Ridge Barn Farm House Ridgebarn Lane, Cuddington HP18 0AE Aylesbury Buckinghamshire | Scotland | British | Company Director | 86671010001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GL SETTLE LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity National Information Services, Inc. | 06. Apr. 2016 | 25 Canada Square E14 5LQ London Level 39 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für GL SETTLE LIMITED?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
01. Dez. 2016 | 01. Dez. 2016 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat GL SETTLE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 | Erstellt am 17. Sept. 2003 Geliefert am 01. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995 | Erstellt am 11. Sept. 2003 Geliefert am 24. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and | Erstellt am 29. Juli 2003 Geliefert am 12. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter) | Erstellt am 23. Okt. 2002 Geliefert am 13. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and | Erstellt am 09. Mai 2002 Geliefert am 25. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0