GP-ELLIOTT ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GP-ELLIOTT ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02397549 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GP-ELLIOTT ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED?
- (3330) /
Wo befindet sich GP-ELLIOTT ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hall Road Maldon CM9 4LA Essex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GP-ELLIOTT ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CONEHOLD LIMITED | 22. Juni 1989 | 22. Juni 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GP-ELLIOTT ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GP-ELLIOTT ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francis Conway als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Watson als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Antony Parsell als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Brian Andrew Watson als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Antony Clive Parsell am 02. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Frederic Hendrickx als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Claudia Griffin als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 4 Seiten | AUD | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GP-ELLIOTT ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONWAY, Francis Joseph | Sekretär | Torrington Drive EN6 5HS Potters Bar 40 Hertfordshire | British | 137700320001 | ||||||
| DODDS, Brian Alfred | Sekretär | 4 Parkway Gidea Park RM2 5NT Romford Essex | British | 1782460002 | ||||||
| CHAPMAN, Robert John | Geschäftsführer | 17 Sheerwater Close CM0 8EN Burnham On Crouch Essex | British | 66967980001 | ||||||
| COOPER, Glenn Charles | Geschäftsführer | Old House Farm Littlemaplestead Road, Gestingthorpe CO9 3AR Halstead Essex | British | 78846260001 | ||||||
| DODDS, Brian Alfred | Geschäftsführer | 4 Parkway Gidea Park RM2 5NT Romford Essex | British | 1782460002 | ||||||
| FRANCIS, Colin James | Geschäftsführer | Jarol House Mill Lane Felbridge RH19 2PE East Grinstead West Sussex | British | 31643010001 | ||||||
| GRIFFIN, Claudia Maria | Geschäftsführer | Rue De La Concorde 7 1050 Brussels Belgium | German | 125074000002 | ||||||
| HALL, Peter John, Doctor | Geschäftsführer | Clavering Hall Stortford Road Clavering CB11 4PG Saffron Walden Essex | British | 112317390001 | ||||||
| HENDRICKX, Frederic Jean Hubert Cecile | Geschäftsführer | Korenveldlaan, 56 Wemmel 1780 Belgium | Belgium | Belgian | 126703710001 | |||||
| HOMEWOOD, Kenneth Arthur | Geschäftsführer | 25 Parkside Place East Horsley KT24 5BZ Leatherhead Surrey | British | 2023190001 | ||||||
| LEESER, Andrew John | Geschäftsführer | 17 Rectory Road North Fambridge CM3 6NG Chelmsford Essex | United Kingdom | British | 92752280001 | |||||
| LEWENDON, Alan Charles | Geschäftsführer | 116 Waddington Way SE19 3UA Upper Norwood London | British | 79461040001 | ||||||
| LINDSAY, David | Geschäftsführer | 92 Sandringham Road WD24 7BE Watford Hertfordshire | British | 78093740001 | ||||||
| MOTTERSHEAD, Peter David Leigh | Geschäftsführer | Red Barn House Red Barn Drive Leavenheath CO6 4UW Colchester Essex | England | British | 102140470001 | |||||
| PALMER, Denis George | Geschäftsführer | 27 Station Road Tiptree CO5 0BB Colchester Essex | British | 32075450001 | ||||||
| PARSELL, Antony Clive | Geschäftsführer | 20 Blacksmith Close CM23 4GB Bishops Stortford Hertfordshire | England | English | 76298010001 | |||||
| RIMMER, David Norman | Geschäftsführer | Ridgefield 23 Newport Road ST21 6BE Eccleshall Staffordshire | United Kingdom | British | 71617270002 | |||||
| SLATTER, Randle James | Geschäftsführer | 16 Colneys Close CO10 5LH Sudbury Suffolk | British | 65583130002 | ||||||
| SNOW, Martin Neil | Geschäftsführer | 1 Lawrence Close Raunds NN9 6RF Wellingborough Northamptonshire | Uk | British | 69219900001 | |||||
| SUTTLE, Alan Kenneth | Geschäftsführer | 35 Heath Drive CM2 9HB Chelmsford Essex | United Kingdom | British | 32136660001 | |||||
| TARALA, Alexander Mark | Geschäftsführer | Heath Lodge Colchester Main Road Alresford CO7 8DB Colchester | England | British | 43163230001 | |||||
| WATSON, Brian Andrew | Geschäftsführer | Hall Road CM9 4LA Maldon Ics House Essex | United Kingdom | British | 147524500001 | |||||
| WHEATLEY, Clement Trevor | Geschäftsführer | Plas-Y-Bryn Llanfair Road SY16 3JY Newtown Powys | Wales | British | 10994430002 | |||||
| WITHRINGTON, Geoffrey Alan | Geschäftsführer | Martins Thakeham RH20 3EP Pulborough West Sussex | British | 56500950001 |
Hat GP-ELLIOTT ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Erstellt am 15. Jan. 2001 Geliefert am 24. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The premises as defined in the mortgage debenture namely all and singular the undertaking and assets whatsoever and wheresoever both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 19. Juni 1998 Geliefert am 06. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the mortgage debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 04. Juli 1997 Geliefert am 16. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the mortgage debenture | |
Kurze Angaben Title no. Ex 511 366 : car parking land, the saltings, maldon, essex CM9 4LA owned by bcmb private clients limited. All other freehold and leasehold property of the companies; unpaid issued shares in the capital of the companies; all goodwill, engines, plant, machinery, fixtures, fittings, furniture and equipment, hire purchase agreements and books of account of the companies; all securities and documents evidencing any estate, right, title or interest of the companies in any property deposited with the trustee; all book debts and receivables of the companies; and all other fixed assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental charge | Erstellt am 18. Juni 1997 Geliefert am 25. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a principal debenture dated 24TH august 1990 | |
Kurze Angaben All patents patent applications trade marks trade mark applications designs design rights and all other intellectual property rights inclusive of all licences under the charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture | Erstellt am 12. Okt. 1990 Geliefert am 22. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from industrial control services PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 10. Sept. 1990 Geliefert am 18. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any of the associated companies (as therein defined) to the chargee as trustee or any of the principal creditors (as therein defined) on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Undertaking and assets present & future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 24. Aug. 1990 Geliefert am 06. Sept. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0