ZALCANY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ZALCANY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02397965 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ZALCANY LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich ZALCANY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3rd Floor 24 Chiswell Street London EC1Y 4YX |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ZALCANY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ZALCANY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2020 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Michael Harris am 19. Sept. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Roy Grainger Williams am 19. Sept. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Nigel Harris als Geschäftsführer am 09. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Notification of Cardinal Holdings Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 11 Seiten | MEM/ARTS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 5 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ZALCANY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Hugh Grainger | Sekretär | Church Lane Shilton OX18 4AD Burford Ivy Bank Oxfordshire | British | 149277770001 | ||||||
| HARRIS, Richard Michael | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1HT London 16 | United Kingdom | Israeli | 3089820035 | |||||
| WILLIAMS, Roy Grainger | Geschäftsführer | Hanover Square W1S 1HT London 16 | United Kingdom | British | 78315110002 | |||||
| TOPPER, Alan | Sekretär | 24 Adelaide Close HA7 3EN Stanmore Middlesex | British | 2981850003 | ||||||
| BEARCROFT, Jeffrey John | Geschäftsführer | 22 Hawkewood Road TW16 6HH Sunbury On Thames Middlesex | British | 74508690001 | ||||||
| BUSTIN, Nicola Marie | Geschäftsführer | 62 Goldhurst Terrace NW6 3HT London | British | 53513080001 | ||||||
| HARRIS, Robert Nigel | Geschäftsführer | Cedars Close Hendon NW4 1TR London 4 | England | British | 11654900003 | |||||
| JESSOP, Richard | Geschäftsführer | 39 Birchmead Avenue HA5 2BQ Pinner Middlesex | British | 14015290001 | ||||||
| JONES, Christopher Neville | Geschäftsführer | 55 York Mews GU34 1JD Alton Hampshire | England | British | 109266700001 | |||||
| SMITH, Andrew Mark | Geschäftsführer | Grove Cottage 15 The Strand Attenborough NG9 6AU Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 26977900001 | |||||
| WALSH, David | Geschäftsführer | 82 North Gate Prince Albert Road NW8 7EJ St Johns Wood London | United Kingdom | British | 88854610001 | |||||
| WILLIAMS, Roy Grainger | Geschäftsführer | Armscote Manor CV37 8DA Armscote Warwickshire | United Kingdom | British | 78315110002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ZALCANY LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 24 Chiswell Street EC1Y 4YX London 3rd Floor | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ZALCANY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 21. Dez. 1999 Geliefert am 29. Dez. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee as agent and trustee for the finance parties (the agent) under each finance document (the secured obligations) | |
Kurze Angaben The properties as described in schedule 1 to the form 395 and all plant and machiinery, all moneys standing to the credit of any account all book and other debts the goodwill and benefit of all licences, uncalled capital and a floating charge over the assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 20. Feb. 1990 Geliefert am 22. Feb. 1990 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £3,000,000 & all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 4/9/89 and the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a part of caxton house farringdon road, london borough of camden, title no. Ngl 11062 together with all fixtures and fittings plant and machinery thereon. By way of floating charge all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 20. Feb. 1990 Geliefert am 22. Feb. 1990 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/as caxton house, 2 farringdon road london EC1 title no: ngl 11062 tog. With all buildings and fixtures. Inc. Goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0