DX FREIGHT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDX FREIGHT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02402927
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DX FREIGHT LIMITED?

    • Güterkraftverkehr (49410) / Verkehr und Lagerei

    Wo befindet sich DX FREIGHT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DX FREIGHT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NIGHTFREIGHT (GB) LIMITED20. Aug. 200420. Aug. 2004
    NIGHTFREIGHT (GREAT BRITAIN) LIMITED25. Juli 198925. Juli 1989
    FRAMDOWN LIMITED11. Juli 198911. Juli 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DX FREIGHT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2013

    Welche sind die letzten Einreichungen für DX FREIGHT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. März 2018

    6 SeitenLIQ03

    Beendigung der Bestellung von Ian Richard Pain als Geschäftsführer am 03. Nov. 2017

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Stuart Lee Godman als Geschäftsführer am 31. Okt. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Petar Cvetkovic als Geschäftsführer am 14. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. März 2017

    4 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:court order - removal/ replacement of liquidator
    30 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Beendigung der Bestellung von Raquel Mcgrath als Sekretär am 26. Mai 2016

    1 SeitenTM02

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. März 2016

    4 Seiten4.68

    Beendigung der Bestellung von Gary Bowes als Geschäftsführer am 30. Juni 2015

    3 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Crestwood House Birches Rise Willenhall West Midlands WV13 2DB zum 15 Canada Square London E14 5GL am 26. März 2015

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    11 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 10. März 2015

    LRESSP

    Aktienspaltung am 26. Feb. 2015

    5 SeitenSH02

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 19. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 2.00
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Erfüllung der Belastung 024029270028 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    16 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 08. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 1,000,001
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von DX FREIGHT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HORSFALL, Ian David
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    Sekretär
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    British104565220001
    MCGRATH, Raquel
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    British167864190001
    RUSSELL, Craig
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    Sekretär
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    British35522270001
    ALDWINCKLE, Anthony Graham
    Copper Beeches Lillyfield
    L60 8NT Heswall
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Copper Beeches Lillyfield
    L60 8NT Heswall
    Cheshire
    United KingdomBritish50561100001
    ALFRED, Peter Charles William
    180 Holtye Road
    RH19 3ES East Grinstead
    West Sussex
    Geschäftsführer
    180 Holtye Road
    RH19 3ES East Grinstead
    West Sussex
    British19384490002
    ALLEN, Stephen John
    51 Old Penkridge Road
    WS11 1HY Cannock
    Whitemead
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    51 Old Penkridge Road
    WS11 1HY Cannock
    Whitemead
    Staffordshire
    United KingdomBritish113733110002
    BLACK, David Russell
    18 College Road
    WR14 3DD Malvern
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    18 College Road
    WR14 3DD Malvern
    Worcestershire
    British2755270005
    BOWES, Gary
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish139488510001
    BURNS, Bernard Kenneth Robbie
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    EnglandBritish239557120001
    CVETKOVIC, Petar
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish150976300002
    DICKINSON, John Richard
    25 St Peters Avenue
    Haslingden
    BB4 4BS Rossendale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    25 St Peters Avenue
    Haslingden
    BB4 4BS Rossendale
    Lancashire
    British35711670002
    DUNN, Lloyd John Charles
    Goodison 38 Mill Lane
    Barrow Upon Soar
    LE12 8LH Loughborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Goodison 38 Mill Lane
    Barrow Upon Soar
    LE12 8LH Loughborough
    Leicestershire
    EnglandBritish105512500001
    GODMAN, Stuart Lee
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritish285283120001
    GORMLEY, George
    18 Gloucester Road
    GL20 5SY Tewkesbury
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    18 Gloucester Road
    GL20 5SY Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglandBritish42452240001
    HELLOWELL, David Neil
    Upper Hole Head Farm
    Ash Hall Lane
    HX6 4NU Halifax
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Upper Hole Head Farm
    Ash Hall Lane
    HX6 4NU Halifax
    West Yorkshire
    British80462060001
    HORSFALL, Ian David
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    EnglandBritish104565220001
    KELLY, Robert David Lindsay
    Glanville House
    Alcester Road Wooton Wawen
    B95 6BQ Henley In Arden
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Glanville House
    Alcester Road Wooton Wawen
    B95 6BQ Henley In Arden
    Warwickshire
    EnglandWelsh161123860001
    LOUDEN, Peter
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    United KingdomBritish172376370001
    MEADOWCROFT, Christopher
    Lyndhurst 62 Kenilworth Road
    M33 5DB Sale
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Lyndhurst 62 Kenilworth Road
    M33 5DB Sale
    Cheshire
    British16010520002
    MILLER, John
    5 Talbot Court
    Huyton
    L36 5YW Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    5 Talbot Court
    Huyton
    L36 5YW Liverpool
    Merseyside
    British74164340001
    PAIN, Ian Richard
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish130880070001
    PAINTER, James
    Stoneleigh House Burley Lane
    DE22 5JR Quarndon
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Stoneleigh House Burley Lane
    DE22 5JR Quarndon
    Derbyshire
    British41731410001
    PATTERMORE, Anthony
    4 The Coppice
    Burbage
    LE10 2TF Leicester
    Geschäftsführer
    4 The Coppice
    Burbage
    LE10 2TF Leicester
    British98152670001
    PEARCE, Michael Graham
    12 Spring Meadow
    Cheslyn Hay
    WS6 7JW Walsall
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    12 Spring Meadow
    Cheslyn Hay
    WS6 7JW Walsall
    Staffordshire
    British49385270002
    POTTER, Ian Roger
    17 Victoria Mill Drive
    Willaston
    CW5 6RR Nantwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    17 Victoria Mill Drive
    Willaston
    CW5 6RR Nantwich
    Cheshire
    EnglandBritish63766210003
    REDBURN, Timothy John
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    Geschäftsführer
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    EnglandBritish22018030002
    RUSSELL, Craig
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Windrush 2 Firdene Crescent
    CH43 9TN Birkenhead
    Merseyside
    British35522270001
    SARGENT, Ian John
    Hunters Moon Wall Hill
    RH18 5EG Forest Row
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Hunters Moon Wall Hill
    RH18 5EG Forest Row
    East Sussex
    British16431850001
    SMITH, Ian Stuart
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Crestwood House
    Birches Rise
    WV13 2DB Willenhall
    West Midlands
    EnglandBritish328324130001
    SULLIVAN, Ronald Thomas
    Woodbarns Farm Blackmore Road
    Fryerning
    CM4 0PA Ingatestone
    Essex
    Geschäftsführer
    Woodbarns Farm Blackmore Road
    Fryerning
    CM4 0PA Ingatestone
    Essex
    United KingdomBritish32440070011
    WAKE, Anthony Francis
    8 Wentworth
    27 Westcliff Road,Birkdale
    PR8 2BL Southport
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    8 Wentworth
    27 Westcliff Road,Birkdale
    PR8 2BL Southport
    United Kingdom
    British33816220001
    WATSON, Paul John
    Dairy Cottage Palmers Cross Farm
    Codsall Road
    WV6 9QG Wolverhampton
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Dairy Cottage Palmers Cross Farm
    Codsall Road
    WV6 9QG Wolverhampton
    Staffordshire
    British29494480003
    WEBSTER, James
    3 Spindleberry Close
    AL6 0SJ Welwyn
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    3 Spindleberry Close
    AL6 0SJ Welwyn
    Hertfordshire
    British84733770001

    Hat DX FREIGHT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 13. März 2014
    Geliefert am 22. März 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Land and buidlings at colthrop thatcham t/no BK341441,land and buildings on the east side of josselin road burnt mills industrial estate basildon t/no EX481057,land lying to the west side of maidstone road rochester t/no K762615. Intellectual property trademark idw no 2567626,nightfreight logo b&w 2897130,nightfreight logo colour 2426451. please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (as Security Agent)
    Transaktionen
    • 22. März 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 27. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 21. Juni 2012
    Geliefert am 02. Juli 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Juli 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 10. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Standard security
    Erstellt am 26. Apr. 2012
    Geliefert am 09. Mai 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All and whole subjects on the east side of cambuslang road, cambuslang, glasgow t/no LAN145301 together with whole buildings and erections see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Pnc Business Credit, a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transaktionen
    • 09. Mai 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Real property security
    Erstellt am 20. Apr. 2012
    Geliefert am 26. Apr. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land lying to the south of ashmore lake way, willenhall t/no WM645332. F/h property k/a land on the south side of morgan close, willenhall t/no WM489440. F/h property k/a land and buildings lying on the north and south side of ashmore lake way, willenhall t/no WM450221. (For further details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 10. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 13. März 2012
    Geliefert am 17. März 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all non-vesting domestic a/r and their proceeds, all related rights, all non-vesting export a/r and related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transaktionen
    • 17. März 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 10. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed & floating charge
    Erstellt am 12. Juni 2008
    Geliefert am 28. Juni 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to rbs invoice finance limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental legal mortgage
    Erstellt am 05. Juni 2008
    Geliefert am 18. Juni 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the secured parties and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Secured Parties (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 18. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 30. Juni 2004
    Geliefert am 05. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the security trustee and the secured parties and to any of them. Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property being depot at josselin road and wollaston way burnt mills industrial estate basildon t/n EX481057. Land and buildings on the south west side of greenbrook road lowerhouse t/n LS730423, land and buildings on the south west side of greenbrook road lowerhouse t/n LA624280. (For details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Securedparties
    Transaktionen
    • 05. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental deed to the third guarantee and debenture (the "debenture") dated 20 june 2001 made between nightfreight (great britain) limited and the governor and company of the bank of scotland
    Erstellt am 19. Dez. 2001
    Geliefert am 02. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    As set out in the assignment dated 03 july 2001 the supplemental deed amends the definition of the "senior finance documents" (as defined therein)
    Kurze Angaben
    As set out in the 395 registered on 3 july 2001 in relation to the debenture.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed to the second guarantee and debenture (the "debenture") dated 05 march 2001 made between nightfreight (great britain) limited and the governor and company of the bank of scotland
    Erstellt am 19. Dez. 2001
    Geliefert am 02. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    As set out in the assignment dated 13 march 2001 the supplemental deed amends the definition of the "senior finance documents" (as defined therein)
    Kurze Angaben
    As set out in the 395 registered on 13 march 2001 in relation to the debenture.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 20. Juni 2001
    Erworben am 20. Aug. 2003
    Geliefert am 10. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land and buildings at woolsthorpe nottingham title number NT212980.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 20. Juni 2001
    Erworben am 20. Aug. 2003
    Geliefert am 10. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Crestwood house birches rise willenhall title number WM697729 and land on the south side of morgan close willenhall title number WM489440 land and buildings lying to the north and south side of ashmore lake way willenhall title number WM450221. For further details of property charged please refer to form 400. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 20. Juni 2001
    Erworben am 20. Aug. 2003
    Geliefert am 10. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that estate and interest in areas of land numbered 1,2,3,4,5,6,7,8 and 9 at ashmore lake way willenhall.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 20. Juni 2001
    Erworben am 20. Aug. 2003
    Geliefert am 10. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Unit 9A sir thomas longley road medway city estate rochester title number K644151.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 20. Juni 2001
    Erworben am 20. Aug. 2003
    Geliefert am 10. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land on the west side of lowton way hellaby rotherham title number SYK424368.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 20. Juni 2001
    Geliefert am 03. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities on or after the date of the debenture due, owing or incurred by the company (the "chargor") to the chargee (acting as security agent and trustee for the other beneficiaries (as defined) and includes any successor appointed by the beneficiaries pursuant to the finance documents) under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents (both as defined therein) to which it is expressed to be a party; and each other company to the chargee (acting as security agent and trustee for the other beneficiaries (as defined) and includes any successor appointed by the beneficiaries pursuant to the finance documents) (as therein defined) (except as a guarantor for the "chargor") under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents and on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 05. März 2001
    Erworben am 20. Aug. 2003
    Geliefert am 10. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land on the west side or lowton way hellaby rotherham title number SYK424368.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 05. März 2001
    Erworben am 20. Aug. 2003
    Geliefert am 10. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Unit 9A sir thomas longley road medway city estate rochester title number K644151.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 05. März 2001
    Erworben am 20. Aug. 2003
    Geliefert am 10. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that estate and interest in areas of land shown coloured blue and numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 at ashmore lake way willenhall.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 05. März 2001
    Erworben am 20. Aug. 2003
    Geliefert am 10. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land and buildings at woolsthorpe nottingham title number NT212980.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 05. März 2001
    Erworben am 20. Aug. 2003
    Geliefert am 10. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Crestwood house birches rise willenhall title number WM697729 and land on the south side of morgan close willenhall title number WM489440 land and buildings lying to the north and south side of ashmore lake way willenhall title number WM450221. For further details of property charged please refer to form 400. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2003Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 05. März 2001
    Geliefert am 13. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security agent and trustee for the benficiaries (as defined) under or pursuant to the senior finance documents (as defined) and each other company (as defined) (except as guarantor for the chargor) under or pursuant to the senior finance documents on any account whatsoever and all monies and liabilities owing or incurred to each beneficiary by the compan under or pursuant to the mezzanine finance documents (as defined) and each other company (except as a guarantor for the chargor) under or pursuant to the mezzanine finance documents on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Aug. 1997
    Geliefert am 27. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Jan. 1995
    Geliefert am 13. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company,nightfreight PLC and nightfreight distribution limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Collateral debentire
    Erstellt am 06. Nov. 1993
    Geliefert am 09. Nov. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from nightfreight PLC to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 09. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat DX FREIGHT LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Nov. 2018Aufgelöst am
    10. März 2015Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring 15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    Kpmg Restructuring 15 Canada Square
    E14 5GL London
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0