ARRIVA DURHAM COUNTY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ARRIVA DURHAM COUNTY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02404350 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ARRIVA DURHAM COUNTY LIMITED?
- Sonstiger Personenlandverkehr im Stadt-, Vorort- oder Ballungsraum (nicht U-Bahn, Metro oder ähnlich) (49319) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich ARRIVA DURHAM COUNTY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ARRIVA DURHAM COUNTY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| UNITED AUTOMOBILE SERVICES LIMITED | 04. Feb. 1990 | 04. Feb. 1990 |
| CALDAIRE NORTH EAST LIMITED | 04. Sept. 1989 | 04. Sept. 1989 |
| PRIESTGATE SERVICES (NO. 81) LIMITED | 14. Juli 1989 | 14. Juli 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ARRIVA DURHAM COUNTY LIMITED?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2025 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2026 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2024 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ARRIVA DURHAM COUNTY LIMITED?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 03. Mai 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 17. Mai 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 03. Mai 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für ARRIVA DURHAM COUNTY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beendigung der Bestellung von Nicholas John Bradley als Geschäftsführer am 17. Dez. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kimberley Jayne Cain als Geschäftsführer am 17. Dez. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Colin Barnes als Direktor am 10. Dez. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ben William Scott als Geschäftsführer am 30. Okt. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2024 | 37 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 143 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Mai 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 21 Seiten | MA | ||||||||||
Eintragung der Belastung 024043500009, erstellt am 20. Dez. 2024 | 68 Seiten | MR01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 46 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Mai 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von John Charles Rochford als Direktor am 16. Jan. 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 44 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 47 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Mai 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Howard Edge Farrall als Geschäftsführer am 28. Apr. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Kimberley Jayne Purcell am 17. Apr. 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Nicholas John Bradley als Direktor am 06. März 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Ian Thompson als Geschäftsführer am 08. März 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Howard Edge Farrall als Direktor am 25. Sept. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ARRIVA DURHAM COUNTY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARNES, Colin | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | England | British | 254036510001 | |||||
| ROCHFORD, John Charles | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | England | British | 318146280001 | |||||
| DAVIES, Elizabeth Anne | Sekretär | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | British | 102907000002 | ||||||
| EDWARDS, Lorna | Sekretär | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | 183720920001 | |||||||
| ESNER, Jonathan | Sekretär | Bridge House Bridge Island, Shotley Bridge DH8 9TB Consett County Durham | British | 121047310001 | ||||||
| LAUCHT, Robert Ian | Sekretär | 1 High Meadows, Church Lane Kirk Ella HU10 7NJ Hull East Riding Yorkshire | British | 13774020001 | ||||||
| RICHARDS, Lewis | Sekretär | 16 Dove House Lane B91 2EX Solihull West Midlands | British | 2452070001 | ||||||
| TURNER, David Paul | Sekretär | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
| WATSON, Kenneth James | Sekretär | 1 Portsmouth Place DL1 2XH Darlington County Durham | British | 29509590001 | ||||||
| ASHCROFT, Alison | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | England | British | 263309540001 | |||||
| BOWLER, Richard Anthony | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | England | British | 35116070003 | |||||
| BRADLEY, Nicholas John | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | England | British | 306514980001 | |||||
| BURD, Stephen | Geschäftsführer | 13 St Margarets Close Ingol PR2 3ZU Preston Lancashire | British | 110122050001 | ||||||
| CAIN, Kimberley Jayne | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 243099020002 | |||||
| CLAYTON, Stephen John | Geschäftsführer | New Hall Farmhouse Fanhams Hall Road Newhall Green Wareside SG12 7SD Ware Hertfordshire | England | British | 46866840005 | |||||
| COCKER, David | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | England | British | 37574310002 | |||||
| COUNSELL, Jeffrey | Geschäftsführer | Jasmin Cottage The Paddock Mickleton DL12 0LG Barnard Castle County Durham | British | 48176680003 | ||||||
| CUMMINS, Philip | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | England | British | 153482060002 | |||||
| DAVIES, Lisa Marie | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | England | British | 209277960001 | |||||
| EDWARDS, Tina Colleen | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | England | British | 204069460001 | |||||
| FARRALL, Howard Edge | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | Wales | British | 150235100001 | |||||
| FEATHAM, Nigel Paul | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | England | British | 161124990001 | |||||
| GRACE, David Martin | Geschäftsführer | Woodhouse Back Lane Woolley WF4 2JT Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | 27031320002 | |||||
| GREAVES, John | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 40433200001 | |||||
| GUEST, Andrew William Gordon | Geschäftsführer | Stonecroft, 7 Grange Road Brompton On Swale DL10 7HJ Richmond North Yorkshire | British | 85467650001 | ||||||
| HARGRAVE, Russell John | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | England | English | 201922420001 | |||||
| HOARE, Richard James | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 270733550001 | |||||
| HODGSON, Gordon William | Geschäftsführer | Bramble House Easington Lane DH5 0QX Houghton Le Spring Tyne & Wear | British | 1108360001 | ||||||
| HODGSON, Kenneth | Geschäftsführer | The Grange Church Lane Elvington YO41 4HD York | United Kingdom | British | 9946200002 | |||||
| HUNTER, Michael John | Geschäftsführer | 100 Manygates Lane Sandal WF2 7DP Wakefield West Yorkshire | British | 1058260002 | ||||||
| JOHNSON, Richard | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | England | British | 227375000001 | |||||
| JOHNSTONE, David Graham | Geschäftsführer | 7 Pont Haugh Eland Mews Ponteland NE20 9XD Newcastle Upon Tyne | British | 95834280001 | ||||||
| KERSLAKE, Brian John | Geschäftsführer | Oaklands Coppenhall ST18 9BW Stafford Staffordshire | British | 34169610003 | ||||||
| KNIGHT, Robin Francis | Geschäftsführer | 52 Ski View Vicarage Farm SR3 1NP Sunderland Tyne & Wear | British | 39458100002 | ||||||
| KNOX, Nicholas Robert | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park, Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 203344140001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ARRIVA DURHAM COUNTY LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arriva Uk Bus Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland 1 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0