BARTON (TRIBUTE) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBARTON (TRIBUTE) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02406566
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BARTON (TRIBUTE) LIMITED?

    • (6110) /

    Wo befindet sich BARTON (TRIBUTE) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BARTON (TRIBUTE) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BARTON SHIPPING COMPANY LIMITED 15. Juni 199815. Juni 1998
    BARTON (TRIBUTE) LIMITED04. Apr. 199004. Apr. 1990
    SINORD 34 LIMITED20. Juli 198920. Juli 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BARTON (TRIBUTE) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für BARTON (TRIBUTE) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Geänderte Geschäftsanschrift vom St Paul's House Warwick Lane London EC4M 7BP am 21. Apr. 2010

    2 SeitenAD01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    legacy

    1 Seiten652a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008

    12 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007

    11 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2006

    11 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Juli 2005

    11 SeitenAA

    Geänderte vollständige Konten erstellt bis 30. Juni 2004

    11 SeitenAAMD

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2004

    11 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von BARTON (TRIBUTE) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CORNHILL SECRETARIES LIMITED
    St Paul's House
    Warwick Lane
    EC4M 7BP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    St Paul's House
    Warwick Lane
    EC4M 7BP London
    900023430001
    FOX, Rodney Bruce
    26 Sydney Street
    SW3 6PP London
    Geschäftsführer
    26 Sydney Street
    SW3 6PP London
    United KingdomAustralianCompany Director42724860002
    LAMBIE, Bruce Donald
    Kenview
    Fitzroy Park Highgate
    N6 6HX London
    Geschäftsführer
    Kenview
    Fitzroy Park Highgate
    N6 6HX London
    United KingdomNew ZealanderCompany Director9019190001
    ALLSOPP, Nicholas James
    The Foxlands 2 Wolferton Close
    Upton
    L49 4GX Wirral
    Sekretär
    The Foxlands 2 Wolferton Close
    Upton
    L49 4GX Wirral
    British2400340001
    BIBBY BROS. & CO. (MANAGEMENT) LIMITED
    105 Duke Street
    L1 5JQ Liverpool
    Merseyside
    Sekretär
    105 Duke Street
    L1 5JQ Liverpool
    Merseyside
    153567030002
    BARNES, Arthur Rennie
    Bendera 3 The Knowe
    Willaston
    CH64 1TA Neston
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Bendera 3 The Knowe
    Willaston
    CH64 1TA Neston
    Cheshire
    BritishChartered Accountant71963280001
    BIBBY, Michael James, Sir
    Johnswood
    Margarets Lane, Childer Thornton
    CH66 5PF Ellesmere Port
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Johnswood
    Margarets Lane, Childer Thornton
    CH66 5PF Ellesmere Port
    Cheshire
    United KingdomBritishChartered Accountant26373310002
    DOWNING, Ian
    15 Marlborough Road
    Crosby
    L23 3DD Liverpool
    Geschäftsführer
    15 Marlborough Road
    Crosby
    L23 3DD Liverpool
    BritishAccountant42032680001
    FOX, Bruce William
    43a Fisher Street
    FOREIGN Bangowlah Heights
    New South Wales
    Australia
    Geschäftsführer
    43a Fisher Street
    FOREIGN Bangowlah Heights
    New South Wales
    Australia
    AustralianCompany Director34993330001
    HARDING, Peter Leslie
    Martlets Greenways
    Walton-On-The-Hill
    KT20 7QE Tadworth
    Surrey
    Geschäftsführer
    Martlets Greenways
    Walton-On-The-Hill
    KT20 7QE Tadworth
    Surrey
    BritishShipbroker8897950001
    HAYMER, Jonathan
    Ravenscar
    Alvanley Road
    WA6 9PS Helsby
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Ravenscar
    Alvanley Road
    WA6 9PS Helsby
    Cheshire
    EnglandBritishChartered Accountant1553510001
    OSBORNE, Jonathan
    54 Cambridge Road
    Crosby
    L23 7TZ Liverpool
    Geschäftsführer
    54 Cambridge Road
    Crosby
    L23 7TZ Liverpool
    BritishChartered Accountant61591800002
    SHERRARD, Simon Patrick
    The White House School Lane
    Bunbury
    CW6 9NX Tarporley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The White House School Lane
    Bunbury
    CW6 9NX Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director2073990001
    STERRETT, David John
    Fron Haul
    LL11 3AL Llandegla
    Clwyd North Wales
    Geschäftsführer
    Fron Haul
    LL11 3AL Llandegla
    Clwyd North Wales
    BritishCompany Director2074000001

    Hat BARTON (TRIBUTE) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Insurance assignment
    Erstellt am 08. Juni 2001
    Geliefert am 29. Juni 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All liabilities due or to become due from the owner (as defined) to the chargee under or by virtue of the guarantee (as defined) or any of the collateral documents (as defined)
    Kurze Angaben
    The charterer's insuarances and any right title or interest which the charterer may have in respect of any requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nib Capital Bank N.V.
    Transaktionen
    • 29. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Second preferred panamanian ship mortgage
    Erstellt am 23. Juni 1995
    Geliefert am 13. Juli 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the guarantees,this mortgage and the multi-party agreement (all as defined)
    Kurze Angaben
    The motor vessel "botany tribute" having international call sign H9NY and described in the patente of navigation no.10840-81-f the title of the vessel registered in the mercantile (marine) section of the public registry of panama and includes any share or interest therein and her engines,machinery,boats,tackle. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank
    Transaktionen
    • 13. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 23. Juni 1995
    Geliefert am 13. Juli 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the "mortgage" dated 23RD june 1995 and/or the other security documents as defined in this deed
    Kurze Angaben
    The earnings of M.T. "botany tribute". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank As
    Transaktionen
    • 13. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 23. Juni 1995
    Geliefert am 13. Juli 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All the liabilities of the comapny to the chargee under or in respect of a facility agreement dated 22ND june 1995, a swap agreement dated 1ST june 1995, a guarantee dated 23RD june 1995 and the floating charge on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the undertaking and other assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank As
    Transaktionen
    • 13. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Retention account assignment
    Erstellt am 25. Apr. 1994
    Geliefert am 13. Mai 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the loan agreement dated 21ST april 1994 and/or the "security documents" (as defined in the charge)
    Kurze Angaben
    All monies from time to time credited to, and for the time being standing to the credit of the "barton/tribute/triton/troubadour- retention account". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank
    Transaktionen
    • 13. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Collateral floating charge
    Erstellt am 25. Apr. 1994
    Geliefert am 13. Mai 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in respect of the guarantee, the first loan agreement dated 17TH january 1992, the second loan agreement dated 21ST april 1994 (all as defined therein) or this floating charge
    Kurze Angaben
    Undertaking and all its other assets belonging to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank As
    Transaktionen
    • 13. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 25. Apr. 1994
    Geliefert am 13. Mai 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in presepct of the loan agreement dated 21ST april 1994 (as defined therein) or this floating charge
    Kurze Angaben
    Undertaking and all its other assets belonging to the company.
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank As
    Transaktionen
    • 13. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Second preferred panamanian mortgage
    Erstellt am 25. Apr. 1994
    Geliefert am 13. Mai 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a guarantee dated 21ST june 1993, the security documents (as defined therein) or this mortgage
    Kurze Angaben
    The whole of the M.V. "botany tribute" having international call sign H9NY and more particularly described in the patent of navigation number 10840-81-e and includes her engines tackle and appurtenances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank As
    Transaktionen
    • 13. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    First preferred panamanian mortgage
    Erstellt am 25. Apr. 1994
    Geliefert am 13. Mai 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the loan agreement dated 21ST april 1994, the security documents (as defined therein) or this mortgage
    Kurze Angaben
    Thw whole of the M.V. "botany tribute" having international call sign H9NY and more particularly described in the patent of navigation number 10840-81-e and includes all engines tackle and appurtenances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank As
    Transaktionen
    • 13. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    First multi-party agreement
    Erstellt am 25. Apr. 1994
    Geliefert am 13. Mai 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the companies named therein to the chargee under the agreements and or all or any of the other documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All insurance and moneys arising out of the use or operation of M.V. "botany tribute". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank
    Transaktionen
    • 13. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Second multi-party agreement
    Erstellt am 25. Apr. 1994
    Geliefert am 13. Mai 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the agreements and any other documents (as defined in the charge)
    Kurze Angaben
    All insurances and monies arising out of the use or operation of M.V. "botany tribute". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank
    Transaktionen
    • 13. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Fourth multi party agreement
    Erstellt am 07. Juli 1993
    Geliefert am 09. Juli 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a guarantee dated 21 june 1993 a loan facility agreement dated 16 june 1993 and a funding agreement dated 21 june 1993
    Kurze Angaben
    The "earnings" being all moneys whatsoever due or to become due or for the account of the company arising out of the use or operation of M.t "botany tribute". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank As
    Transaktionen
    • 09. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Fourth preferred panamanian mortgage
    Erstellt am 21. Juni 1993
    Geliefert am 05. Juli 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due from barton (marinor) limited and bibby (marinor) limited to the chargee under the terms of a loan facility agreement dated 16.6.93
    Kurze Angaben
    The panamanian registered vessel "botany tribute".....all engines,machinery,boats....etc. See form 395.
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank Asks (As Defined)as Agent for and on Behalf of Itself and the Ban
    Transaktionen
    • 05. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 21. Juni 1993
    Geliefert am 05. Juli 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks (as defined) under the terms of the guarantee, the facility agreement and the charge (as defined)
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank As
    Transaktionen
    • 05. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Fourth multiparty agreement
    Erstellt am 29. Jan. 1992
    Geliefert am 19. Feb. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from norac limited and/or rumford tankers limited to the chargee under the "facility agreement" dated 28TH january 1992 or any other documents as defined
    Kurze Angaben
    The earnings in respect of "botany tribute" (the "ship") (see doc ref M87 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank Plcfinedacting on Behalf of Itself and the "Banks" as De
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 29. Jan. 1992
    Geliefert am 19. Feb. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 28TH january 1992 and all monies due or to become due from rumford tankers limited and norac limited to the chargee under the terms of a loan and guarantee facility agreement dated 28TH january 1992.
    Kurze Angaben
    The whole of the panamanian registered motor vessel "botany tribute" registered in the name of the company with patente of navigation number 10840-81-E. (see doc 395 reference M440C for full details).
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 29. Jan. 1992
    Geliefert am 19. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a guarantee dated 29TH january 1992 and all monies due or to become due from rumford tankers limited and norac limited to the chargee under the terms of a loan and guarantee facility agreement dated 28TH january 1992.
    Kurze Angaben
    All the company's undertaking and all its other assets. (See doc 395 reference M439C for full details).
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third multiparty agreement
    Erstellt am 17. Jan. 1992
    Geliefert am 07. Feb. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the companies named therein to the chargee under the agreements and any and all other documents as defined
    Kurze Angaben
    The earnings arising out of the use or operation of M.V. "botany tribute" (see doc ref M122 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Third preferred panamanian mortgage
    Erstellt am 17. Jan. 1992
    Geliefert am 07. Feb. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee of even date and all monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreements (as defined in the charge) and under any and all other documents (as therein defined)
    Kurze Angaben
    The whole of the panmanian registered motor vessel "botany tribute" navigation number 10840-81-e (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 17. Jan. 1992
    Geliefert am 07. Feb. 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreements (as defined in the charge) and under any and all other documents (as therein defined)
    Kurze Angaben
    All the undertaking and assets (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    New four party agreement
    Erstellt am 26. Juni 1991
    Geliefert am 15. Juli 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement dated 10/05/90 (as supplemented and amended by a supplemental agreement dated 26/6/91) being the loan of U.s $1,379,758.61 and under the security documents as defined.
    Kurze Angaben
    The "earnings" arising from the use or operation of M.V. "botany tribute" and insurances (see doc M172 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Oceanic Finance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 15. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    Tribute four party agreement
    Erstellt am 26. Juni 1991
    Geliefert am 09. Juli 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    U.s $3,209,169.85 and all other moneys due or to become due from the barton (tribute) limited to den norske bank PLC pursuant to a loan agreement dated 10/5/90 as supplemented by a supplemental agreement dated 26/06/91 and the other security documents as defined
    Kurze Angaben
    All monies due from the use or operation of the M.V. "botany tribute" (the vessel) under the bareboat charter dated 10/05/90 (see doc M795C for full details).
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    Four party agreement.
    Erstellt am 26. Juni 1991
    Geliefert am 09. Juli 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    U.s $3,847,870.14. and all other moneys due or to become due from barton shipping company limited to the chargee pursuant to a loan agreement dated 10TH may 1990 as supplemented by a supplemental agreement dated 26TH june 1991 and the other security documents (as defined).
    Kurze Angaben
    All moneys whatsoever due or to become due to the company at any time during the security period arising out of the use or operation of the M.V. "botany tribute" (see form 395. ref m 797C for full details).
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    Four part agreement
    Erstellt am 18. Mai 1990
    Geliefert am 08. Juni 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    U.s $3,847,870.14 and all other moneys due or to become due from salt shares limited to the chargee pursuant to the "loan agreement" dated 10/5/90 and the other security documents as defined
    Kurze Angaben
    All rights and interest in M.V. "botany tribute".
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juni 1990Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 11. Mai 1990
    Geliefert am 01. Juni 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee dated 10TH may 90. and this deed on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    One hundred one hundredth shares in the motor vessel named "botany tribute" (see form 395 ref m 715C for full details).
    Berechtigte Personen
    • Den Norske Bank PLC.
    Transaktionen
    • 01. Juni 1990Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0