WASTE RECOVERY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WASTE RECOVERY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02411841 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WASTE RECOVERY LIMITED?
- Behandlung und Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen (38210) / Wasserversorgung; Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft und Behebung von Umweltverschmutzungen
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich WASTE RECOVERY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Staverton Court Staverton GL51 0UX Cheltenham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WASTE RECOVERY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| WASTE RECYCLING LIMITED | 08. Aug. 1989 | 08. Aug. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WASTE RECOVERY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WASTE RECOVERY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 10 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Sept. 2023 | 9 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 3 Sidings Court White Rose Way Doncaster DN4 5NU England zum Staverton Court Staverton Cheltenham GL51 0UX am 20. Sept. 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park Northampton NN4 7RG zum 3 Sidings Court White Rose Way Doncaster DN4 5NU am 01. Apr. 2022 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Agustin Serrano Minchan als Geschäftsführer am 11. Feb. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Georgina Violet Crowhurst als Sekretär am 28. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 024118410010 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Miss Georgina Violet Crowhurst als Sekretär am 15. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2019 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Carol Jayne Nunn als Sekretär am 17. Mai 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 024118410010, erstellt am 18. Juni 2018 | 105 Seiten | MR01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 024118410009 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WASTE RECOVERY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTS-LLOPIS, Vicente Federico | Geschäftsführer | Staverton GL51 0UX Cheltenham Staverton Court | United Kingdom | Spanish | 147551840001 | |||||
| TAYLOR, Paul | Geschäftsführer | Staverton GL51 0UX Cheltenham Staverton Court | United Kingdom | British | 147757950001 | |||||
| BOLTON, Jonathan Mark | Sekretär | Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Northamptonshire | British | 15931960007 | ||||||
| BUNTON, Victoria | Sekretär | Ground Floor West 900 Pavilion Drive NN4 7RG Northampton Business Park Northampton | 164525630001 | |||||||
| CALDER, Samantha Jane | Sekretär | Cowslip Cottage Roade Hill Ashton NN7 2JH Northampton Northamptonshire | British | 75830790003 | ||||||
| CROWHURST, Georgina Violet | Sekretär | Ground Floor West 900 Pavilion Drive NN4 7RG Northampton Business Park Northampton | 263557120001 | |||||||
| DE FEO, Caterina | Sekretär | Pavilion Drive NN4 7RG Northampton Ground Floor West, 900 United Kingdom | Italian | 140556050001 | ||||||
| FAVIER TILSTON, Claire | Sekretär | Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Northamptonshire | British | 117647490002 | ||||||
| HARDMAN, Steven Neville | Sekretär | The Wing Jaggards House Jaggards Lane Neston SN13 9SF Corsham Wiltshire | British | 93743250001 | ||||||
| HARDMAN, Steven Neville | Sekretär | Merrywood Sion Hill BA1 2UL Bath Avon | British | 93743250004 | ||||||
| NUNN, Carol Jayne | Sekretär | Ground Floor West 900 Pavilion Drive NN4 7RG Northampton Business Park Northampton | 174531890001 | |||||||
| STUTELEY, Stephen Russell | Sekretär | 2 Oak Grove Barton Hill IP31 1TH Bury St Edmunds Suffolk | British | 60742960001 | ||||||
| WATERHOUSE, Alan | Sekretär | 2a Norwood Grove Birkenshaw BD11 2NP Bradford West Yorkshire | British | 24588340001 | ||||||
| BASTOW, Edward William | Geschäftsführer | Rose Cottage Nowton IP29 5NB Bury St. Edmunds Suffolk | United Kingdom | British | 85608360001 | |||||
| BURNS, Phillip Wesley | Geschäftsführer | Flat 15 12 Bourchier Street W1D 4HZ London | United Kingdom | British | 160550800001 | |||||
| CASSELLS, Leslie James Davidson | Geschäftsführer | Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Northamptonshire | British | 95347040005 | ||||||
| ELLIS, Christopher John | Geschäftsführer | 900 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Ground Floor West | United Kingdom | British | 132052980001 | |||||
| ETHERIDGE, Hugh Charles | Geschäftsführer | 5 Springfield Place BA1 5RA Bath Avon | United Kingdom | British | 1491130002 | |||||
| HARDMAN, Steven Neville | Geschäftsführer | Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Northamptonshire | British | 93743250006 | ||||||
| HUNTINGTON, John Michael | Geschäftsführer | Skelton Hall Skelton Lane Thorner LS14 1AE Leeds West Yorkshire | British | 102172280001 | ||||||
| KNOTT, Gordon Peter | Geschäftsführer | Duxrdun Dodds Road NR17 2HH Attleborough Norfolk | British | 74368950001 | ||||||
| MEREDITH, James Robert | Geschäftsführer | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Ground Floor West 900 Northamptonshire | British | 29339860005 | ||||||
| PRIOR, Ruth Catherine | Geschäftsführer | 56 Northchurch Road N1 4EJ London | United Kingdom | British | 92539490002 | |||||
| RACKHAM, Sheila Anne | Geschäftsführer | Manor Farm NR16 2RX Bridgham Norfolk | England | English | 56243630001 | |||||
| RACKHAM (SNR), Paul Anthony | Geschäftsführer | Manor Farm Bridgham NR16 2RX Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 74659430001 | |||||
| RACKHAM JNR, Paul Anthony | Geschäftsführer | 14 Hardwick Park Gardens IP33 2QU Bury St Edmunds Suffolk | British | 84636840002 | ||||||
| SANDY, Nigel Desmond Alexander | Geschäftsführer | 3 Collett Way BA11 2XN Frome Somerset | England | British | 6470660001 | |||||
| SERRANO MINCHAN, Agustin | Geschäftsführer | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7RG Northampton Ground Floor West, 900 United Kingdom | Spain | Spanish | 140598310001 | |||||
| SHEPPARD, Derrick Richard Adam, Reverend | Geschäftsführer | Orchard House Back Lane Garboldisham IP22 2SD Diss Norfolk | England | British | 54306660001 | |||||
| STEWART, Quentin Richard | Geschäftsführer | 62 Anchor Brew House Shad Thames SE1 2LY London | United Kingdom | British | 94880800002 | |||||
| STUTELEY, Stephen Russell | Geschäftsführer | 2 Oak Grove Barton Hill IP31 1TH Bury St Edmunds Suffolk | British | 60742960001 | ||||||
| TRENDELL, William Anthony | Geschäftsführer | Victorian Rendezvous 18 Rectory Close Merrow GU4 7AR Guildford Surrey | England | British | 12317760001 | |||||
| WALSH, Timothy Charles | Geschäftsführer | White House Farm The Street, Hindolveston NR20 5DF Dereham Norfolk | British | 106429250001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WASTE RECOVERY LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fcc Environment (Uk) Limited | 07. Apr. 2016 | 900 Pavilion Drive NN4 7RG Northampton Ground Floor West Northamptonshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat WASTE RECOVERY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 18. Juni 2018 Geliefert am 21. Juni 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The debenture dated 18 june 2018 between, amongst others, waste recovery limited and glas trustees limited creates fixed security over certain real property and intellectual property rights owned by waste recovery limited. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 22. Jan. 2014 Geliefert am 24. Jan. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 17. Dez. 2013 Geliefert am 20. Dez. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung F/H property k/a the thetford site located at burrell way thetford norfolk t/no NK103462. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 17. Dez. 2013 Geliefert am 20. Dez. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Account charge | Erstellt am 21. Dez. 2006 Geliefert am 05. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower and each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of floating charge all its present and future rights, title and interest to each cash account and all amounts credited to each cash account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Dez. 2004 Geliefert am 23. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the second secured creditors and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of second legal mortgage and second fixed charge the property (as defined in the form 395) by way of second fixed charge the investments, book debts, intellectual property, plant and machinery, contracts, pension funds, all its uncalled capital, all its goodwill and all its present and future rights and interests in respect of the relevant documents by way of second floating charge, its undertaking and all its assets both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Sept. 2003 Geliefert am 12. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Aug. 2003 Geliefert am 21. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of each obligor to the security agent and/or the finance parties and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage, the scheduled property other than (I) any leasehold restricted property, the aldeby restricted property or the cinergy properties, in relation to which the provisions of clause 3.15 shall apply (ii) the excluded properties, in relation to which the provisions of clause 3.16 of the debenture shall apply and (iii) any excluded gas assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 08. März 1990 Geliefert am 17. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Including heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 15. Jan. 1990 Geliefert am 17. Jan. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Inc all property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat WASTE RECOVERY LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0