WASTE RECOVERY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWASTE RECOVERY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02411841
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WASTE RECOVERY LIMITED?

    • Behandlung und Beseitigung von nicht gefährlichen Abfällen (38210) / Wasserversorgung; Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft und Behebung von Umweltverschmutzungen
    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich WASTE RECOVERY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Staverton Court
    Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WASTE RECOVERY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WASTE RECYCLING LIMITED08. Aug. 198908. Aug. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WASTE RECOVERY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für WASTE RECOVERY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    10 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Sept. 2023

    9 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3 Sidings Court White Rose Way Doncaster DN4 5NU England zum Staverton Court Staverton Cheltenham GL51 0UX am 20. Sept. 2022

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 08. Sept. 2022

    LRESSP

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Ground Floor West 900 Pavilion Drive Northampton Business Park Northampton NN4 7RG zum 3 Sidings Court White Rose Way Doncaster DN4 5NU am 01. Apr. 2022

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Agustin Serrano Minchan als Geschäftsführer am 11. Feb. 2022

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    17 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    18 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Georgina Violet Crowhurst als Sekretär am 28. Jan. 2020

    1 SeitenTM02

    Erfüllung der Belastung 024118410010 vollständig

    1 SeitenMR04

    Ernennung von Miss Georgina Violet Crowhurst als Sekretär am 15. Okt. 2019

    2 SeitenAP03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    21 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2019 mit Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Carol Jayne Nunn als Sekretär am 17. Mai 2019

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    20 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Eintragung der Belastung 024118410010, erstellt am 18. Juni 2018

    105 SeitenMR01

    Erfüllung der Belastung 024118410009 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    19 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von WASTE RECOVERY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ORTS-LLOPIS, Vicente Federico
    Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Staverton Court
    Geschäftsführer
    Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Staverton Court
    United KingdomSpanish147551840001
    TAYLOR, Paul
    Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Staverton Court
    Geschäftsführer
    Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Staverton Court
    United KingdomBritish147757950001
    BOLTON, Jonathan Mark
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British15931960007
    BUNTON, Victoria
    Ground Floor West
    900 Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton Business Park
    Northampton
    Sekretär
    Ground Floor West
    900 Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton Business Park
    Northampton
    164525630001
    CALDER, Samantha Jane
    Cowslip Cottage
    Roade Hill Ashton
    NN7 2JH Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    Cowslip Cottage
    Roade Hill Ashton
    NN7 2JH Northampton
    Northamptonshire
    British75830790003
    CROWHURST, Georgina Violet
    Ground Floor West
    900 Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton Business Park
    Northampton
    Sekretär
    Ground Floor West
    900 Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton Business Park
    Northampton
    263557120001
    DE FEO, Caterina
    Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West, 900
    United Kingdom
    Sekretär
    Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West, 900
    United Kingdom
    Italian140556050001
    FAVIER TILSTON, Claire
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British117647490002
    HARDMAN, Steven Neville
    The Wing Jaggards House
    Jaggards Lane Neston
    SN13 9SF Corsham
    Wiltshire
    Sekretär
    The Wing Jaggards House
    Jaggards Lane Neston
    SN13 9SF Corsham
    Wiltshire
    British93743250001
    HARDMAN, Steven Neville
    Merrywood
    Sion Hill
    BA1 2UL Bath
    Avon
    Sekretär
    Merrywood
    Sion Hill
    BA1 2UL Bath
    Avon
    British93743250004
    NUNN, Carol Jayne
    Ground Floor West
    900 Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton Business Park
    Northampton
    Sekretär
    Ground Floor West
    900 Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton Business Park
    Northampton
    174531890001
    STUTELEY, Stephen Russell
    2 Oak Grove
    Barton Hill
    IP31 1TH Bury St Edmunds
    Suffolk
    Sekretär
    2 Oak Grove
    Barton Hill
    IP31 1TH Bury St Edmunds
    Suffolk
    British60742960001
    WATERHOUSE, Alan
    2a Norwood Grove
    Birkenshaw
    BD11 2NP Bradford
    West Yorkshire
    Sekretär
    2a Norwood Grove
    Birkenshaw
    BD11 2NP Bradford
    West Yorkshire
    British24588340001
    BASTOW, Edward William
    Rose Cottage
    Nowton
    IP29 5NB Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Rose Cottage
    Nowton
    IP29 5NB Bury St. Edmunds
    Suffolk
    United KingdomBritish85608360001
    BURNS, Phillip Wesley
    Flat 15
    12 Bourchier Street
    W1D 4HZ London
    Geschäftsführer
    Flat 15
    12 Bourchier Street
    W1D 4HZ London
    United KingdomBritish160550800001
    CASSELLS, Leslie James Davidson
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British95347040005
    ELLIS, Christopher John
    900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West
    Geschäftsführer
    900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West
    United KingdomBritish132052980001
    ETHERIDGE, Hugh Charles
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    United KingdomBritish1491130002
    HARDMAN, Steven Neville
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British93743250006
    HUNTINGTON, John Michael
    Skelton Hall
    Skelton Lane Thorner
    LS14 1AE Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Skelton Hall
    Skelton Lane Thorner
    LS14 1AE Leeds
    West Yorkshire
    British102172280001
    KNOTT, Gordon Peter
    Duxrdun
    Dodds Road
    NR17 2HH Attleborough
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Duxrdun
    Dodds Road
    NR17 2HH Attleborough
    Norfolk
    British74368950001
    MEREDITH, James Robert
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West 900
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West 900
    Northamptonshire
    British29339860005
    PRIOR, Ruth Catherine
    56 Northchurch Road
    N1 4EJ London
    Geschäftsführer
    56 Northchurch Road
    N1 4EJ London
    United KingdomBritish92539490002
    RACKHAM, Sheila Anne
    Manor Farm
    NR16 2RX Bridgham
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Manor Farm
    NR16 2RX Bridgham
    Norfolk
    EnglandEnglish56243630001
    RACKHAM (SNR), Paul Anthony
    Manor Farm
    Bridgham
    NR16 2RX Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Manor Farm
    Bridgham
    NR16 2RX Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish74659430001
    RACKHAM JNR, Paul Anthony
    14 Hardwick Park Gardens
    IP33 2QU Bury St Edmunds
    Suffolk
    Geschäftsführer
    14 Hardwick Park Gardens
    IP33 2QU Bury St Edmunds
    Suffolk
    British84636840002
    SANDY, Nigel Desmond Alexander
    3 Collett Way
    BA11 2XN Frome
    Somerset
    Geschäftsführer
    3 Collett Way
    BA11 2XN Frome
    Somerset
    EnglandBritish6470660001
    SERRANO MINCHAN, Agustin
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West, 900
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West, 900
    United Kingdom
    SpainSpanish140598310001
    SHEPPARD, Derrick Richard Adam, Reverend
    Orchard House Back Lane
    Garboldisham
    IP22 2SD Diss
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Orchard House Back Lane
    Garboldisham
    IP22 2SD Diss
    Norfolk
    EnglandBritish54306660001
    STEWART, Quentin Richard
    62 Anchor Brew House
    Shad Thames
    SE1 2LY London
    Geschäftsführer
    62 Anchor Brew House
    Shad Thames
    SE1 2LY London
    United KingdomBritish94880800002
    STUTELEY, Stephen Russell
    2 Oak Grove
    Barton Hill
    IP31 1TH Bury St Edmunds
    Suffolk
    Geschäftsführer
    2 Oak Grove
    Barton Hill
    IP31 1TH Bury St Edmunds
    Suffolk
    British60742960001
    TRENDELL, William Anthony
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Victorian Rendezvous
    18 Rectory Close Merrow
    GU4 7AR Guildford
    Surrey
    EnglandBritish12317760001
    WALSH, Timothy Charles
    White House Farm
    The Street, Hindolveston
    NR20 5DF Dereham
    Norfolk
    Geschäftsführer
    White House Farm
    The Street, Hindolveston
    NR20 5DF Dereham
    Norfolk
    British106429250001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WASTE RECOVERY LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Fcc Environment (Uk) Limited
    900 Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West
    Northamptonshire
    England
    07. Apr. 2016
    900 Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West
    Northamptonshire
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House England & Wales
    Registrierungsnummer2902416
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat WASTE RECOVERY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 18. Juni 2018
    Geliefert am 21. Juni 2018
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    The debenture dated 18 june 2018 between, amongst others, waste recovery limited and glas trustees limited creates fixed security over certain real property and intellectual property rights owned by waste recovery limited.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Glas Trustees Limited
    Transaktionen
    • 21. Juni 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. Dez. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 22. Jan. 2014
    Geliefert am 24. Jan. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Glas Nominees Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 24. Jan. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 18. Juni 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 17. Dez. 2013
    Geliefert am 20. Dez. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    F/H property k/a the thetford site located at burrell way thetford norfolk t/no NK103462. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Glas Nominees Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 24. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 17. Dez. 2013
    Geliefert am 20. Dez. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Glas Nominees Limited
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 24. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Account charge
    Erstellt am 21. Dez. 2006
    Geliefert am 05. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower and each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of floating charge all its present and future rights, title and interest to each cash account and all amounts credited to each cash account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Banco Santander Central Hispano, S.A., London Branch as Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 15. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the second secured creditors and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of second legal mortgage and second fixed charge the property (as defined in the form 395) by way of second fixed charge the investments, book debts, intellectual property, plant and machinery, contracts, pension funds, all its uncalled capital, all its goodwill and all its present and future rights and interests in respect of the relevant documents by way of second floating charge, its undertaking and all its assets both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of New York as Second Secured Note Trustee (The "Second Secured Note Trustee")
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Sept. 2003
    Geliefert am 12. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As "Security Agent")
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Aug. 2003
    Geliefert am 21. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of each obligor to the security agent and/or the finance parties and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage, the scheduled property other than (I) any leasehold restricted property, the aldeby restricted property or the cinergy properties, in relation to which the provisions of clause 3.15 shall apply (ii) the excluded properties, in relation to which the provisions of clause 3.16 of the debenture shall apply and (iii) any excluded gas assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 08. März 1990
    Geliefert am 17. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 26. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 15. Jan. 1990
    Geliefert am 17. Jan. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Inc all property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WASTE RECOVERY LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Juli 2024Soll aufgelöst werden am
    08. Sept. 2022Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Peter Richard James Frost
    Staverton Court Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Gloucestershire
    Praktiker
    Staverton Court Staverton
    GL51 0UX Cheltenham
    Gloucestershire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0