CAPARO AUTOMOTIVE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCAPARO AUTOMOTIVE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02412684
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CAPARO AUTOMOTIVE LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich CAPARO AUTOMOTIVE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CAPARO AUTOMOTIVE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LAUNCHSURE PUBLIC LIMITED COMPANY10. Aug. 198910. Aug. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CAPARO AUTOMOTIVE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2004

    Welche sind die letzten Einreichungen für CAPARO AUTOMOTIVE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    1 Seiten405(2)

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 30. Juli 2009

    4 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 12. März 2009

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 12. März 2009

    3 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    Verschiedenes

    Form 3.2 - statement of affairs
    4 SeitenMISC

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    6 Seiten3.10

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten405(1)

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    28 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003

    28 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2002

    27 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2001

    25 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von CAPARO AUTOMOTIVE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BAILEY, Stephen Geoffrey
    Abbey Gardens
    ST18 0RY Great Haywood
    1
    Staffordshire
    Sekretär
    Abbey Gardens
    ST18 0RY Great Haywood
    1
    Staffordshire
    British108203800001
    DANCASTER, David Patrick
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    Geschäftsführer
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    EnglandBritish55380530001
    GARDNER, Norman Arthur
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    Sekretär
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    British61016230001
    MILWARD, Roy Edward
    63 Doles Lane
    Findern
    DE65 6BA Derby
    Derbyshire
    Sekretär
    63 Doles Lane
    Findern
    DE65 6BA Derby
    Derbyshire
    British114078580001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Sekretär
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    British56051330001
    STEELE, Colin Grant
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British10618480001
    DICKINSON, John Alan
    Monks Barn Maugersbury
    Stow On The Wold
    GL54 1HB Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Monks Barn Maugersbury
    Stow On The Wold
    GL54 1HB Cheltenham
    Gloucestershire
    British28823880003
    GARDNER, Norman Arthur
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    British61016230001
    HANNA, Richard Guy Crawford, Doctor
    The Tile House 26 Pound Lane
    Sonning On Thames
    RG4 6XE Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Tile House 26 Pound Lane
    Sonning On Thames
    RG4 6XE Reading
    Berkshire
    British12310490001
    LEEK, James Anthony
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    Geschäftsführer
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    British11293430001
    PAUL, Akash, The Honourable
    Ambkia House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 3
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ambkia House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 3
    United Kingdom
    United KingdomBritish49303360005
    PAUL, Ambar, The Honourable
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    United KingdomBritish92729600003
    PAUL, Angad, The Honorable
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    Geschäftsführer
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    United KingdomUnited Kingdom130813310001
    PAUL OF MARYLEBONE, The Lord
    6 Ambika House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    Geschäftsführer
    6 Ambika House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    EnglandBritish11293420003
    READ, James Allan
    30e Cadogan Square
    SW1X 0JH London
    Geschäftsführer
    30e Cadogan Square
    SW1X 0JH London
    American32172560001
    SHAW, Christopher Norman
    Castle Vale
    Castle Street, Raglan
    NP15 2DS Usk
    Gwent
    Geschäftsführer
    Castle Vale
    Castle Street, Raglan
    NP15 2DS Usk
    Gwent
    United KingdomBritish28831060001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritish56051330001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritish56051330001
    STEELE, Colin Grant
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish10618480001

    Hat CAPARO AUTOMOTIVE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 28. Nov. 2002
    Geliefert am 09. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Caparo Group Limited
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2006Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 1
    Debenture
    Erstellt am 31. Jan. 1996
    Geliefert am 01. Feb. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to the secured parties (as defined) or any of them under the finance documents (as defined) and all sums and liabilities under or in connection with the hedging arrangements
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia
    Transaktionen
    • 01. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Charge
    Erstellt am 08. Juni 1990
    Geliefert am 11. Juni 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent and trustee for itself and for the banks under the terms of a facility agreement dated 22.9.89 (as amended) or the charge or any other security document (as defined) and all moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of any hedging arrangement in connection with the facility agreement and any extensions or modification thereof
    Kurze Angaben
    All sums (including any interest earned thereon) for the time being standing to the credit of, and the benefit of the debt represented by, the account opened by the company with barclays bank PLC 15 colmore row, birmingham sort code 02-07-71 and designated "scotiabank re: arnstrong patents co. Limited", account no 60117978.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia
    Transaktionen
    • 11. Juni 1990Registrierung einer Belastung
    • 02. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 05. Dez. 1989
    Geliefert am 08. Dez. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the "bank") pursuant to an indemnity of even date given by the company to the bank in connection with an instrument dated 1/12/89 constituting guaranteed variable rate loan notes 1992, as may be varied and amended from time to time .
    Kurze Angaben
    All monies standing to the credit of an account or accounts with the royal bank of scotland PLC (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 08. Dez. 1989Registrierung einer Belastung
    • 01. Feb. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of deposit
    Erstellt am 01. Dez. 1989
    Geliefert am 11. Dez. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee acting for itself and as agent and trustee for the banks or to the banks or any of them under or in connection with the senior credit facility agreement dated 8/11/89 any agreement pursuant to a satisfication letter (as defined) or this debenture or any other security document and all monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any hedging arrangement made in connection with the senior credit facility agreement
    Kurze Angaben
    All interest, dividends bonus issues, distributions allotments, offers, benefits, rights, proceeds and entitlements attaching to shares in the capital of armstrong equipment PLC (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia
    Transaktionen
    • 11. Dez. 1989Registrierung einer Belastung
    • 02. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Dez. 1989
    Geliefert am 11. Dez. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee acting for itself and as agent and trustee for the banks or to the banks or any of them under the senior credit facility agreement d/d 8/11/89, any agreement pursuant to a substitution letter (as defined) or this debenture or any other security document and all monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any ledging arrangement made in connection with the senior credit facility agreement.
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill. Bookdebts (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Banks of Nova Scotia
    Transaktionen
    • 11. Dez. 1989Registrierung einer Belastung
    • 02. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Dez. 1989
    Geliefert am 11. Dez. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee acting for itself and as agent and trustee for the banks or to the banks or any of them under the terms of a facility agreement dated 14/9/89 or this debenture or any other security document.
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale therof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • First Britannia Mezzanine Capital B.V.
    Transaktionen
    • 11. Dez. 1989Registrierung einer Belastung
    • 02. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of deposit
    Erstellt am 08. Nov. 1989
    Geliefert am 27. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and in its capacity as agent and trustee for itself, any successor agent and the banks in connection with the facility agreement (as amended or supplemented from time to time) this deed or any other security document (as defined) as evidenced by a statutory declaration dated 4/12/89
    Kurze Angaben
    All interest dividends (cash or otherwise) bonus issues distributions, allotments offer by way of rights benefits and proceeds arising from or attaching to any of the shares (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 02. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Nov. 1989
    Geliefert am 27. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent & trustee for the banks (as defined in a facility agreement dated 8/11/89) or any of them under or in connection with the facility agreement, this debenture and the security documents
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1989Registrierung einer Belastung

    Hat CAPARO AUTOMOTIVE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    28. Nov. 2002Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Kingsway
    CF10 3PW Cardiff

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0