W DEB MVL PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameW DEB MVL PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 02412739
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von W DEB MVL PLC?

    • (6712) /

    Wo befindet sich W DEB MVL PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    9th Floor 100 Wood Street
    EC2V 7AN London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von W DEB MVL PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WILLIAMS DE BROE PLC25. Juni 199025. Juni 1990
    PLUSGILT PUBLIC LIMITED COMPANY 10. Aug. 198910. Aug. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von W DEB MVL PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2005

    Welche sind die letzten Einreichungen für W DEB MVL PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. März 2017

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2016

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2016

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2015

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2015

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2014

    5 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Rücktritt eines Liquidators

    1 Seiten4.33

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2010

    5 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 29-30 Cornhill London EC3V 3NF* am 07. Juli 2010

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2008

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2008

    5 Seiten4.68

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von W DEB MVL PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SNOW, Alexander Charles Wallace
    Kencot Manor
    Kencot
    GL7 3QU Lechlade
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Kencot Manor
    Kencot
    GL7 3QU Lechlade
    Gloucestershire
    EnglandBritish83328190003
    TROLL, Graeme Simon
    157 Old Nazeing Road
    EN10 6QT Broxbourne
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    157 Old Nazeing Road
    EN10 6QT Broxbourne
    Hertfordshire
    EnglandBritish142348400001
    WARBURTON, Richard Andrew
    Witheridge Hill House,
    Witheridge Hill Highmoor
    RG9 5PF Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Witheridge Hill House,
    Witheridge Hill Highmoor
    RG9 5PF Henley On Thames
    Oxfordshire
    British105992070001
    WHILEY, Clive Peter
    Little Orchard London Road
    IP2 0SS Ipswich
    Geschäftsführer
    Little Orchard London Road
    IP2 0SS Ipswich
    United KingdomBritish22310850003
    GORDON, Mark Thomas
    Brands Cottage
    Hedingham Road Wethersfield
    CM7 4EH Chelmsford
    Essex
    Sekretär
    Brands Cottage
    Hedingham Road Wethersfield
    CM7 4EH Chelmsford
    Essex
    British110288270001
    HEIGHAM, David John
    Hill House
    Nayland
    CO6 4JB Colchester
    Essex
    Sekretär
    Hill House
    Nayland
    CO6 4JB Colchester
    Essex
    British5585480002
    ACKROYD, David Edward
    Stanza 11 Birds Hill Road
    Oxshott
    KT22 0NJ Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Stanza 11 Birds Hill Road
    Oxshott
    KT22 0NJ Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish60107150001
    BACKHOUSE, Raymond Paul
    Manor Farm
    Bells Yew Green
    TN3 9BH Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    Manor Farm
    Bells Yew Green
    TN3 9BH Tunbridge Wells
    Kent
    British68280870001
    BAUDET, Jean Jacques
    Avenue De La Tanche 5,Box 5
    FOREIGN Brussels
    1160
    Belgium
    Geschäftsführer
    Avenue De La Tanche 5,Box 5
    FOREIGN Brussels
    1160
    Belgium
    Belgian105465070001
    CHARNOCK, Richard Anthony
    20 Multon Road
    SW18 3LH London
    Geschäftsführer
    20 Multon Road
    SW18 3LH London
    United KingdomBritish56576450001
    COLMANT, Bruno, Dr
    Windmo Lenlaan, 62
    Sterrebeek
    B-1233
    Belgium
    Geschäftsführer
    Windmo Lenlaan, 62
    Sterrebeek
    B-1233
    Belgium
    Belgian100735010001
    CURLING, David Antony Bryan
    Middle Oakshott Farm
    Hawkley
    GU33 6LP Liss
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Middle Oakshott Farm
    Hawkley
    GU33 6LP Liss
    Hampshire
    British5585490002
    DELL, Graeme John
    72 Mount Ararat Road
    TW10 6PN Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    72 Mount Ararat Road
    TW10 6PN Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish107996430001
    GACHOUD, Yves Auxence
    28 Lower Teddington Road
    Hampton Wick
    KT1 4HJ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    28 Lower Teddington Road
    Hampton Wick
    KT1 4HJ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Swiss5898980001
    GASTON, Michael Charles
    17 Corona Road
    Langdon Hill
    SS16 6HH Basildon
    Essex
    Geschäftsführer
    17 Corona Road
    Langdon Hill
    SS16 6HH Basildon
    Essex
    United KingdomBritish52658300001
    GRAHAM-WOOD, Malcolm David
    Little Chartham
    East Shalford Lane
    GU4 8AF Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Little Chartham
    East Shalford Lane
    GU4 8AF Guildford
    Surrey
    EnglandBritish68471000001
    GRAY, Jonathan James Mark Olav
    10 Queens Elm Square
    SW3 6ED London
    Geschäftsführer
    10 Queens Elm Square
    SW3 6ED London
    EnglandBritish92202430001
    LAMBRECHT, Thierry Paul
    3 Place Du Nouveau
    Marche Aux Grains
    1000 Brussels
    Belgium
    Belgium
    Geschäftsführer
    3 Place Du Nouveau
    Marche Aux Grains
    1000 Brussels
    Belgium
    Belgium
    Belgian50109850002
    LUSTY, Colin Edgar
    12 Ironstones
    Langton Green
    TN3 0YD Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    12 Ironstones
    Langton Green
    TN3 0YD Tunbridge Wells
    Kent
    Canadian25389540001
    MATHEWS, Christopher Donald
    24 Alwyn Avenue
    W4 4PB London
    Geschäftsführer
    24 Alwyn Avenue
    W4 4PB London
    Australian62327230002
    MELLY, Charles William
    3 Browns Coppice Avenue
    B91 1PL Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    3 Browns Coppice Avenue
    B91 1PL Solihull
    West Midlands
    British52658920002
    MILLAR, John Paterson
    66 Limerston Street
    SW10 0HJ London
    Geschäftsführer
    66 Limerston Street
    SW10 0HJ London
    British5898990002
    NALLY, John Joseph
    Flat 14 Tennyson Court
    11 Dorset Square
    NW1 6QB London
    Geschäftsführer
    Flat 14 Tennyson Court
    11 Dorset Square
    NW1 6QB London
    United KingdomBritish41763610003
    SIVASOTHY, Ramani
    7 Lyndhurst Gardens
    NW3 5NS London
    Geschäftsführer
    7 Lyndhurst Gardens
    NW3 5NS London
    United KingdomBritish27859100002
    SMITH, Eleanor
    13 Linhope Street
    NW1 6HT London
    Geschäftsführer
    13 Linhope Street
    NW1 6HT London
    British71933760001
    SMITH, Martin John
    45 Allestree Road
    SW6 6AD London
    Geschäftsführer
    45 Allestree Road
    SW6 6AD London
    British31587050002
    SPEARING, Nicholas Charles
    Segenhoe Manor
    Segenhoe, Ridgmont
    MK43 0XW Bedford
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Segenhoe Manor
    Segenhoe, Ridgmont
    MK43 0XW Bedford
    Bedfordshire
    British63725610001
    STANLEY, Peter Henry Arthur
    Cundall Hall
    Cundall
    YO6 2RP Helperby
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Cundall Hall
    Cundall
    YO6 2RP Helperby
    Yorkshire
    United KingdomBritish25918110003
    STRAET, Jean Pierre
    Avenue Armand Huysmans No 75 Bus 15
    FOREIGN Brussels
    1050
    Belgium
    Geschäftsführer
    Avenue Armand Huysmans No 75 Bus 15
    FOREIGN Brussels
    1050
    Belgium
    Belgian116110960001
    VANDEWALLE, Luc
    Gerard Davidstraat 20
    Marke (Kortrijk)
    8570
    Belgium
    Geschäftsführer
    Gerard Davidstraat 20
    Marke (Kortrijk)
    8570
    Belgium
    Belgian88209020001
    VERLODT, Gerrit
    8 Aria House
    5-15 Newton Street
    WC2B 5EN London
    Geschäftsführer
    8 Aria House
    5-15 Newton Street
    WC2B 5EN London
    Belgian104106630001
    WHISTANCE, David John
    4 Ardlui Road
    SE27 9HP London
    Geschäftsführer
    4 Ardlui Road
    SE27 9HP London
    British56178430002
    WOODIFIELD, Nicholas Robert
    The Cottage Main Street
    Charlton
    OX17 3DL Banbury
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Cottage Main Street
    Charlton
    OX17 3DL Banbury
    Oxfordshire
    British41796700001
    WORLLEDGE, Timothy John
    82 Home Park Road
    Wimbledon Park
    SW19 7HR London
    Geschäftsführer
    82 Home Park Road
    Wimbledon Park
    SW19 7HR London
    United KingdomBritish42548270001
    WRIGHT, Alfred William Fraser
    13 Cheyne Gardens
    SW3 5QT London
    Geschäftsführer
    13 Cheyne Gardens
    SW3 5QT London
    British1239120001

    Hat W DEB MVL PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security deed
    Erstellt am 02. Nov. 2004
    Geliefert am 05. Nov. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right, title and interest of the company to or in all money now or at any time hereafter standing to the credit of the controlled accounts, all right (including property rights) in all securities, by way of first floating charge all stock held by, or on behalf of or for the account of, the company in crest. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Security deed
    Erstellt am 30. Juni 2000
    Geliefert am 18. Juli 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever which arise in connection with the facility agreement (as defined) and/or the security deed or the making of any assured oayment with the bank for the account of the customer or any transfer of stock to the customer by means of crest (as defined)
    Kurze Angaben
    All sums and payments at the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by reason or in respect of any transfer or debit of or agreement to transfer or debit stock from any stock account of or in the name of or otherwise referable to the customer in crest. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental security deed (which is supplemental to a security deed dated 7 november 1997 (as amended by a further deed dated 30 december 1998))
    Erstellt am 20. Mai 1999
    Geliefert am 27. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the terms of this deed
    Kurze Angaben
    First fixed charge all sums, payments, money, interests, rights and remedies and first floating charge all stock money property and assets benefits interest rights and remedies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental security deed supplementing the provisions of the security deed dated 7TH november 1997
    Erstellt am 30. Dez. 1998
    Geliefert am 14. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    In addition to the controlled accounts the subject matter of the security deed, the supplemental security deed specifies an additional account as being a controlled account and amends the definition of "controlled accounts" the subject of a first fixed charge in the bank's favour to include any other such accounts which the company and the bank may agree in writing from time to time are to be treated as controlled accounts.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security deed
    Erstellt am 07. Nov. 1997
    Geliefert am 22. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges all sums and payments in respect of any transfer or debit or any agreement to trnasfer or debit stock from any eligible stock account in the cgo service or any transfer of any of its right title or interest to and in stock represented by any credit balance on any such eligible stock account in the cgo service and all right title and interest to and in all monies standing to the credit of the controlled accounts together with all rights relating thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Declaration of pledge of securities and claims
    Erstellt am 20. Okt. 1997
    Geliefert am 04. Nov. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations of the pledgor to the guarantor (a syndicate of banks whose lead bank is citibank N.A. and whose members as at the date of this certificate include banque bruxelles lambert S.A. banque generale du luxembourg S.A. banque internationale a luxembourg S.A. credit commercial de france kredietbank N.V. kredietbank S.A. luxemburgeoise union bank of switzerland and whose composition may periodically change) arising from its guarantee of the pledgor's borrowings of securities arranged under the cedel securities lending and borrowing rules and regulations of march 1997 as amended from time to time (the rules)
    Kurze Angaben
    All present and future securities bonds notes certificates of deposit instruments or rights representing property rights or claims and the balance from time to time of the cash account(s) and all currencies of the pledgor with cedel bank.
    Berechtigte Personen
    • The Guarantor (See Form 395)
    Transaktionen
    • 04. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    A charge in favour of the international stock exchange of the united kingdom and the republic of ireland limited
    Erstellt am 10. Mai 1994
    Geliefert am 13. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All shares,stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities which are from time to time registered in the name of or comprised in a transfer in favour of any stock exchange nominee company or held by or delivered for transfer to any agent or depositary to the order of the stock exchange. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland Limited
    Transaktionen
    • 13. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 17. Jan. 1994
    Geliefert am 25. Jan. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether before or after the service of a default notice) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all sums now and from time to time receivable by the company floating charge over all the right title and interest of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 16. Sept. 1991
    Geliefert am 23. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge all sums now and from time to time receivable by the company or any nominee of the company by reason or in respect of any transfer or debit of stock or other securities from any stock account at the cgo in the name of the company floating charge the stock and other securities of any kind. (Please see M395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    • 20. Juli 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Collateral agreement governing secured borrowing by participants in the euroclear system
    Erstellt am 16. Sept. 1991
    Geliefert am 19. Sept. 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee relating to or resulting from the borrowers use of the euroclear system on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All 'collateral' (as defined) (please see M395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transaktionen
    • 19. Sept. 1991Registrierung einer Belastung

    Hat W DEB MVL PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. Apr. 2007Beginn der Liquidation
    26. Juli 2017Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Timothy Gerard Walsh
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praktiker
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Richard Victor Yerburgh Setchim
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0