W DEB MVL PLC
Überblick
| Unternehmensname | W DEB MVL PLC |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Unternehmensnummer | 02412739 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von W DEB MVL PLC?
- (6712) /
Wo befindet sich W DEB MVL PLC?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 9th Floor 100 Wood Street EC2V 7AN London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von W DEB MVL PLC?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| WILLIAMS DE BROE PLC | 25. Juni 1990 | 25. Juni 1990 |
| PLUSGILT PUBLIC LIMITED COMPANY | 10. Aug. 1989 | 10. Aug. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von W DEB MVL PLC?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2005 |
Welche sind die letzten Einreichungen für W DEB MVL PLC?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. März 2017 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2016 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2016 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2015 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2015 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2014 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||
Rücktritt eines Liquidators | 1 Seiten | 4.33 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2014 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2013 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2013 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2012 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2012 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2010 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 29-30 Cornhill London EC3V 3NF* am 07. Juli 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2010 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2009 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Apr. 2009 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2008 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Okt. 2008 | 5 Seiten | 4.68 | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Wer sind die Geschäftsführer von W DEB MVL PLC?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOW, Alexander Charles Wallace | Geschäftsführer | Kencot Manor Kencot GL7 3QU Lechlade Gloucestershire | England | British | 83328190003 | |||||
| TROLL, Graeme Simon | Geschäftsführer | 157 Old Nazeing Road EN10 6QT Broxbourne Hertfordshire | England | British | 142348400001 | |||||
| WARBURTON, Richard Andrew | Geschäftsführer | Witheridge Hill House, Witheridge Hill Highmoor RG9 5PF Henley On Thames Oxfordshire | British | 105992070001 | ||||||
| WHILEY, Clive Peter | Geschäftsführer | Little Orchard London Road IP2 0SS Ipswich | United Kingdom | British | 22310850003 | |||||
| GORDON, Mark Thomas | Sekretär | Brands Cottage Hedingham Road Wethersfield CM7 4EH Chelmsford Essex | British | 110288270001 | ||||||
| HEIGHAM, David John | Sekretär | Hill House Nayland CO6 4JB Colchester Essex | British | 5585480002 | ||||||
| ACKROYD, David Edward | Geschäftsführer | Stanza 11 Birds Hill Road Oxshott KT22 0NJ Leatherhead Surrey | England | British | 60107150001 | |||||
| BACKHOUSE, Raymond Paul | Geschäftsführer | Manor Farm Bells Yew Green TN3 9BH Tunbridge Wells Kent | British | 68280870001 | ||||||
| BAUDET, Jean Jacques | Geschäftsführer | Avenue De La Tanche 5,Box 5 FOREIGN Brussels 1160 Belgium | Belgian | 105465070001 | ||||||
| CHARNOCK, Richard Anthony | Geschäftsführer | 20 Multon Road SW18 3LH London | United Kingdom | British | 56576450001 | |||||
| COLMANT, Bruno, Dr | Geschäftsführer | Windmo Lenlaan, 62 Sterrebeek B-1233 Belgium | Belgian | 100735010001 | ||||||
| CURLING, David Antony Bryan | Geschäftsführer | Middle Oakshott Farm Hawkley GU33 6LP Liss Hampshire | British | 5585490002 | ||||||
| DELL, Graeme John | Geschäftsführer | 72 Mount Ararat Road TW10 6PN Richmond Surrey | United Kingdom | British | 107996430001 | |||||
| GACHOUD, Yves Auxence | Geschäftsführer | 28 Lower Teddington Road Hampton Wick KT1 4HJ Kingston Upon Thames Surrey | Swiss | 5898980001 | ||||||
| GASTON, Michael Charles | Geschäftsführer | 17 Corona Road Langdon Hill SS16 6HH Basildon Essex | United Kingdom | British | 52658300001 | |||||
| GRAHAM-WOOD, Malcolm David | Geschäftsführer | Little Chartham East Shalford Lane GU4 8AF Guildford Surrey | England | British | 68471000001 | |||||
| GRAY, Jonathan James Mark Olav | Geschäftsführer | 10 Queens Elm Square SW3 6ED London | England | British | 92202430001 | |||||
| LAMBRECHT, Thierry Paul | Geschäftsführer | 3 Place Du Nouveau Marche Aux Grains 1000 Brussels Belgium Belgium | Belgian | 50109850002 | ||||||
| LUSTY, Colin Edgar | Geschäftsführer | 12 Ironstones Langton Green TN3 0YD Tunbridge Wells Kent | Canadian | 25389540001 | ||||||
| MATHEWS, Christopher Donald | Geschäftsführer | 24 Alwyn Avenue W4 4PB London | Australian | 62327230002 | ||||||
| MELLY, Charles William | Geschäftsführer | 3 Browns Coppice Avenue B91 1PL Solihull West Midlands | British | 52658920002 | ||||||
| MILLAR, John Paterson | Geschäftsführer | 66 Limerston Street SW10 0HJ London | British | 5898990002 | ||||||
| NALLY, John Joseph | Geschäftsführer | Flat 14 Tennyson Court 11 Dorset Square NW1 6QB London | United Kingdom | British | 41763610003 | |||||
| SIVASOTHY, Ramani | Geschäftsführer | 7 Lyndhurst Gardens NW3 5NS London | United Kingdom | British | 27859100002 | |||||
| SMITH, Eleanor | Geschäftsführer | 13 Linhope Street NW1 6HT London | British | 71933760001 | ||||||
| SMITH, Martin John | Geschäftsführer | 45 Allestree Road SW6 6AD London | British | 31587050002 | ||||||
| SPEARING, Nicholas Charles | Geschäftsführer | Segenhoe Manor Segenhoe, Ridgmont MK43 0XW Bedford Bedfordshire | British | 63725610001 | ||||||
| STANLEY, Peter Henry Arthur | Geschäftsführer | Cundall Hall Cundall YO6 2RP Helperby Yorkshire | United Kingdom | British | 25918110003 | |||||
| STRAET, Jean Pierre | Geschäftsführer | Avenue Armand Huysmans No 75 Bus 15 FOREIGN Brussels 1050 Belgium | Belgian | 116110960001 | ||||||
| VANDEWALLE, Luc | Geschäftsführer | Gerard Davidstraat 20 Marke (Kortrijk) 8570 Belgium | Belgian | 88209020001 | ||||||
| VERLODT, Gerrit | Geschäftsführer | 8 Aria House 5-15 Newton Street WC2B 5EN London | Belgian | 104106630001 | ||||||
| WHISTANCE, David John | Geschäftsführer | 4 Ardlui Road SE27 9HP London | British | 56178430002 | ||||||
| WOODIFIELD, Nicholas Robert | Geschäftsführer | The Cottage Main Street Charlton OX17 3DL Banbury Oxfordshire | British | 41796700001 | ||||||
| WORLLEDGE, Timothy John | Geschäftsführer | 82 Home Park Road Wimbledon Park SW19 7HR London | United Kingdom | British | 42548270001 | |||||
| WRIGHT, Alfred William Fraser | Geschäftsführer | 13 Cheyne Gardens SW3 5QT London | British | 1239120001 |
Hat W DEB MVL PLC Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security deed | Erstellt am 02. Nov. 2004 Geliefert am 05. Nov. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right, title and interest of the company to or in all money now or at any time hereafter standing to the credit of the controlled accounts, all right (including property rights) in all securities, by way of first floating charge all stock held by, or on behalf of or for the account of, the company in crest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security deed | Erstellt am 30. Juni 2000 Geliefert am 18. Juli 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever which arise in connection with the facility agreement (as defined) and/or the security deed or the making of any assured oayment with the bank for the account of the customer or any transfer of stock to the customer by means of crest (as defined) | |
Kurze Angaben All sums and payments at the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by reason or in respect of any transfer or debit of or agreement to transfer or debit stock from any stock account of or in the name of or otherwise referable to the customer in crest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental security deed (which is supplemental to a security deed dated 7 november 1997 (as amended by a further deed dated 30 december 1998)) | Erstellt am 20. Mai 1999 Geliefert am 27. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the terms of this deed | |
Kurze Angaben First fixed charge all sums, payments, money, interests, rights and remedies and first floating charge all stock money property and assets benefits interest rights and remedies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental security deed supplementing the provisions of the security deed dated 7TH november 1997 | Erstellt am 30. Dez. 1998 Geliefert am 14. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben In addition to the controlled accounts the subject matter of the security deed, the supplemental security deed specifies an additional account as being a controlled account and amends the definition of "controlled accounts" the subject of a first fixed charge in the bank's favour to include any other such accounts which the company and the bank may agree in writing from time to time are to be treated as controlled accounts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security deed | Erstellt am 07. Nov. 1997 Geliefert am 22. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges all sums and payments in respect of any transfer or debit or any agreement to trnasfer or debit stock from any eligible stock account in the cgo service or any transfer of any of its right title or interest to and in stock represented by any credit balance on any such eligible stock account in the cgo service and all right title and interest to and in all monies standing to the credit of the controlled accounts together with all rights relating thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Declaration of pledge of securities and claims | Erstellt am 20. Okt. 1997 Geliefert am 04. Nov. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All present and future obligations of the pledgor to the guarantor (a syndicate of banks whose lead bank is citibank N.A. and whose members as at the date of this certificate include banque bruxelles lambert S.A. banque generale du luxembourg S.A. banque internationale a luxembourg S.A. credit commercial de france kredietbank N.V. kredietbank S.A. luxemburgeoise union bank of switzerland and whose composition may periodically change) arising from its guarantee of the pledgor's borrowings of securities arranged under the cedel securities lending and borrowing rules and regulations of march 1997 as amended from time to time (the rules) | |
Kurze Angaben All present and future securities bonds notes certificates of deposit instruments or rights representing property rights or claims and the balance from time to time of the cash account(s) and all currencies of the pledgor with cedel bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A charge in favour of the international stock exchange of the united kingdom and the republic of ireland limited | Erstellt am 10. Mai 1994 Geliefert am 13. Mai 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All shares,stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities which are from time to time registered in the name of or comprised in a transfer in favour of any stock exchange nominee company or held by or delivered for transfer to any agent or depositary to the order of the stock exchange. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 17. Jan. 1994 Geliefert am 25. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (whether before or after the service of a default notice) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all sums now and from time to time receivable by the company floating charge over all the right title and interest of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 16. Sept. 1991 Geliefert am 23. Sept. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge all sums now and from time to time receivable by the company or any nominee of the company by reason or in respect of any transfer or debit of stock or other securities from any stock account at the cgo in the name of the company floating charge the stock and other securities of any kind. (Please see M395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral agreement governing secured borrowing by participants in the euroclear system | Erstellt am 16. Sept. 1991 Geliefert am 19. Sept. 1991 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee relating to or resulting from the borrowers use of the euroclear system on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All 'collateral' (as defined) (please see M395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat W DEB MVL PLC Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0