PRECIS (928) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PRECIS (928) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02413328 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PRECIS (928) LIMITED?
- Kombinierte Büroverwaltungsdienste (82110) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich PRECIS (928) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o GRANT THORNTON LLP 4 Hardman Square M3 3EB Spinningfields Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PRECIS (928) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 01. Okt. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PRECIS (928) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 21 Seiten | 4.72 | ||||||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Potton House Great North Road Wyboston Bedford MK44 3BA United Kingdom am 07. Dez. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 6 Seiten | 4.20 | ||||||||||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Leisure Connection Ltd Potton House Great North Road Wyboston Bedford MK44 3BA United Kingdom am 21. Sept. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Low Lane Horsforth Leeds West Yorkshire LS18 4ER am 03. Aug. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Okt. 2011 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Okt. 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Derek Lloyd als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Ernennung von Mr Julian Frederick Nicholls als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Ernennung von Mr Richard Matthew Still als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Meehan als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Sept. 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2008 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 9 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
legacy | 9 Seiten | 155(6)b | ||||||||||||||||||||||
legacy | 13 Seiten | 155(6)b | ||||||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PRECIS (928) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STILL, Richard Matthew | Sekretär | 4 Southway Guiseley LS20 8HX Leeds West Yorkshire | British | 71581460002 | ||||||
| NICHOLLS, Julian Frederick | Geschäftsführer | c/o Danoptra Limited Low Lane Horsforth LS18 4ER Leeds West Yorkshire | England | British | 95086050001 | |||||
| STILL, Richard Matthew | Geschäftsführer | Low Lane Horsforth LS18 4ER Leeds Danoptra Limited West Yorkshire | United Kingdom | British | 71581460002 | |||||
| JONES, John Graham | Sekretär | Lowick House 41 Creskeld Lane Bramhope LS16 9EP Leeds West Yorkshire | British | 35569170001 | ||||||
| PARSONS, Keith Rowland | Sekretär | 19 Beaumont Close Keyworth NG12 5JJ Nottingham Nottinghamshire | British | 3472170001 | ||||||
| BROCKMANN, Juergen | Geschäftsführer | Immengarten 26 32312 Luebecke Germany | German | 51257760001 | ||||||
| DANIELS, Colin | Geschäftsführer | Brooklands 313 Batley Road WF2 0AP Wakefield West Yorkshire | British | 1278190001 | ||||||
| GAUSELMANN, Michael | Geschäftsführer | Frotheimer Weg 54 Espelkamp 32339 Germany | German | 51256970001 | ||||||
| HEALEY, Keith Stanley | Geschäftsführer | 5 Smythson Drive Wollaton Village NG8 2NW Nottingham | British | 89750880001 | ||||||
| JONES, John Graham | Geschäftsführer | Lowick House 41 Creskeld Lane Bramhope LS16 9EP Leeds West Yorkshire | British | 35569170001 | ||||||
| LLOYD, Derek Thomas | Geschäftsführer | 55 Westerdale Drive Banks PR9 8DG Southport Merseyside | England | English | 98695040001 | |||||
| MEEHAN, Paul Alan | Geschäftsführer | House, Park Farm Newton Hall Lane Mobberley WA16 7LQ Knutsford The Farm Cheshire United Kingdom | England | British | 130608590001 | |||||
| PARSONS, Keith Rowland | Geschäftsführer | 19 Beaumont Close Keyworth NG12 5JJ Nottingham Nottinghamshire | British | 3472170001 | ||||||
| SMITH, Russell Stansfield | Geschäftsführer | 64 Riverside Court Victoria Road BD18 3LZ Shipley Saltaire | British | 809230004 | ||||||
| WALTERS, Philip Donald | Geschäftsführer | Hartley Place Thackhams Lane RG27 8HT Hartley Witney Hampshire | United Kingdom | British | 78370620003 | |||||
| WUSEKE, Ulrich | Geschäftsführer | Maile Harder Weg 26 Hamburg D 22399 Germany | German | 61949880001 | ||||||
| DANOPTRA DIRECTOR I LIMITED | Geschäftsführer | Low Lane Horsforth LS18 4ER Leeds Yorkshire | 125899680001 | |||||||
| DANOPTRA DIRECTOR II LIMITED | Geschäftsführer | Low Lane Horsforth LS18 4ER Leeds Yorkshire | 125899730001 | |||||||
| DANOPTRA DIRECTOR II LIMITED | Geschäftsführer | Low Lane LS18 4ER Horsforth Yorkshire | 125899730001 |
Hat PRECIS (928) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debentures | Erstellt am 19. Aug. 2008 Geliefert am 21. Aug. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second supplemental deed to a composite guarantee and debenture | Erstellt am 01. Feb. 2005 Geliefert am 10. Feb. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company to the security trustee and/or the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 26. Apr. 2002 Geliefert am 10. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 21. Okt. 1994 Geliefert am 01. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 31. Okt. 1989 Geliefert am 11. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from bfm holdings limited and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of this charge. | |
Kurze Angaben (See doc M809C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat PRECIS (928) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0