MARQUIS FILMS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMARQUIS FILMS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02413664
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MARQUIS FILMS LIMITED?

    • Filmproduktionsaktivitäten (59111) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich MARQUIS FILMS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    14 Arterial Avenue
    RM13 9NX Rainham
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MARQUIS FILMS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TANGOMERE LIMITED16. Aug. 198916. Aug. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MARQUIS FILMS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für MARQUIS FILMS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Ernennung von Mr Mark Fisher als Direktor am 02. Feb. 2023

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mark Fisher als Sekretär am 30. Dez. 2022

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Mark Fisher als Geschäftsführer am 30. Dez. 2022

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von William George Hinshelwood als Geschäftsführer am 30. Dez. 2022

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Aug. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Aug. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Withdrawal of a person with significant control statement on 05. Mai 2021

    2 SeitenPSC09

    Notification of Winv Wide Llc as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    1 SeitenPSC02

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2020 bis 31. Dez. 2020

    1 SeitenAA01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2019

    2 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Vicki Christianson als Geschäftsführer am 07. März 2020

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Mark Fisher als Direktor am 07. März 2020

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2018

    2 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O C/O Mark Fisher Flat 1, the Hollies St. Marys Lane Upminster Essex RM14 2QJ zum 14 Arterial Avenue Rainham RM13 9NX am 19. Dez. 2018

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2017

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2016

    8 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von MARQUIS FILMS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FISHER, Mark
    Arterial Avenue
    RM13 9NX Rainham
    14
    Essex
    England
    Geschäftsführer
    Arterial Avenue
    RM13 9NX Rainham
    14
    Essex
    England
    EnglandBritishAccountant267889710001
    FISHER, Mark
    Arterial Avenue
    RM13 9NX Rainham
    14
    England
    Sekretär
    Arterial Avenue
    RM13 9NX Rainham
    14
    England
    171174850001
    HINSHELWOOD, William George
    Witnesham Hall
    IP6 9JD Witnesham
    Suffolk
    Sekretär
    Witnesham Hall
    IP6 9JD Witnesham
    Suffolk
    British36026700001
    RYMER, Philip Graham
    Etheldene Avenue
    Muswell Hill
    N10 3QH London
    50
    Sekretär
    Etheldene Avenue
    Muswell Hill
    N10 3QH London
    50
    British137514930001
    MH SECRETARIES LIMITED
    Staple Court 11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Sekretär
    Staple Court 11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    123667200001
    BRADLEY, Jo Ann
    151a Longcroft Road
    Conifers
    S18 5SW Sheffield
    Geschäftsführer
    151a Longcroft Road
    Conifers
    S18 5SW Sheffield
    BritishMarketing & Development44824710001
    CHRISTIANSON, Vicki
    638 S Rossmore Ave
    FOREIGN Los Angeles
    California 90005
    United States
    Geschäftsführer
    638 S Rossmore Ave
    FOREIGN Los Angeles
    California 90005
    United States
    United StatesAmericanCoo102005790002
    DAVEY, Bruce Edwin Elwyn
    Wilshire Blvd
    Fourth Floor
    90401 Santa Monica
    808
    California
    Usa
    Geschäftsführer
    Wilshire Blvd
    Fourth Floor
    90401 Santa Monica
    808
    California
    Usa
    United StatesAustralianFilm Producer104727180001
    FISHER, Mark
    Arterial Avenue
    RM13 9NX Rainham
    14
    England
    Geschäftsführer
    Arterial Avenue
    RM13 9NX Rainham
    14
    England
    EnglandBritishAccountant267889710001
    HILL, Nicholas James
    23 Lambolle Place
    NW6 4PG London
    Geschäftsführer
    23 Lambolle Place
    NW6 4PG London
    BritishManaging Director87663590001
    HINSHELWOOD, William George
    Witnesham Hall
    IP6 9JD Witnesham
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Witnesham Hall
    IP6 9JD Witnesham
    Suffolk
    United KingdomBritishSolicitor36026700001
    KAMP, Ralph Michael
    20 A The Ridgeway
    Cuffley
    EN6 4AR Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    20 A The Ridgeway
    Cuffley
    EN6 4AR Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChief Executive60794430001
    LEMLEY, James
    50 Courtfield Gardens
    Flat 2
    SW5 0ND London
    Geschäftsführer
    50 Courtfield Gardens
    Flat 2
    SW5 0ND London
    AmericanCeo78406620001
    MAYSON, Andrew Graham
    Edwins Hall Edwins Hall Road
    Woodham Ferrers
    CM3 8RX Chelmsford
    Essex
    Geschäftsführer
    Edwins Hall Edwins Hall Road
    Woodham Ferrers
    CM3 8RX Chelmsford
    Essex
    EnglandBritishChief Operating Officer166543040001
    NORRIS, David John
    5 Wood Drive
    BR7 5EU Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    5 Wood Drive
    BR7 5EU Chislehurst
    Kent
    United KingdomBritishSolicitor43802550001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MARQUIS FILMS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Winv Wide Llc
    Wilshire Blvd
    Suite 400
    Santa Monica
    808
    Los Angeles
    United States
    06. Apr. 2016
    Wilshire Blvd
    Suite 400
    Santa Monica
    808
    Los Angeles
    United States
    Nein
    RechtsformLimited Liability Corporation
    RechtsgrundlageLimited Liability Corporation
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für MARQUIS FILMS LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    01. Sept. 201630. Dez. 2020Das Unternehmen hat eine registrierungspflichtige Person in Bezug auf das Unternehmen identifiziert, jedoch wurden nicht alle erforderlichen Angaben zu dieser Person bestätigt.

    Hat MARQUIS FILMS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge and deed of assignment
    Erstellt am 21. Mai 1999
    Geliefert am 02. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums owing or payable to newmarket capital group L.L.C.pursuant to the loan agreement
    Kurze Angaben
    By way of fixed and floating charge all that the chargor's right title and interest (whether now owned or hereafter acquired) excepting only the sv copyright interest throughout the territory in favour of the bank,in and to:- (a) all copies made or to be made of the film and of any such other films and sound recordings as are mentioned in clause 4.2 of the charge.(b) all sums relating to or derived from the film and from time to time standing to the credit of the chargor in any bank account.(c) all other rights and properties,including but not limited to physical properties acquired.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Newmarket Capital Group L.L.C.
    Transaktionen
    • 02. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge and deed of assignment
    Erstellt am 09. Okt. 1998
    Geliefert am 14. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from icon distribution llc to the chargee under deed of assignment
    Kurze Angaben
    By way of first fixed and floating all copies made or to be made of the film entitled 'felicia's journey' all sums relating to or derived from the film all other rights and properties the proceeds of any. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Newmarket Capital Group Llc
    Transaktionen
    • 14. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Apr. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge and security assignment
    Erstellt am 15. Mai 1996
    Geliefert am 24. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the producer's agreement and the performance of all representations,warranties,agreements,covenants and obligations under the producers agreement
    Kurze Angaben
    In relation to the film all preprints elements capable of producing prints all positive prints all soundtrack elements the copyright of the film,the misic and compositions including the lyrics and all distribution and other rights relating to the film and by way of floating charge all the undertaking assets and rights of the company.
    Berechtigte Personen
    • International Film Guarantors L.P.
    • Firemans Fund Insurance Company
    Transaktionen
    • 24. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Agreement and charge
    Erstellt am 24. Mai 1990
    Geliefert am 07. Juni 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums which completion bond company inc. May be required to pay under the terms of a completion guarantee for the film "hamlet" and under the agreement and charge
    Kurze Angaben
    The entire copyright throughout the world in the film "hamlet" and the approved screenplay for the film and any cinematograph films and sound recordings made in the course of the production of thefilm. (See form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Completion Bond Company Inc.
    Transaktionen
    • 07. Juni 1990Registrierung einer Belastung
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0