MARQUIS FILMS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MARQUIS FILMS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02413664 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MARQUIS FILMS LIMITED?
- Filmproduktionsaktivitäten (59111) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich MARQUIS FILMS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 14 Arterial Avenue RM13 9NX Rainham England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MARQUIS FILMS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
TANGOMERE LIMITED | 16. Aug. 1989 | 16. Aug. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MARQUIS FILMS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MARQUIS FILMS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Ernennung von Mr Mark Fisher als Direktor am 02. Feb. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Mark Fisher als Sekretär am 30. Dez. 2022 | 1 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von Mark Fisher als Geschäftsführer am 30. Dez. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von William George Hinshelwood als Geschäftsführer am 30. Dez. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Aug. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Aug. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Withdrawal of a person with significant control statement on 05. Mai 2021 | 2 Seiten | PSC09 | ||
Notification of Winv Wide Llc as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC02 | ||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2020 bis 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | AA01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 2 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Vicki Christianson als Geschäftsführer am 07. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Mark Fisher als Direktor am 07. März 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 2 Seiten | AA | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O C/O Mark Fisher Flat 1, the Hollies St. Marys Lane Upminster Essex RM14 2QJ zum 14 Arterial Avenue Rainham RM13 9NX am 19. Dez. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 8 Seiten | AA | ||
Wer sind die Geschäftsführer von MARQUIS FILMS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISHER, Mark | Geschäftsführer | Arterial Avenue RM13 9NX Rainham 14 Essex England | England | British | Accountant | 267889710001 | ||||
FISHER, Mark | Sekretär | Arterial Avenue RM13 9NX Rainham 14 England | 171174850001 | |||||||
HINSHELWOOD, William George | Sekretär | Witnesham Hall IP6 9JD Witnesham Suffolk | British | 36026700001 | ||||||
RYMER, Philip Graham | Sekretär | Etheldene Avenue Muswell Hill N10 3QH London 50 | British | 137514930001 | ||||||
MH SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Staple Court 11 Staple Inn Buildings WC1V 7QH London | 123667200001 | |||||||
BRADLEY, Jo Ann | Geschäftsführer | 151a Longcroft Road Conifers S18 5SW Sheffield | British | Marketing & Development | 44824710001 | |||||
CHRISTIANSON, Vicki | Geschäftsführer | 638 S Rossmore Ave FOREIGN Los Angeles California 90005 United States | United States | American | Coo | 102005790002 | ||||
DAVEY, Bruce Edwin Elwyn | Geschäftsführer | Wilshire Blvd Fourth Floor 90401 Santa Monica 808 California Usa | United States | Australian | Film Producer | 104727180001 | ||||
FISHER, Mark | Geschäftsführer | Arterial Avenue RM13 9NX Rainham 14 England | England | British | Accountant | 267889710001 | ||||
HILL, Nicholas James | Geschäftsführer | 23 Lambolle Place NW6 4PG London | British | Managing Director | 87663590001 | |||||
HINSHELWOOD, William George | Geschäftsführer | Witnesham Hall IP6 9JD Witnesham Suffolk | United Kingdom | British | Solicitor | 36026700001 | ||||
KAMP, Ralph Michael | Geschäftsführer | 20 A The Ridgeway Cuffley EN6 4AR Potters Bar Hertfordshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 60794430001 | ||||
LEMLEY, James | Geschäftsführer | 50 Courtfield Gardens Flat 2 SW5 0ND London | American | Ceo | 78406620001 | |||||
MAYSON, Andrew Graham | Geschäftsführer | Edwins Hall Edwins Hall Road Woodham Ferrers CM3 8RX Chelmsford Essex | England | British | Chief Operating Officer | 166543040001 | ||||
NORRIS, David John | Geschäftsführer | 5 Wood Drive BR7 5EU Chislehurst Kent | United Kingdom | British | Solicitor | 43802550001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MARQUIS FILMS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winv Wide Llc | 06. Apr. 2016 | Wilshire Blvd Suite 400 Santa Monica 808 Los Angeles United States | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
|
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für MARQUIS FILMS LIMITED?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
01. Sept. 2016 | 30. Dez. 2020 | Das Unternehmen hat eine registrierungspflichtige Person in Bezug auf das Unternehmen identifiziert, jedoch wurden nicht alle erforderlichen Angaben zu dieser Person bestätigt. |
Hat MARQUIS FILMS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Charge and deed of assignment | Erstellt am 21. Mai 1999 Geliefert am 02. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums owing or payable to newmarket capital group L.L.C.pursuant to the loan agreement | |
Kurze Angaben By way of fixed and floating charge all that the chargor's right title and interest (whether now owned or hereafter acquired) excepting only the sv copyright interest throughout the territory in favour of the bank,in and to:- (a) all copies made or to be made of the film and of any such other films and sound recordings as are mentioned in clause 4.2 of the charge.(b) all sums relating to or derived from the film and from time to time standing to the credit of the chargor in any bank account.(c) all other rights and properties,including but not limited to physical properties acquired.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge and deed of assignment | Erstellt am 09. Okt. 1998 Geliefert am 14. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from icon distribution llc to the chargee under deed of assignment | |
Kurze Angaben By way of first fixed and floating all copies made or to be made of the film entitled 'felicia's journey' all sums relating to or derived from the film all other rights and properties the proceeds of any. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge and security assignment | Erstellt am 15. Mai 1996 Geliefert am 24. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the producer's agreement and the performance of all representations,warranties,agreements,covenants and obligations under the producers agreement | |
Kurze Angaben In relation to the film all preprints elements capable of producing prints all positive prints all soundtrack elements the copyright of the film,the misic and compositions including the lyrics and all distribution and other rights relating to the film and by way of floating charge all the undertaking assets and rights of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Agreement and charge | Erstellt am 24. Mai 1990 Geliefert am 07. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums which completion bond company inc. May be required to pay under the terms of a completion guarantee for the film "hamlet" and under the agreement and charge | |
Kurze Angaben The entire copyright throughout the world in the film "hamlet" and the approved screenplay for the film and any cinematograph films and sound recordings made in the course of the production of thefilm. (See form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0