J. ROSENTHAL AND SON LIMITED

J. ROSENTHAL AND SON LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameJ. ROSENTHAL AND SON LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02415151
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?

    • Großhandel mit Textilien (46410) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5 Tabley Court
    Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OPTWISE LIMITED21. Aug. 198921. Aug. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    10 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Okt. 2021

    9 SeitenLIQ03

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    7 SeitenLIQ10

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 16. Okt. 2020

    LRESSP

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Geänderte Geschäftsanschrift vom PO Box 54 158 Bury Road Radcliffe Manchester M26 2JR zum 5 Tabley Court Victoria Street Altrincham Cheshire WA14 1EZ am 21. Okt. 2020

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2019

    36 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018

    36 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2017 bis 31. März 2018

    1 SeitenAA01

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2016

    34 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Alan Jamieson als Geschäftsführer am 24. März 2017

    2 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Ernennung von Alan Jamieson als Direktor am 25. Apr. 2016

    3 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CROLLA, Gillian Denise
    Brandish
    Sandhurst Drive
    SK9 2GP Wilmslow
    Cheshire
    Sekretär
    Brandish
    Sandhurst Drive
    SK9 2GP Wilmslow
    Cheshire
    British67844560002
    CROLLA, Gillian Denise
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    England
    Geschäftsführer
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    England
    EnglandBritish67844560002
    MCLOUGHLIN, Jacqueline Anne
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Geschäftsführer
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    United KingdomBritish151736120001
    POTTER, John Steven
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Geschäftsführer
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    EnglandBritish168496110001
    ROSENTHAL, Harry Ralph
    10 The Beeches
    Heald Road, Bowdon
    WA14 2HZ Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    10 The Beeches
    Heald Road, Bowdon
    WA14 2HZ Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish46809940002
    ANDERSON, Neil
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Geschäftsführer
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    EnglandBritish174453210001
    BAILEY, Keith Andrew
    Treetop Main Road
    Little Haywood
    ST18 0TR Stafford
    Geschäftsführer
    Treetop Main Road
    Little Haywood
    ST18 0TR Stafford
    EnglandBritish77732780002
    CRIBB, James
    Pendeen
    28 Caldy Road
    CH48 2HG West Kirby
    Merseyside
    Geschäftsführer
    Pendeen
    28 Caldy Road
    CH48 2HG West Kirby
    Merseyside
    United KingdomBritish15119750004
    HAMILTON, John Peter
    Harden Road
    BB18 6TS Kelbrook
    The Old Co-Op 1
    Geschäftsführer
    Harden Road
    BB18 6TS Kelbrook
    The Old Co-Op 1
    EnglandBritish129084320001
    HENDERSON, Francis
    22 Ellendale Grange
    Worsley
    M28 7UX Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    22 Ellendale Grange
    Worsley
    M28 7UX Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish31481280001
    HILLIER, Paul Christopher
    57 Pewterspear Green Road
    Appleton
    WA4 5FE Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    57 Pewterspear Green Road
    Appleton
    WA4 5FE Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish66065810001
    HOYLE, Jacqueline Diane
    7 Christchurch Lane
    Harwood
    BL2 3QF Bolton
    Geschäftsführer
    7 Christchurch Lane
    Harwood
    BL2 3QF Bolton
    United KingdomBritish77098160002
    JAMIESON, Alan
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Lancashire
    EnglandBritish209414830001
    KINGSLEY, Andrew Robert
    PO BOX 54
    158 Bury Road
    M26 2JR Radcliffe
    Manchester
    Geschäftsführer
    PO BOX 54
    158 Bury Road
    M26 2JR Radcliffe
    Manchester
    United KingdomBritish3974060003
    WHITTLE, Simon Robert
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    Geschäftsführer
    Bury Road
    Radcliffe
    M26 2JR Manchester
    158
    EnglandBritish151744120001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Andrew Peter Rigby
    Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    5 Tabley Court
    Cheshire
    England
    07. Apr. 2016
    Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    5 Tabley Court
    Cheshire
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Mr Harry Ralph Rosenthal
    Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    5 Tabley Court
    Cheshire
    England
    07. Apr. 2016
    Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    5 Tabley Court
    Cheshire
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat J. ROSENTHAL AND SON LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal assignment
    Erstellt am 30. Nov. 2011
    Geliefert am 01. Dez. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Nov. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Erstellt am 24. Nov. 2011
    Geliefert am 26. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Nov. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Floating charge (all assets)
    Erstellt am 21. Nov. 2011
    Geliefert am 24. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transaktionen
    • 24. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Nov. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Nov. 2011
    Geliefert am 10. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Britannia house 158 bury road radcliffe manchester t/n GM115898 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Nov. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Nov. 2011
    Geliefert am 10. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    219 bury road radcliffe t/no GM906491 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Nov. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 08. Okt. 2007
    Geliefert am 17. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mr Harry Ralph Ross
    Transaktionen
    • 17. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juli 2001
    Geliefert am 02. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Prospect mill walter street blackburn lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 2000
    Geliefert am 08. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property being units 82, 83, 84 and 85 bison place moss side industrial estate leyland lancashire.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Apr. 1999
    Geliefert am 20. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,000,000 and all other sums due from the company to the chargee pursuant to an agreement of even date
    Kurze Angaben
    Prospect mill walter st,blackburn lancashire; la 609520; all fixtures/fittings,fixed plant/machinery thereon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Rexmore PLC
    Transaktionen
    • 20. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Dez. 1996
    Geliefert am 02. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 158 bury road radcliffe manchester t/no 115898 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 15. März 1996
    Geliefert am 26. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Nov. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 25. Okt. 1995
    Geliefert am 01. Nov. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transaktionen
    • 01. Nov. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Sept. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. März 1995
    Geliefert am 04. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed charge on book debts
    Erstellt am 10. Aug. 1994
    Geliefert am 17. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A) by way of first fixed charge all book debts and other debts. B). by way of first floating charge the premises described in (a) above if and insofar as the charges thereon or any part thereof shall for any reason be in eneffective as fixed charges.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Invoice Discounting Limited
    Transaktionen
    • 17. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Feb. 1994
    Geliefert am 18. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Bank of Pakistan Limited
    Transaktionen
    • 18. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Okt. 1989
    Geliefert am 08. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 07. Dez. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat J. ROSENTHAL AND SON LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    01. Dez. 2022Soll aufgelöst werden am
    16. Okt. 2020Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Michael Simister
    5 Tabley Court Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire
    Praktiker
    5 Tabley Court Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire
    Neil Henry
    5 Tabley Court Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire
    Praktiker
    5 Tabley Court Victoria Street
    WA14 1EZ Altrincham
    Cheshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0