J. ROSENTHAL AND SON LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | J. ROSENTHAL AND SON LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02415151 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?
- Großhandel mit Textilien (46410) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5 Tabley Court Victoria Street WA14 1EZ Altrincham Cheshire England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| OPTWISE LIMITED | 21. Aug. 1989 | 21. Aug. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 10 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Okt. 2021 | 9 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss | 7 Seiten | LIQ10 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom PO Box 54 158 Bury Road Radcliffe Manchester M26 2JR zum 5 Tabley Court Victoria Street Altrincham Cheshire WA14 1EZ am 21. Okt. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2019 | 36 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 13 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 15 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 16 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 14 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018 | 36 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2017 bis 31. März 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 34 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Jamieson als Geschäftsführer am 24. März 2017 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Alan Jamieson als Direktor am 25. Apr. 2016 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROLLA, Gillian Denise | Sekretär | Brandish Sandhurst Drive SK9 2GP Wilmslow Cheshire | British | 67844560002 | ||||||
| CROLLA, Gillian Denise | Geschäftsführer | Bury Road Radcliffe M26 2JR Manchester 158 England | England | British | 67844560002 | |||||
| MCLOUGHLIN, Jacqueline Anne | Geschäftsführer | Bury Road Radcliffe M26 2JR Manchester 158 | United Kingdom | British | 151736120001 | |||||
| POTTER, John Steven | Geschäftsführer | Bury Road Radcliffe M26 2JR Manchester 158 | England | British | 168496110001 | |||||
| ROSENTHAL, Harry Ralph | Geschäftsführer | 10 The Beeches Heald Road, Bowdon WA14 2HZ Altrincham Cheshire | England | British | 46809940002 | |||||
| ANDERSON, Neil | Geschäftsführer | Bury Road Radcliffe M26 2JR Manchester 158 | England | British | 174453210001 | |||||
| BAILEY, Keith Andrew | Geschäftsführer | Treetop Main Road Little Haywood ST18 0TR Stafford | England | British | 77732780002 | |||||
| CRIBB, James | Geschäftsführer | Pendeen 28 Caldy Road CH48 2HG West Kirby Merseyside | United Kingdom | British | 15119750004 | |||||
| HAMILTON, John Peter | Geschäftsführer | Harden Road BB18 6TS Kelbrook The Old Co-Op 1 | England | British | 129084320001 | |||||
| HENDERSON, Francis | Geschäftsführer | 22 Ellendale Grange Worsley M28 7UX Manchester Lancashire | United Kingdom | British | 31481280001 | |||||
| HILLIER, Paul Christopher | Geschäftsführer | 57 Pewterspear Green Road Appleton WA4 5FE Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 66065810001 | |||||
| HOYLE, Jacqueline Diane | Geschäftsführer | 7 Christchurch Lane Harwood BL2 3QF Bolton | United Kingdom | British | 77098160002 | |||||
| JAMIESON, Alan | Geschäftsführer | Bury Road Radcliffe M26 2JR Manchester 158 Lancashire | England | British | 209414830001 | |||||
| KINGSLEY, Andrew Robert | Geschäftsführer | PO BOX 54 158 Bury Road M26 2JR Radcliffe Manchester | United Kingdom | British | 3974060003 | |||||
| WHITTLE, Simon Robert | Geschäftsführer | Bury Road Radcliffe M26 2JR Manchester 158 | England | British | 151744120001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei J. ROSENTHAL AND SON LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Andrew Peter Rigby | 07. Apr. 2016 | Victoria Street WA14 1EZ Altrincham 5 Tabley Court Cheshire England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Harry Ralph Rosenthal | 07. Apr. 2016 | Victoria Street WA14 1EZ Altrincham 5 Tabley Court Cheshire England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat J. ROSENTHAL AND SON LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal assignment | Erstellt am 30. Nov. 2011 Geliefert am 01. Dez. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge on purchased debts which fail to vest | Erstellt am 24. Nov. 2011 Geliefert am 26. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge (all assets) | Erstellt am 21. Nov. 2011 Geliefert am 24. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 07. Nov. 2011 Geliefert am 10. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Britannia house 158 bury road radcliffe manchester t/n GM115898 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 07. Nov. 2011 Geliefert am 10. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 219 bury road radcliffe t/no GM906491 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Okt. 2007 Geliefert am 17. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juli 2001 Geliefert am 02. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Prospect mill walter street blackburn lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Jan. 2000 Geliefert am 08. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property being units 82, 83, 84 and 85 bison place moss side industrial estate leyland lancashire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Apr. 1999 Geliefert am 20. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,000,000 and all other sums due from the company to the chargee pursuant to an agreement of even date | |
Kurze Angaben Prospect mill walter st,blackburn lancashire; la 609520; all fixtures/fittings,fixed plant/machinery thereon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 24. Dez. 1996 Geliefert am 02. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 158 bury road radcliffe manchester t/no 115898 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. März 1996 Geliefert am 26. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Okt. 1995 Geliefert am 01. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 30. März 1995 Geliefert am 04. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge on book debts | Erstellt am 10. Aug. 1994 Geliefert am 17. Aug. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A) by way of first fixed charge all book debts and other debts. B). by way of first floating charge the premises described in (a) above if and insofar as the charges thereon or any part thereof shall for any reason be in eneffective as fixed charges. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Feb. 1994 Geliefert am 18. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Okt. 1989 Geliefert am 08. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat J. ROSENTHAL AND SON LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0