COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02424283 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED?
- (7020) /
- (7415) /
Wo befindet sich COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP 31st Floor 40 Bank Street E14 5NR London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ESTATES & GENERAL PROPERTIES LIMITED | 22. Jan. 1990 | 22. Jan. 1990 |
| FEASTLAND LIMITED | 19. Sept. 1989 | 19. Sept. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 20 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Reit (Corporate Services) Limited als Sekretär am 08. Aug. 2017 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2017 | 19 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher George White als Geschäftsführer am 11. Apr. 2016 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2016 | 19 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2015 | 18 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Begbies Traynor 32 Cornhill London EC3V 3BT England zum C/O Begbies Traynor (Central) Llp 31St Floor 40 Bank Street London E14 5NR am 26. Sept. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2014 | 18 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2013 | 19 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Jan. 2012 | 17 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 6 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 5 Wigmore Street London W1U 1PB United Kingdom* am 17. Jan. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2010 bis 30. März 2010 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juli 2010 | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENADY, Maurice Moses | Geschäftsführer | 57/63 Line Wall Road Gibraltar | Gibraltar | British | 69435160001 | |||||
| TRAFALGAR OFFICERS LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London 3rd Floor | 135316290001 | |||||||
| HOLLAND, Philip John | Sekretär | 9 Royle Close Chalfont St. Peter SL9 0BA Buckinghamshire | British | 74688330002 | ||||||
| ROBERTS, Geoffrey Michael | Sekretär | Brenchley 8 Hamilton Road DA15 7HB Sidcup Kent | British | 29217560001 | ||||||
| WHITE, Christine | Sekretär | 31 Denmark Street WD17 4YA Watford Hertfordshire | British | 74900200002 | ||||||
| REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Sekretär | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 79571870001 | |||||||
| BLOOMFIELD, David William | Geschäftsführer | Hillcroft The Drive Harefield Place UB10 8AQ Ickenham Middlesex | British | 7927670001 | ||||||
| CLEGG, Barry Stuart | Geschäftsführer | The Gate House 18a Ducks Hill Road HA6 2NR Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 11296610002 | |||||
| CULL, David Geoffrey Maurice | Geschäftsführer | 8 Centennial Court High Street WD3 1AW Rickmansworth Hertfordshire | British | 84076630001 | ||||||
| DOSSETT, Roger John | Geschäftsführer | Charlecote Harewood Road HP8 4UA Chalfont St Giles Buckinghamshire | England | British | 116927100001 | |||||
| HOLLAND, Philip John | Geschäftsführer | 61 Badgers Gate LU6 2BF Dunstable Bedfordshire | England | British | 163838050001 | |||||
| LONGMAN, Karen Sarah | Geschäftsführer | 14b Alexandra Mansions West End Lane NW6 1LU London | British | 29163610001 | ||||||
| MALONE, Kenneth Daniel | Geschäftsführer | One Tree Cottage 18 Woodside Avenue HP9 1JJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 60687110001 | ||||||
| WHITE, Christopher George | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 Gibraltar | Gibraltar | British | 80132540006 | |||||
| REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 74030120002 |
Hat COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 15. Sept. 2004 Geliefert am 29. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all of the chargor's rights to and title and interest from time to time in the real properties specified in part iii of schedule 2. by way of floating charge (I) the whole of its assets, present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Sixth supplemental trust deed | Erstellt am 18. Feb. 2003 Geliefert am 25. Feb. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 01. Sept. 2000 Geliefert am 05. Sept. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The principal of and interest on the £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 and the £18,000,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates & general PLC and all other monies intended to be secured by the deed and by the deeds supplemental thereto | |
Kurze Angaben F/H property k/a units a B1 and B2 foundry lane horsham t/n WSX46889 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery and all imporovements and additions thereto subject to and with the benefit of all leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants and conditions affecting the same. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and mortgage debenture | Erstellt am 04. Aug. 1992 Geliefert am 19. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the composite guarantee and mortgage debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat COUNTY & SUBURBAN HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0