VANGUARD BUS & COACH SALES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | VANGUARD BUS & COACH SALES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02425184 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VANGUARD BUS & COACH SALES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich VANGUARD BUS & COACH SALES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Daw Bank Stockport SK3 0DU Cheshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von VANGUARD BUS & COACH SALES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| JUGBROOK LIMITED | 21. Sept. 1989 | 21. Sept. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VANGUARD BUS & COACH SALES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für VANGUARD BUS & COACH SALES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 20. Aug. 2012
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 7 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Michael John Vaux am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Ernennung von Michael John Vaux als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Whitnall als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2009 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Leslie Brian Warneford am 01. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Colin Brown am 15. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs | 2 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2008 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von VANGUARD BUS & COACH SALES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUX, Michael | Sekretär | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire United Kingdom | 148863010002 | |||||||
| BROWN, Colin | Geschäftsführer | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire United Kingdom | United Kingdom | British | 85970020003 | |||||
| WARNEFORD, Leslie Brian | Geschäftsführer | 10 Dunkeld Road PH1 5TW Perth Stagecoach Group Plc Perthshire United Kingdom | United Kingdom | British | 49771140004 | |||||
| DAVISON, Jeremy Robert | Sekretär | 34 Trendlewood Park BS16 1TE Bristol | British | 65096740001 | ||||||
| FULLER, Alan Charles | Sekretär | Freshwater Cottage 2 Chapel Brow Charlesworth SK13 5HH Glossop Derbyshire | British | 70283550001 | ||||||
| HEMMING, Christopher Thomas | Sekretär | Bankura Stoke Road Bishops Cleeve GL52 7RT Cheltenham Gloucestershire | British | 17902220001 | ||||||
| STAITE, John Frederick | Sekretär | 30 Byfords Close Huntley GL19 3SA Gloucester | British | 45931770001 | ||||||
| WHITNALL, Alan Leonard | Sekretär | 25 Millhill Drive Greenloaning FK15 0LS Dunblane Perthshire | British | 54184420002 | ||||||
| COCHRANE, Keith Robertson | Geschäftsführer | Glen Hall Belwood Park PH2 7AJ Perth | British | 47574960002 | ||||||
| COOK, Stephen Edward | Geschäftsführer | Cartref 4 Rugby Road Bulkington CV12 9JE Nuneaton Warwickshire | British | 15585000001 | ||||||
| COX, Anthony Geoffrey | Geschäftsführer | 4 Keats Close Great Houghton NN4 7NX Northampton Northamptonshire | British | 70180950001 | ||||||
| COX, Brian John | Geschäftsführer | Kirknewton House Kirknewton NE71 6XF Wooler Northumberland | England | British | 1436830002 | |||||
| DAVISON, Jeremy Robert | Geschäftsführer | 34 Trendlewood Park BS16 1TE Bristol | British | 65096740001 | ||||||
| FULLER, Alan Charles | Geschäftsführer | Freshwater Cottage 2 Chapel Brow Charlesworth SK13 5HH Glossop Derbyshire | England | British | 70283550001 | |||||
| GLOAG, Ann Heron | Geschäftsführer | Kinfauns Castle PH2 7JZ Perth Perthshire | Scotland | British | 141120003 | |||||
| GRIFFITHS, Martin Andrew | Geschäftsführer | Upland 2 Dupplin Terrace PH2 7DG Perth | Scotland | British | 61722690002 | |||||
| HINKLEY, William Barry | Geschäftsführer | Mandalay Bassenthwaite CA12 4QG Keswick Cumbria | England | British | 2268190002 | |||||
| KINSKI, Michael John | Geschäftsführer | Cherry Tree House 268 Dunchurch Road CV22 6HX Rugby Warwickshire | United Kingdom | British | 58643710001 | |||||
| LYON, Inglis | Geschäftsführer | 102 Lewis Road Radford Semele CV31 1UP Leamington Spa Warwickshire | British | 72280120001 | ||||||
| RHYS-DAVIES, Mark Iorwedd | Geschäftsführer | 10 Evesham Road GL52 2AB Cheltenham Gloucestershire | British | 5652350001 | ||||||
| ROBBINS, Karen Rosaleen | Geschäftsführer | 8 Chendre Close Hayfield SK22 2PH High Peak Derbyshire | England | British | 73518280001 | |||||
| SOUTER, Brian | Geschäftsführer | Murrayfield House St Magdalenes Road PH2 0BT Perth Perthshire | British | 1436810001 | ||||||
| STAITE, John Frederick | Geschäftsführer | 30 Byfords Close Huntley GL19 3SA Gloucester | United Kingdom | British | 45931770001 | |||||
| THOMAS, Mark Richard | Geschäftsführer | The Quarry House Upper Lynch Road France Lynch GL6 8LZ Stroud Gloucestershire | British | 28914510001 |
Hat VANGUARD BUS & COACH SALES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 10. Dez. 1993 Geliefert am 18. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Please see doc for further details,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Apr. 1992 Geliefert am 12. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee debenture | Erstellt am 01. Feb. 1991 Geliefert am 07. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facility letter dated 1ST february 1991, this debenture, or any other finance document (as defined). | |
Kurze Angaben (See form 395 - ref m 226 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0