MERCURY HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MERCURY HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02425976 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MERCURY HOLDINGS LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich MERCURY HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 Mountview Court 310 Friern Barnet Lane N20 0YZ Whetstone London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MERCURY HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MERCURY AIRFREIGHT HOLDINGS LIMITED | 03. Juli 1990 | 03. Juli 1990 |
| ROLEROD LIMITED | 25. Sept. 1989 | 25. Sept. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MERCURY HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MERCURY HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ocean House the Ring Bracknell Berkshire RG12 1AN am 27. Apr. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dermot Francis Woolliscroft als Geschäftsführer am 10. Apr. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Fink als Geschäftsführer am 10. Apr. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Exel Secretarial Services Limited als Geschäftsführer am 10. Apr. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Ms Jane Sargeant als Direktor am 10. Apr. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. März 2012
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Exel Nominee No 2 Limited als Geschäftsführer am 01. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Dermot Woolliscroft als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Waters als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Steven Fink als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Exel Nominee No 2 Limited am 31. Mai 2010 | 2 Seiten | CH02 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Exel Secretarial Services Limited am 31. Mai 2010 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Exel Secretarial Services Limited am 31. Mai 2010 | 2 Seiten | CH02 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MERCURY HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire |
| 32524900007 | ||||||||||
| SARGEANT, Jane | Geschäftsführer | Friern Barnet Lane N20 0YZ Whetstone 2 Mountview Court 310 London | United Kingdom | British | 134292740001 | |||||||||
| TAYLOR, Paul | Geschäftsführer | 2a High Street Ringstead NN14 4DA Kettering Northamptonshire | England | British | 105652320001 | |||||||||
| CARTWRIGHT, Michael John | Sekretär | 4 Douro Road GL50 2PQ Cheltenham Gloucestershire | British | 65540180001 | ||||||||||
| THOMAS, Christopher Henry | Sekretär | Quarries Parkfield TN15 0HX Sevenoaks Kent | British | 3174810001 | ||||||||||
| WALLS, Kenneth Charles | Sekretär | 4 Squirrel Rise SL7 3PN Marlow Bottom Buckinghamshire | British | 24310840002 | ||||||||||
| BROWN, Peter Frederick | Geschäftsführer | Lindrick Marlpit Close TN8 6BE Edenbridge Kent | British | 11464160001 | ||||||||||
| BUMSTEAD, Jonathan Culver | Geschäftsführer | Eastland Cottage Hall Place GU6 8LA Cranleigh Surrey | United Kingdom | British | 72820970001 | |||||||||
| BUTTERFIELD, Michael John Brownrigg | Geschäftsführer | 53 Hollycroft Avenue NW3 7QJ London | English | 2304510001 | ||||||||||
| CARTWRIGHT, Michael John | Geschäftsführer | 4 Douro Road GL50 2PQ Cheltenham Gloucestershire | British | 65540180001 | ||||||||||
| CHAMBERS, Alan James | Geschäftsführer | 19 Mayes Close Mayes Place CR6 9LB Warlingham Surrey | British | 21607620002 | ||||||||||
| FINK, Steven | Geschäftsführer | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 158324340001 | |||||||||
| GOLDSMITH, Brian Leslie | Geschäftsführer | 65 Moor End SL6 2YJ Holyport Berkshire | England | British | 101242590001 | |||||||||
| HOWSE, Christopher John | Geschäftsführer | 52 Gregories Road HP9 1HQ Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 58746330001 | |||||||||
| JAKES, Clifford Duncan | Geschäftsführer | Deeracres Lisle Court Road SO41 5SH Lymington Hampshire | United Kingdom | British | 8426370002 | |||||||||
| MATTHEWS, John Waylett | Geschäftsführer | Limpley Crest Midford Lane Limpley Stoke BA2 7GW Bath Avon | England | British | 28826190001 | |||||||||
| PORTER, Melvin Robert | Geschäftsführer | Highfield House Manor Wood Gate Lower Shiplake RG9 3BY Henley On Thames | United Kingdom | British | 91881810001 | |||||||||
| ROBINSON, Anthony John | Geschäftsführer | 5 Simmons Place TW18 3HW Staines Middlesex | English | 68016520002 | ||||||||||
| ROTHWELL, Donald Sidney | Geschäftsführer | Tamarisk Knotty Green HP9 2UA Beaconsfield Bucks | English | 812720001 | ||||||||||
| RUSSELL, Deborah Elizabeth | Geschäftsführer | 63 Crofton Close RG12 0UT Bracknell Berkshire | British | 59704430001 | ||||||||||
| SMITH, Ian Richard | Geschäftsführer | 22 The Grange Wimbledon SW19 4PS London | United Kingdom | British | 181082310001 | |||||||||
| THOMAS, Christopher Henry | Geschäftsführer | Quarries Parkfield TN15 0HX Sevenoaks Kent | England | British | 3174810001 | |||||||||
| THOMAS, Christopher Henry | Geschäftsführer | Quarries Parkfield TN15 0HX Sevenoaks Kent | England | British | 3174810001 | |||||||||
| WATERS, Christopher Stephen | Geschäftsführer | 5 Five Acres WD4 9JU Kings Langley Hertfordshire | England | British | 54969250001 | |||||||||
| WOOLLISCROFT, Dermot Francis | Geschäftsführer | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | England | British | 125837760001 | |||||||||
| YOUNG, Stuart Anthony | Geschäftsführer | 12 Darling House 35 Clevedon Road TW1 2TU Twickenham | England | English | 47414200005 | |||||||||
| EXEL NOMINEE NO 2 LIMITED | Geschäftsführer | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire |
| 73807850002 | ||||||||||
| EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom |
| 32524900007 |
Hat MERCURY HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of assignment of life policy | Erstellt am 09. Apr. 1997 Geliefert am 21. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or by the other borrowers (as defined)(or either of them) to the chargee under the facilities agreement (as defined) | |
Kurze Angaben All its right,title and interest in and to the policy including all new and substituted policies relating thereto and all moneys including bonuses accrued or which may at any time hereafter accrue and which shall become patable thereunder. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment of life policies | Erstellt am 24. März 1997 Geliefert am 02. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee by the company or by the other borrowers (as therein defined) (or either of them) (except for obligations and liabilities due owing or incurred to the chargee by the other borrowers as guarantor for the company) in whatever manner, including without prejudice to the generality of the foregoing under the facilities agreement (as therein defined) and on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assigns all right title and interest in and to the policies being: policy numbers 24069-088-das and 24068-088-das including all new and substituted policies relating thereto and all moneys including bonuses accrued thereunder. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 24. Jan. 1997 Geliefert am 10. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to each of the relevant agreements (as defined); and all monies due or to become due from any other company to the chargee under or pursuant to each of the relevant agreements (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Pledge agreement | Erstellt am 24. Jan. 1997 Geliefert am 10. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness and obligations of the company to the chargee under the facilities agreement of even date and the relevant agreements (as defined) | |
Kurze Angaben By clause 2 of the pledge agreement the pledgor pledged and granted to the bank the pledged shares being all of the issued and outstanding shares of common stock of mercury holdings inc. And the proceeds thereof together with any shares issued by way of stock dividend split or other distribution or reclassification. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Mai 1990 Geliefert am 18. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (For full details see form M395 reference M44L and continuation sheet). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 30. Mai 1990 Geliefert am 08. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Mai 1990 Geliefert am 04. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Stock-in-trade work-in-progress prepayments, investments. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MERCURY HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0