QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02426512 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Suite 64 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way CM1 2QE Chelmsford Essex England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| QUEENS MOAT HOUSES (A) DEVELOPMENTS LIMITED | 04. Juli 2005 | 04. Juli 2005 |
| ASHFORD DEVELOPMENTS LTD | 04. Dez. 1989 | 04. Dez. 1989 |
| JUGMEAD LIMITED | 26. Sept. 1989 | 26. Sept. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sally Ann Coughlan am 02. Jan. 2016 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE zum Suite 64 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE am 07. Dez. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sally Ann Coughlan am 02. Okt. 2014 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Erwin Joseph Rieck als Geschäftsführer am 30. Sept. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Queens Court 9-17 Eastern Road Romford Essex RM1 3NG zum 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE am 29. Sept. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Martin Quinn als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Rosenberg als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von W2001 Two Cv als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von W2001 Britannia Llc als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Erwin Joseph Rieck am 12. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von W2001 Two Cv als Direktor | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUGHLAN, Sally Ann | Sekretär | Waterhouse Business Park 2 Cromar Way CM1 2QE Chelmsford Suite 64 Essex England | British | 107832420001 | ||||||||||||
| QUINN, Martin Joseph | Geschäftsführer | 34 Francis Grove, Wimbledon SW19 4DT London Westmont Management Limited England | England | Irish | 186571310001 | |||||||||||
| BURGESS, Keith John | Sekretär | 3 Queen Annes Gate White House Walk GU9 9AN Farnham Surrey | British | 7009790002 | ||||||||||||
| CHRISTIAN, Tracy Joanne | Sekretär | 19 Lovell Walk RM13 7ND Rainham Essex | British | 102667300001 | ||||||||||||
| JONES, Vanessa | Sekretär | Stables House Castle Hill RH1 4LB Bletchingley Surrey | British | 72146200001 | ||||||||||||
| PURVIS, Martin Terence Alan | Sekretär | Fenetters Melfort Road TN6 1QT Crowborough East Sussex | British | 7901050001 | ||||||||||||
| STADEN, Paul Sidney | Sekretär | Swallows Barn New College Court MK18 5JP Chackmore Buckingham | British | 35453800001 | ||||||||||||
| WATERS, Jonathan Roy | Sekretär | Maldon Road CO3 3BQ Colchester 237 Essex | British | 129848360001 | ||||||||||||
| ALLSOP, Heather Louise | Geschäftsführer | 62 Prebend Street N1 8PS London | British | 101912850001 | ||||||||||||
| ASHFORD, Martin John | Geschäftsführer | The Elms Chessetts Wood Road B94 6EL Lapworth Solihull | British | 1450190001 | ||||||||||||
| BEASLEY, Colin John | Geschäftsführer | The Ridings Plumpton Road, Woodend NN12 8RZ Towcester Northamptonshire | United Kingdom | British | 65499270001 | |||||||||||
| COLES, Alan Clifford | Geschäftsführer | The Knoll Grendon NN7 1JG Northampton Beeches, 5 Northamptonshire | England | British | 101144900002 | |||||||||||
| COLLYER, Brian Charles | Geschäftsführer | 49 Route De Croissy 78110 Le Vesinet France | Canadian | 101144260001 | ||||||||||||
| COPPEL, Andrew Maxwell | Geschäftsführer | Orchard House 8 Claremont Park Road KT10 9LT Esher Surrey | England | British | 14330100002 | |||||||||||
| COURT, Gregory James | Geschäftsführer | 46 Buckminster Drive Dorridge B93 8PG Solihull West Midlands | British | 17155090002 | ||||||||||||
| CUTTS, John Charles | Geschäftsführer | Tudor Gables Old Warwick Road Lapworth B94 6AY Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 56651680001 | |||||||||||
| ELLAMS, Robert | Geschäftsführer | 34 Alderbrook Road B91 1NN Solihull West Midlands | British | 80180860001 | ||||||||||||
| FEARNSIDE, James Nicholas | Geschäftsführer | 7 Harris Close Henley In Arden B95 5DE Solihull West Midlands | British | 54861980001 | ||||||||||||
| GOIN, Russell Todd | Geschäftsführer | 4 Rue Jadin 75017 FOREIGN Paris France | American | 108675490001 | ||||||||||||
| KABALAN, Fadi | Geschäftsführer | Keyes House Dolphin Square SW1V 3NA London Suite 311 | England | British | 133846470001 | |||||||||||
| KEIR, David Christopher Lindsay | Geschäftsführer | Laird Manoch Church Lane NN6 9NX Harrington Northamptonshire | British | 32255280001 | ||||||||||||
| KRAIS, Ashley Simon | Geschäftsführer | 74 Marsh Lane NW7 4NT London | United Kingdom | British | 105921220001 | |||||||||||
| LE POIDEVIN, Andrew Daryl | Geschäftsführer | Kinneil 34 Bulstrode Way SL9 7QU Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 4958800007 | |||||||||||
| MENARD, Veronique Pascale Dominique | Geschäftsführer | Goldman Sachs International Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International England | United Kingdom | French | 141156250001 | |||||||||||
| METCALFE, Michael Stuart | Geschäftsführer | Harwil 37 Howards Thicket SL9 7NT Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 40294180002 | |||||||||||
| MOORE, Richard John | Geschäftsführer | 2 Maple Wood Bedhampton PO9 3JB Havant Hampshire | England | British | 101144680001 | |||||||||||
| MULAHASANI, Heather Louise | Geschäftsführer | Goldman Sachs International Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International | England | British | 136994090001 | |||||||||||
| OGDEN, Kathryn | Geschäftsführer | 14 Arundel Court 43-47 Arundel Gardens W11 2LP London | American | 114248790002 | ||||||||||||
| RIECK, Erwin Joseph | Geschäftsführer | Queens Court 9-17 Eastern Road RM1 3NG Romford Queens Court Essex England | German | 108675520002 | ||||||||||||
| ROBERTS, Peter Charles William | Geschäftsführer | White Lodge 78 Tiddington Road CV37 7BA Stratford Upon Avon Warwickshire | United Kingdom | British | 81817780001 | |||||||||||
| ROSENBERG, Matthew Alexander | Geschäftsführer | Queens Court 9-17 Eastern Road RM1 3NG Romford Queens Court Essex England | England | British | 134723670001 | |||||||||||
| SCOBLE, Timothy James | Geschäftsführer | 57 Old Road Wheatley OX33 1NX Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 83743120001 | |||||||||||
| STADEN, Paul Sidney | Geschäftsführer | Swallows Barn New College Court MK18 5JP Chackmore Buckingham | British | 35453800001 | ||||||||||||
| W2001 BRITANNIA LLC | Geschäftsführer | The Corporation Trust Company 1209 Orange Street Wilmington The Corporation Trust Company County Of Newcastle Usa |
| 152068320001 | ||||||||||||
| W2001 TWO CV | Geschäftsführer | Strawinskylaan 1207 1077 Xx Amsterdam Strawinskylaan 1207 Netherlands |
| 152068470001 |
Hat QMH (A) DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A composite guarantee and debenture | Erstellt am 23. Feb. 2005 Geliefert am 04. März 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 24. Nov. 2004 Geliefert am 14. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Juni 2004 Geliefert am 25. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed to the composite guarantee and debenture | Erstellt am 08. Juni 2004 Geliefert am 11. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 25. März 2004 Geliefert am 26. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge on shares | Erstellt am 30. Juni 1999 Geliefert am 09. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from glancepress (wokingham) limited or a memeber of the same group to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Seven hundred and fitiyy one sh of £1.00 each in the issued share capiatl of the borrower with all dividends interest and other money for full details please refer to form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed without instrument | Erstellt am 03. Juni 1992 Geliefert am 13. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £440,000 due from the company and/or wilson bowden properties limited to the chargee | |
Kurze Angaben Farmhouse bungalow farm buildings and land containing 6.84 acres or thereabouts forming part of gate farm bardon hill near coalville leicestershire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Jan. 1992 Geliefert am 04. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at rockingham road market harborough leicestershire t/n lt 227168. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Jan. 1992 Geliefert am 04. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at the embankment wellingborough northhamptonshire t/n nn 147287. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Jan. 1992 Geliefert am 04. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at embankment wellingborough northamptonshire t/n nn 139614. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Jan. 1992 Geliefert am 04. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The palais bingo hall, wentworth street, peterborough, cambridgeshire. T/n CB77541. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Jan. 1992 Geliefert am 04. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on the south side of raywell street, kingston-upon-hull, humberside. T/n HS194357. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Jan. 1992 Geliefert am 04. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 5 new walk, and 38-50 (even numbers) king street, leicester, leicestershire. T/n LT151627. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Jan. 1992 Geliefert am 04. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 5 new walk and 38-50 (even numbers) king street, leicester, leicestershire. T/n LT58751. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Jan. 1992 Geliefert am 04. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 5 new walk and 38-50 (even numbers) king street, leicester, leicestershire. T/n LT39919. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Jan. 1992 Geliefert am 04. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at rockingham road, market harborough, leicestershire. T/n LT233767. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Jan. 1992 Geliefert am 04. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at barton dock road, trafford park, manchester, greater manchester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Juli 1991 Geliefert am 08. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the agreement of even date | |
Kurze Angaben F/H plot e, swift park rugby, title no wk 327361 all the companys right title & interest in the balance of the sale proceeds (if any) (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Nov. 1990 Geliefert am 30. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 24.65 acres of land at cosford lane, rugby, warwickshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0