CARE IN BATHING LTD
Überblick
| Unternehmensname | CARE IN BATHING LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02426566 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CARE IN BATHING LTD?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich CARE IN BATHING LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 20-21 Padgets Lane B98 0RA Redditch England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CARE IN BATHING LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PREMIER BATHROOMS LTD. | 17. Okt. 1995 | 17. Okt. 1995 |
| GULLYMERE LIMITED | 26. Sept. 1989 | 26. Sept. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CARE IN BATHING LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Aug. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CARE IN BATHING LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Sotos Constantinides als Direktor am 30. Okt. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stephen Michael Murray als Geschäftsführer am 18. Okt. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Aug. 2022 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Aug. 2021 | 3 Seiten | AA | ||
Ernennung von Stephen Michael Murray als Direktor am 18. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Jeremy Simon Ling als Geschäftsführer am 16. Nov. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Aug. 2020 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Aug. 2019 | 16 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Apr. 2020 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Jeremy Simon Ling als Direktor am 01. Dez. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Lawrence Edward Warriner als Geschäftsführer am 17. Feb. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Kevin Bage als Geschäftsführer am 31. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Premier House Hewell Road Enfield Redditch Worcestershire B97 6BW zum Unit 20-21 Padgets Lane Redditch B98 0RA am 29. Aug. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
legacy | 6 Seiten | RP04CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2018 | 25 Seiten | AA | ||
Cessation of Mobility Bathing Group Limited as a person with significant control on 31. Aug. 2018 | 3 Seiten | PSC07 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von CARE IN BATHING LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTANTINIDES, Sotos | Geschäftsführer | Padgets Lane B98 0RA Redditch Unit 20-21 England | United Kingdom | British | 124622460002 | |||||
| ELLIS, Lee Richard | Geschäftsführer | Padgets Lane B98 0RA Redditch Unit 20-21 England | England | British | 199559150001 | |||||
| FARMILOE, Gordon Trevarthen | Sekretär | Premier House Hewell Road Enfield B97 6BW Redditch Worcestershire | British | 48633500003 | ||||||
| FARMILOE, Gordon Trevarthen | Sekretär | Perry Mill Farm Perry Mill Lane B98 6RR Bradley Green Redditch | British | 48633500003 | ||||||
| BAGE, Kevin Bruce | Geschäftsführer | Padgets Lane B98 0RA Redditch Unit 20-21 England | England | British | 212484210001 | |||||
| CHAPMAN, Richard Anthony | Geschäftsführer | Premier House Hewell Road Enfield B97 6BW Redditch Worcestershire | England | British | 141406650001 | |||||
| ELLIS, Steven | Geschäftsführer | Rose Cottage Main Street WR10 2LX Bishampton Worcestershire | British | 84557420001 | ||||||
| FARMILOE, Gordon Trevarthen | Geschäftsführer | Premier House Hewell Road Enfield B97 6BW Redditch Worcestershire | England | British | 150955160001 | |||||
| FARMILOE, Gordon Trevarthen | Geschäftsführer | Perry Mill Farm Perry Mill Lane B98 6RR Bradley Green Redditch | England | British | 48633500003 | |||||
| FARMILOE, Malcolm Patrick | Geschäftsführer | Premier House Hewell Road Enfield B97 6BW Redditch Worcestershire | England | British | 5663680011 | |||||
| FARMILOE, Malcolm Patrick | Geschäftsführer | Premier House Hewell Road Enfield B97 6BW Redditch Worcestershire | United Kingdom | British | 5663680009 | |||||
| FARMILOE, Philip Geoffrey | Geschäftsführer | Manor Cottage Abbots Morton WR7 4NA Worcester Worcestershire | United Kingdom | British | 23681750002 | |||||
| GARDNER, John William | Geschäftsführer | 9 Caynham Close Winyates West B98 0JF Redditch | British | 53982190004 | ||||||
| HARVEY, Paul Andrew | Geschäftsführer | 1 Manor Road B80 7NA Studley Warwickshire | England | English | 50633130002 | |||||
| HOWE, Michael | Geschäftsführer | Premier House Hewell Road Enfield B97 6BW Redditch Worcestershire | England | British | 32724080002 | |||||
| HURFURT, Gareth John | Geschäftsführer | Premier House Hewell Road Enfield B97 6BW Redditch Worcestershire | England | British | 112699190001 | |||||
| JUSTICE, Kevin Thomas | Geschäftsführer | Premier House Hewell Road Enfield B97 6BW Redditch Worcestershire | United Kingdom | British | 189302640001 | |||||
| LING, Jeremy Simon | Geschäftsführer | Padgets Lane B98 0RA Redditch Unit 20-21 England | England | British | 267364260001 | |||||
| MOSEDALE, Michael John | Geschäftsführer | 44 Luddington Road B92 9QH Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 14506050002 | |||||
| MURRAY, Stephen Michael | Geschäftsführer | Padgets Lane B98 0RA Redditch Units 20-21 England | England | British | 290563950001 | |||||
| NEWBROOK, David | Geschäftsführer | 5 Wasdale Court WR4 9YT Worcester Worcestershire | British | 28917950001 | ||||||
| PRICE, Richard Duncan | Geschäftsführer | Premier House Hewell Road Enfield B97 6BW Redditch Worcestershire | England | British | 111545180001 | |||||
| VAUGHAN, Andrew Derek | Geschäftsführer | Premier House Hewell Road Enfield B97 6BW Redditch Worcestershire | England | British | 174693630001 | |||||
| WARRINER, Lawrence Edward | Geschäftsführer | Padgets Lane B98 0RA Redditch Unit 20-21 England | United Kingdom | British | 119997720001 | |||||
| WATSON, Andrew Terence | Geschäftsführer | 12 Battenhall Road WR5 2BL Worcester Worcestershire | England | British | 107091420001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CARE IN BATHING LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobility Bathing Group Limited | 31. Aug. 2018 | Hewell Road B97 6BW Redditch Premier House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Hc1264 Limited | 06. Apr. 2016 | Hewell Road B97 6BW Redditch Premier House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Hc1264 Limited | 06. Apr. 2016 | Hewell Road Enfield B97 6BW Redditch Premier House Worcester | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CARE IN BATHING LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 21. Feb. 2018 Geliefert am 05. März 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung N/A. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 21. Feb. 2018 Geliefert am 22. Feb. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung The freehold property known as unit 1, enfield industrial estate, hewell road, redditch, B97 6BG and registered at the land registry with title number HW110381. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 04. Okt. 2016 Geliefert am 06. Okt. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All that freehold property known as premier house, unit 1 enfield industrial estate, hewell road, redditch, worcestershire B97 6BG registered at the land registry under title number HW110381. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 20. Juli 2016 Geliefert am 20. Juli 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung A fixed and floating charge over all assets. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 26. Mai 2016 Geliefert am 31. Mai 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Unit 1, enfield industrial estate, hewell road, redditch, B97 6BG. Title number HW110381. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 15. Apr. 2016 Geliefert am 26. Apr. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 11. März 2015 Geliefert am 13. März 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Unit 1 enfield industrial estate hewell road redditch t/n HW110381. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 27. Okt. 2011 Geliefert am 02. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H properties at unit 16 vigo place hayward industrial estate aldridge t/n WM884026, gainsborough house brickyard road aldridge and unit 16 vigo place hayward industrial estate aldridge west midlands and any buildings, fixtures, fittings, fixed plant or machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Omnibus letter of set-off | Erstellt am 24. Okt. 2011 Geliefert am 28. Okt. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 01. Apr. 2011 Geliefert am 18. Apr. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property at unit 1 enfield industrial estate, hewell road, redditch t/no HW110381 and any buildings, fixtures, fittings, fixed plant and machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Apr. 2011 Geliefert am 18. Apr. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee whether for its own account or as trustee for the secured parties or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 20. März 2007 Geliefert am 04. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. März 2007 Geliefert am 04. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. März 2006 Geliefert am 22. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a unit 1, enfield industrial estate, hewell road, redditch t/no HW110381. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. März 2006 Geliefert am 22. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Sept. 1999 Geliefert am 13. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 1, enfield industrial estate hewell road redditch worcestershire t/n HW110381. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Nov. 1998 Geliefert am 22. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The f/h property k/a unit 1 enfield industrial estate hewell road redditch t/n HW110381. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Nov. 1998 Geliefert am 22. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £250,000 and all other monies due or to become due from the company under the debenture | |
Kurze Angaben The f/h property k/a unit 1 enfield industrial estate hewell road redditch t/n HW110381. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. März 1995 Geliefert am 29. März 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £30,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Nov. 1993 Geliefert am 16. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £10,000 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Floating charge on the undertaking property and uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Mai 1993 Geliefert am 09. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0