OFQUEST LIMITED
Überblick
Unternehmensname | OFQUEST LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02429501 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OFQUEST LIMITED?
- (3614) /
Wo befindet sich OFQUEST LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Begbies Traynor 9th Floor Bond Court LS1 2JZ Leeds West Yorkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von OFQUEST LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
DESKING SYSTEMS LIMITED | 17. Okt. 1991 | 17. Okt. 1991 |
WELLPAY LIMITED | 05. Okt. 1989 | 05. Okt. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OFQUEST LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2007 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für OFQUEST LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für OFQUEST LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 16 Seiten | 4.72 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juni 2014 | 21 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juni 2014 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Dez. 2013 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juni 2013 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Dez. 2012 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juni 2012 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Dez. 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Juli 2013 | 18 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juni 2012 | 17 Seiten | 4.68 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juni 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. Juni 2010 | 16 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 16 Seiten | 2.34B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Jan. 2010 | 14 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Juli 2009 | 11 Seiten | 2.24B | ||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 12 Seiten | 2.16B | ||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 33 Seiten | 2.23B | ||
Vorschlag des Verwalters | 32 Seiten | 2.17B | ||
legacy | 2 Seiten | 288b | ||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||
Wer sind die Geschäftsführer von OFQUEST LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAYSHAW, Neil Andrew | Geschäftsführer | 3 Finchley Lane OX6 8AE Bicester Oxfordshire | England | British | Operations Director | 59805060001 | ||||
OFQUEST DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Irton House Warpsgrove Lane, Chalgrove OX44 7TH Oxford | 101569120002 | |||||||
BARKER, James Edward | Sekretär | The Old Vicarage Cragg Vale HX7 5TB Hebden Bridge West Yorkshire | British | 42890001 | ||||||
BENNETT, Phillip James | Sekretär | Grove House Daw Lane Horbury WF4 5DR Wakefield West Yorkshire | British | Company Director | 113393520001 | |||||
KING, Lorna | Sekretär | Slade Road Stokenchurch HP14 3QH High Wycombe 34 Buckinghamshire | British | 130153660001 | ||||||
GWB SECRETARY LIMITED | Sekretär | Crossley House Hopwood Lane HX1 5EB Halifax West Yorkshire | 83825250001 | |||||||
OFQUEST SECRETARY LIMITED | Sekretär | Irton House Warpsgrove Lane, Chalgrove OX44 7TH Oxford | 86085190002 | |||||||
ALLEN, Christopher Taylor | Geschäftsführer | 65 Seven Acres OX9 3JQ Thame Oxfordshire | British | Financial Director | 45256100001 | |||||
ATKIN, John Dudley | Geschäftsführer | Manor Farm Marston St Lawrence OX17 2DA Banbury Oxfordshire | England | British | Finance Director | 47046270004 | ||||
BARKER, James Edward | Geschäftsführer | The Old Vicarage Cragg Vale HX7 5TB Hebden Bridge West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 42890001 | ||||
BENNETT, Phillip James | Geschäftsführer | Grove House Daw Lane Horbury WF4 5DR Wakefield West Yorkshire | England | British | Company Director | 113393520001 | ||||
DUFFY, Francis Patrick | Geschäftsführer | 33 Tithebarn Road L34 0EU Knowsley Village Merseyside | England | British | Director | 151944930001 | ||||
GARTLAND, Anthony | Geschäftsführer | Broad Carr House Broad Carr Lane HX4 9BS Holywell Green Halifax | United Kingdom | British | Director | 27652170001 | ||||
HADLEY, David John | Geschäftsführer | 76 Old High Street The Slade Headington OX3 7HW Oxford | British | Design & Development Officer | 55574880002 | |||||
HEATHER, Brian Hersee | Geschäftsführer | 9 Gledhow Park Crescent Chapel Allerton LS7 4JY Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 40164810001 | ||||
HEATHER, Brian Hersee | Geschäftsführer | 9 Gledhow Park Crescent Chapel Allerton LS7 4JY Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 40164810001 | ||||
HOYLE, Richard John | Geschäftsführer | Millstones Milner Lane Greetland HX4 8HP Halifax West Yorkshire | England | British | Director | 43591930001 | ||||
IRWIN, John David | Geschäftsführer | Seeleys Orchard 39 Penn Road HP9 2LN Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | Company Director | 59361420001 | ||||
LAWSON, Ian Bruce | Geschäftsführer | 15 Moorlands Westwood Drive LS29 9QZ Ilkley Yorkshire | England | British | Director | 79170680001 | ||||
MCDOUGALL, Andrew | Geschäftsführer | The Old School School Lane NG13 9ES Whatton In The Vale Nottinghamshire | England | British | Director | 154053860001 | ||||
MILLS, Lawrence Anthony | Geschäftsführer | 15 Mayfield Drive Brayton YO8 9JZ Selby North Yorkshire | United Kingdom | British | Sales Director | 165378540001 | ||||
PENTLAND, Ian William | Geschäftsführer | Steadwell House Church End MK18 5NU Leckhampstead Buckinghamshire | British | Director | 33480180001 | |||||
ROE, David | Geschäftsführer | 12 St George's Street PE9 2BJ Stamford Lincolnshire | United Kingdom | British | Director | 80567360002 | ||||
STANTON, Michael John | Geschäftsführer | 16 Duxford Close B97 5BY Redditch Worcestershire | United Kingdom | British | Sales And Marketing Director | 114566620001 | ||||
WARD, Alan John | Geschäftsführer | 6 Donegal Close Caversham RG4 5DT Reading Berkshire | England | British | Director | 70124690001 | ||||
WHALLEY, Jeffrey | Geschäftsführer | Broncroft Castle Broncroft SY7 9HL Craven Arms Shropshire | United Kingdom | British | Director | 1955430002 | ||||
WOODALL, Michael David | Geschäftsführer | Glovers Cottage Reigate Hill RH2 9PN Reigate Surrey | British | Director | 4777030001 | |||||
ZAVOS, Theodore | Geschäftsführer | Under Hill House Hundon Road Barnardiston CB9 7TJ Haverhill Suffolk | England | British | Director | 50583170001 |
Hat OFQUEST LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 30. Apr. 2008 Geliefert am 14. Mai 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 06. März 2007 Geliefert am 09. März 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 05. Aug. 2005 Geliefert am 24. Aug. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Equitable mortgage of shares | Erstellt am 04. Dez. 2000 Geliefert am 14. Dez. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in connection with the corporate guarantee | |
Kurze Angaben Shares in any relevant company and all dividends interest etc. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Dez. 2000 Geliefert am 09. Dez. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 12. Mai 2000 Geliefert am 18. Mai 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 07. Apr. 2000 Geliefert am 08. Apr. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1 x new stefani edgebander s/no.AH1003262. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 12. Juni 1998 Geliefert am 16. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due or to become due from the company and/or systems furniture limited and/or cooper & palmer limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Single debenture | Erstellt am 20. Okt. 1994 Geliefert am 08. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 02. Okt. 1992 Geliefert am 14. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Premises off eastview terrace, north street, langley mill, derbyshire t/no. DY228442. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 02. Okt. 1992 Geliefert am 13. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See form 395 ref. M367C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 09. Okt. 1991 Geliefert am 18. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat OFQUEST LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||
2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0