BMT (MIDLANDS) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BMT (MIDLANDS) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02431708 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BMT (MIDLANDS) LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich BMT (MIDLANDS) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hilton Road Cobbs Wood Industrial Estate TN23 1EW Ashford Kent, |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BMT (MIDLANDS) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BRITISH MIDLAND TOOL LIMITED | 03. Dez. 1991 | 03. Dez. 1991 |
| MINTLEY LIMITED | 12. Okt. 1989 | 12. Okt. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BMT (MIDLANDS) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BMT (MIDLANDS) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Alan Charles Gibson am 19. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Timothy John Allen am 19. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael John Allen am 19. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed british midland tool LIMITED\certificate issued on 21/11/05 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2004 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2003 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BMT (MIDLANDS) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIBSON, Alan Charles | Sekretär | 7 The Maltings Walmer CT14 7AR Deal Kent | British | 43724570002 | ||||||
| ALLEN, Michael John | Geschäftsführer | Bellropes Biddenden Road TN27 8QG Smarden Ashford Kent | England | British | 27989920001 | |||||
| ALLEN, Timothy John | Geschäftsführer | Rose Cottage Southenay Lane, Sellindge TN25 6EW Ashford Kent | England | British | 159002510001 | |||||
| GIBSON, Alan Charles | Geschäftsführer | 7 The Maltings Walmer CT14 7AR Deal Kent | England | British | 43724570002 | |||||
| GORDON, Graham | Sekretär | Flat 104 The Metropole CT20 2LU Folkestone Kent | British | 117843740001 | ||||||
| ALLEN, Donald William | Geschäftsführer | The Paddock Darnford Lane, Whittington WS14 9LD Litchfield Staffordshire | British | 72172530001 | ||||||
| ALLEN, Wayne Stephen | Geschäftsführer | The Paddock Darnford Lane Whittington WS14 9LD Lichfield Staffs | British | 117742730001 | ||||||
| GORDON, Graham | Geschäftsführer | Flat 104 The Metropole CT20 2LU Folkestone Kent | England | British | 117843740001 | |||||
| MORLEY, Alan Peter | Geschäftsführer | 4 Barn Road Handsacre WS15 4TA Rugeley Staffordshire | British | 94214320001 | ||||||
| SMITH, Alan | Geschäftsführer | Mill Stream Tamworth Road Elford B79 7BL Tamworth Staffordshire | British | 30417910001 |
Hat BMT (MIDLANDS) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| All assets debenture deed | Erstellt am 17. Mai 2002 Geliefert am 20. Mai 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 05. Apr. 2002 Geliefert am 13. Apr. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 10. März 1997 Geliefert am 17. März 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 28. März 1990 Geliefert am 02. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0