MORTIMER SPINKS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMORTIMER SPINKS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02432139
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MORTIMER SPINKS LIMITED?

    • Beratung im Bereich Informationstechnologie (62020) / Information und Kommunikation
    • Aktivitäten von Zeitarbeitsagenturen (78200) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich MORTIMER SPINKS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    110 Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MORTIMER SPINKS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TAGPASS LIMITED13. Okt. 198913. Okt. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MORTIMER SPINKS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Jan. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für MORTIMER SPINKS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Ernennung von Mark Jonathan Garratt als Direktor am 27. Apr. 2017

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mark Jonathan Garratt als Sekretär am 27. Apr. 2017

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Richard Ashcroft als Geschäftsführer am 27. Apr. 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Richard Ashcroft als Sekretär am 27. Apr. 2017

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Jan. 2016

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 27. Juni 2016

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2015

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 13. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2014

    17 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Harvey Nash Heron Tower 110 Bishopsgate London England and Wales EC2N 4AY zum 110 Bishopsgate London EC2N 4AY am 22. Sept. 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Sept. 2014

    Kapitalaufstellung am 22. Sept. 2014

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 10. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2013

    16 SeitenAA

    legacy

    10 SeitenMG01

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschlüsse

    Resolution effect notwithstanding provisions company articles 05/02/2013
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschlüsse

    Resolution effect notwithstanding any provisions of company articles 05/02/2013
    RES13

    Wer sind die Geschäftsführer von MORTIMER SPINKS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GARRATT, Mark Jonathan
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    Sekretär
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    231362280001
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish49452080003
    GARRATT, Mark Jonathan
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Bishopsgate
    EC2N 4AY London
    110
    United Kingdom
    EnglandBritish229682100001
    WASSALL, Simon Mark
    Highview
    18 Pebworth Drive
    CV35 7UD Hatton Park
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Highview
    18 Pebworth Drive
    CV35 7UD Hatton Park
    Warwickshire
    EnglandBritish108449780001
    ASHCROFT, Jonathan Richard, Mr.
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Sekretär
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    British258414370001
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British49452080003
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British49452080003
    FURNISS, Ian William
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    Sekretär
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    British81663830001
    HANTON, Karen Anne
    11 Warwick Square Mews
    SW1V 2EL London
    Sekretär
    11 Warwick Square Mews
    SW1V 2EL London
    British318330001
    NORTHEY, David
    187 Croxted Road
    West Dulwich
    SE21 8NL London
    Sekretär
    187 Croxted Road
    West Dulwich
    SE21 8NL London
    British46276820002
    HARFORD NOMINEES LIMITED
    Harford House
    101-103 Great Portland Street
    W1N 6BH London
    Sekretär
    Harford House
    101-103 Great Portland Street
    W1N 6BH London
    2134810001
    ASHCROFT, Jonathan Richard, Mr.
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Beechwood Cottage
    Hambleden
    RG9 6SD Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish258414370001
    CRAWFORD, Thomas Francis Alexander
    1 Durrell Road
    Fulham
    SW6 5LQ London
    Geschäftsführer
    1 Durrell Road
    Fulham
    SW6 5LQ London
    United KingdomBritish3856480002
    ELLIS, Albert George Hector
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Lambourne
    Three Households
    HP8 4LW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish49452080003
    FURNISS, Ian William
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Greensands
    Promrose Way Bramley
    GU5 0BZ Guildford
    Surrey
    British81663830001
    HANTON, Karen Anne
    12 Crown Reach
    145 Grosvenor Road
    SW1V 3JU London
    Geschäftsführer
    12 Crown Reach
    145 Grosvenor Road
    SW1V 3JU London
    British318330003
    HIGGINS, David Charles
    40 Bradbourne Street
    Fulham
    SW6 3TE London
    Geschäftsführer
    40 Bradbourne Street
    Fulham
    SW6 3TE London
    United KingdomBritish33333910003
    NORTHEY, David
    128 Farnaby Road
    BR1 4BH Bromley
    Surrey
    Geschäftsführer
    128 Farnaby Road
    BR1 4BH Bromley
    Surrey
    British46276820003
    SINGER, David Ivan
    11 Kings Drive
    HA8 8EB Edgware
    Middlesex
    Geschäftsführer
    11 Kings Drive
    HA8 8EB Edgware
    Middlesex
    United KingdomBritish38583380003
    TREACHER, David Hedley
    Suite Goft House
    Byworth
    GU28 0HW Petworth
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Suite Goft House
    Byworth
    GU28 0HW Petworth
    West Sussex
    EnglandBritish80479660001

    Hat MORTIMER SPINKS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 12. Feb. 2013
    Geliefert am 21. Feb. 2013
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2013Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Jan. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 03. Mai 2005
    Geliefert am 17. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transaktionen
    • 17. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge by client on purchased debts which fail to vest and other debts and floating charge on banked proceeds of other debts
    Erstellt am 14. Nov. 2001
    Geliefert am 27. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the agreement (as defined in the charge) for the purchase of debts (as defined in the agreement) or otherwise
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge over any debt with its related rights purchased by the security holder pursuant to the agreement which fails to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason and any proceeds thereof; all indebtedness now or at any time owing or becoming due to the company on any account whatsoever with related rights thereto other than the purchased debts and floating charge over all monies which the company may receive in respect of other debts.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transaktionen
    • 27. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 08. Sept. 1997
    Geliefert am 24. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 29. Juni 1995
    Geliefert am 07. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 16. Feb. 1994
    Geliefert am 18. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Kurze Angaben
    The sum of £5,000 deposited.
    Berechtigte Personen
    • Stoll Moss Theatres Limited
    Transaktionen
    • 18. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 17. Juni 1993
    Geliefert am 25. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0