MORTIMER SPINKS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MORTIMER SPINKS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02432139 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MORTIMER SPINKS LIMITED?
- Beratung im Bereich Informationstechnologie (62020) / Information und Kommunikation
- Aktivitäten von Zeitarbeitsagenturen (78200) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich MORTIMER SPINKS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 110 Bishopsgate EC2N 4AY London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MORTIMER SPINKS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TAGPASS LIMITED | 13. Okt. 1989 | 13. Okt. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MORTIMER SPINKS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Jan. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MORTIMER SPINKS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mark Jonathan Garratt als Direktor am 27. Apr. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mark Jonathan Garratt als Sekretär am 27. Apr. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Richard Ashcroft als Geschäftsführer am 27. Apr. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Richard Ashcroft als Sekretär am 27. Apr. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Jan. 2016 | 11 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2015 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2014 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Harvey Nash Heron Tower 110 Bishopsgate London England and Wales EC2N 4AY zum 110 Bishopsgate London EC2N 4AY am 22. Sept. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2013 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 10 Seiten | MG01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MORTIMER SPINKS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARRATT, Mark Jonathan | Sekretär | Bishopsgate EC2N 4AY London 110 United Kingdom | 231362280001 | |||||||
| ELLIS, Albert George Hector | Geschäftsführer | Lambourne Three Households HP8 4LW Chalfont St Giles Buckinghamshire | England | British | 49452080003 | |||||
| GARRATT, Mark Jonathan | Geschäftsführer | Bishopsgate EC2N 4AY London 110 United Kingdom | England | British | 229682100001 | |||||
| WASSALL, Simon Mark | Geschäftsführer | Highview 18 Pebworth Drive CV35 7UD Hatton Park Warwickshire | England | British | 108449780001 | |||||
| ASHCROFT, Jonathan Richard, Mr. | Sekretär | Beechwood Cottage Hambleden RG9 6SD Henley On Thames Oxfordshire | British | 258414370001 | ||||||
| ELLIS, Albert George Hector | Sekretär | Lambourne Three Households HP8 4LW Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 49452080003 | ||||||
| ELLIS, Albert George Hector | Sekretär | Lambourne Three Households HP8 4LW Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 49452080003 | ||||||
| FURNISS, Ian William | Sekretär | Greensands Promrose Way Bramley GU5 0BZ Guildford Surrey | British | 81663830001 | ||||||
| HANTON, Karen Anne | Sekretär | 11 Warwick Square Mews SW1V 2EL London | British | 318330001 | ||||||
| NORTHEY, David | Sekretär | 187 Croxted Road West Dulwich SE21 8NL London | British | 46276820002 | ||||||
| HARFORD NOMINEES LIMITED | Sekretär | Harford House 101-103 Great Portland Street W1N 6BH London | 2134810001 | |||||||
| ASHCROFT, Jonathan Richard, Mr. | Geschäftsführer | Beechwood Cottage Hambleden RG9 6SD Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 258414370001 | |||||
| CRAWFORD, Thomas Francis Alexander | Geschäftsführer | 1 Durrell Road Fulham SW6 5LQ London | United Kingdom | British | 3856480002 | |||||
| ELLIS, Albert George Hector | Geschäftsführer | Lambourne Three Households HP8 4LW Chalfont St Giles Buckinghamshire | England | British | 49452080003 | |||||
| FURNISS, Ian William | Geschäftsführer | Greensands Promrose Way Bramley GU5 0BZ Guildford Surrey | British | 81663830001 | ||||||
| HANTON, Karen Anne | Geschäftsführer | 12 Crown Reach 145 Grosvenor Road SW1V 3JU London | British | 318330003 | ||||||
| HIGGINS, David Charles | Geschäftsführer | 40 Bradbourne Street Fulham SW6 3TE London | United Kingdom | British | 33333910003 | |||||
| NORTHEY, David | Geschäftsführer | 128 Farnaby Road BR1 4BH Bromley Surrey | British | 46276820003 | ||||||
| SINGER, David Ivan | Geschäftsführer | 11 Kings Drive HA8 8EB Edgware Middlesex | United Kingdom | British | 38583380003 | |||||
| TREACHER, David Hedley | Geschäftsführer | Suite Goft House Byworth GU28 0HW Petworth West Sussex | England | British | 80479660001 |
Hat MORTIMER SPINKS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 12. Feb. 2013 Geliefert am 21. Feb. 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 03. Mai 2005 Geliefert am 17. Mai 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge by client on purchased debts which fail to vest and other debts and floating charge on banked proceeds of other debts | Erstellt am 14. Nov. 2001 Geliefert am 27. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the agreement (as defined in the charge) for the purchase of debts (as defined in the agreement) or otherwise | |
Kurze Angaben By way of fixed equitable charge over any debt with its related rights purchased by the security holder pursuant to the agreement which fails to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason and any proceeds thereof; all indebtedness now or at any time owing or becoming due to the company on any account whatsoever with related rights thereto other than the purchased debts and floating charge over all monies which the company may receive in respect of other debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 08. Sept. 1997 Geliefert am 24. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Juni 1995 Geliefert am 07. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 16. Feb. 1994 Geliefert am 18. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed | |
Kurze Angaben The sum of £5,000 deposited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 17. Juni 1993 Geliefert am 25. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0