COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02435766 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3 Field Court Grays Inn WC1R 5EF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) PLC | 24. Okt. 1989 | 24. Okt. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 24 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom One Kingdom Street Paddington London W2 6BL am 08. Juni 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 14. Feb. 2011
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Ernennung von Thomas Edward Timothy Homer als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Cheesewright als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Nicholas Brian Farrimond als Direktor | 6 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Ham als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Misys Corporate Secretary Limited als Sekretär | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gurbinder Bains als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street |
| 149985420001 | ||||||||||
| FARRIMOND, Nicholas Brian | Geschäftsführer | The Avenue WD17 4NU Watford 51 Hertfordshire England | England | British | 75357260001 | |||||||||
| HOMER, Thomas Edward Timothy | Geschäftsführer | Maidenhead Road Cookham SL6 9DF Berkshire Rosedale United Kingdom | England | British | 146605570001 | |||||||||
| MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Kingdom Street Paddington W2 6BL London 1 | 82836510002 | |||||||||||
| BAINS, Gurbinder | Sekretär | Kingston Road UB2 4AP Southall 36 Middlesex United Kingdom | Other | 138753780001 | ||||||||||
| DURRANT, Zoe Vivienne | Sekretär | Beehive Cottage Radford Road, Rous Lench WR11 4UL Evesham Worcestershire | British | 68141090001 | ||||||||||
| GRAY, Elizabeth Andrea | Sekretär | 16 Broad Street CV34 4LT Warwick Warwickshire | British | 98035800001 | ||||||||||
| HAM, Richard Laurence | Sekretär | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | British | 136433670001 | ||||||||||
| JACOBS, Trevor Arthur | Sekretär | 23 Crowson Way Deeping St James PE6 8EY Peterborough Cambridgeshire | British | 5724050001 | ||||||||||
| TAYLOR, David | Sekretär | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 | ||||||||||
| WATERS, Paul Christopher | Sekretär | The Old Vicarage High Street B50 4BQ Bidford On Avon Warwickshire | British | 67435560001 | ||||||||||
| BEAUMONT, Frederick Peter | Geschäftsführer | The Homestead The Playing Close Browns Lane OX7 3QP Chalbury Oxfordshire | British | 17370420001 | ||||||||||
| CHEESEWRIGHT, James | Geschäftsführer | Horton Meadow Heyshott GU29 0DL Midhurst West Sussex | United Kingdom | British | 80646020001 | |||||||||
| COOK, John | Geschäftsführer | Barnside GL20 7BP Tredington Gloucestershire | England | British | 86208160001 | |||||||||
| COPELAND, Philip Robert | Geschäftsführer | Crofton Sheldon Road Ickford HP18 9HY Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 44954570001 | |||||||||
| DAVIS, James Michael | Geschäftsführer | 22 Meadow Road Market Deeping PE6 8PF Peterborough Cambridgeshire | England | British | 17589470001 | |||||||||
| EVANS, Howard | Geschäftsführer | Charlton Park House Charlton Park Gate GL53 7DJ Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 56986700002 | |||||||||
| GRAHAM, Ross King | Geschäftsführer | Stourton Farm House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | 61733920001 | |||||||||
| HAM, Richard Laurence | Geschäftsführer | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | United Kingdom | British | 136433670001 | |||||||||
| HAM, Richard Laurence | Geschäftsführer | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | United Kingdom | British | 136433670001 | |||||||||
| JACOBS, Trevor Arthur | Geschäftsführer | 12 Woodcroft Close PE6 8BT Market Deeping Lincs | British | 5724050002 | ||||||||||
| KING, Gary James | Geschäftsführer | The Coppice Brockhill Road WR14 4DL West Malvern Worcestershire | British | 5724060004 | ||||||||||
| LOMAX, John Kevin | Geschäftsführer | Hawling Manor Hawling GL54 5TA Cheltenham Gloucestershire | British | 22190280002 | ||||||||||
| MCMAHON, Jasper Philip | Geschäftsführer | Ground Floor Flat 33 Warrington Crescent W9 1EJ London | England | British | 45080250003 | |||||||||
| MORGAN, Glyn Howell | Geschäftsführer | 2a College Road WR14 3DD Malvern Worcestershire | British | 10282920001 | ||||||||||
| MORGAN, Roger Hugh | Geschäftsführer | The Gables Grit Lane Leigh Sinton WR14 1UR Malvern Worcestershire | British | 17001000001 | ||||||||||
| O'LEARY, Michael Kevin | Geschäftsführer | Greenwood Wichenford WR6 6YB Worcester Worcestershire | England | British | 129193560001 | |||||||||
| SHAW, John Malcolm | Geschäftsführer | Willow Gate Southorpe PE9 3BX Stamford Lincolnshire | England | British | 12536610001 | |||||||||
| SUSSENS, John Gilbert | Geschäftsführer | Blythe House 10 Grange Road Bidford On Avon B50 4BY Alcester Warwickshire | England | British | 1442450002 | |||||||||
| TAYLOR, David | Geschäftsführer | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 |
Hat COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995 | Erstellt am 19. Dez. 2006 Geliefert am 29. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 | Erstellt am 17. Sept. 2003 Geliefert am 01. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995 | Erstellt am 11. Sept. 2003 Geliefert am 24. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and | Erstellt am 29. Juli 2003 Geliefert am 12. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter) | Erstellt am 23. Okt. 2002 Geliefert am 13. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 | Erstellt am 09. Mai 2002 Geliefert am 25. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat COUNTRYWIDE HOLDINGS (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0