MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED

MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02436108
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    8th Floor One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    METAPATH SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED15. Dez. 199815. Dez. 1998
    MOBILE SYSTEMS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY04. Aug. 199204. Aug. 1992
    MOBILE SYSTEMS UK LIMITED25. Okt. 198925. Okt. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    19 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 01. März 2023

    17 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Point 3 Haywood Road Warwick CV34 5AH zum 8th Floor One Temple Row Birmingham B2 5LG am 11. März 2022

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 02. März 2022

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Kapitalaufstellung am 04. Nov. 2021

    • Kapital: GBP 0.025
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Cancellation of share premium account; cancellation of capital redemption reserve 02/11/2021
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2021

    16 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mrs Heather Marie Green als Direktor am 18. Feb. 2021

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2020

    15 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2019

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 29. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 40,000,000
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Craig George Donaldson als Sekretär am 31. März 2016

    1 SeitenTM02

    Wer sind die Geschäftsführer von MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GREEN, Heather Marie
    One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    8th Floor
    Geschäftsführer
    One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    8th Floor
    EnglandBritish106936580002
    WEBBERLEY, Mark Andrew
    One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    8th Floor
    Geschäftsführer
    One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    8th Floor
    EnglandBritish162019130001
    BRITTON, Jeanette Eden
    32 Chestnut Avenue
    KT10 8JF Esher
    Surrey
    Sekretär
    32 Chestnut Avenue
    KT10 8JF Esher
    Surrey
    British33976690001
    CARPENTER, Peter Jon
    3a King Edward Mansions
    No 8 Grape Street
    WC2H 8DY London
    Sekretär
    3a King Edward Mansions
    No 8 Grape Street
    WC2H 8DY London
    British37632220001
    DONALDSON, Craig George
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    Sekretär
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    British79026210001
    FADL, Hania, Dr
    15 Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PG London
    Sekretär
    15 Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PG London
    British7644540001
    LONG, Jacqueline
    361 Hanworth Road
    TW12 3EJ Hampton
    Middlesex
    Sekretär
    361 Hanworth Road
    TW12 3EJ Hampton
    Middlesex
    British77617710001
    MEADES, Derek Leslie
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    Sekretär
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    British8142960002
    SKELLY, Mary Angela
    44 Hartswood Road
    Stamford Brook
    W12 9NF London
    Sekretär
    44 Hartswood Road
    Stamford Brook
    W12 9NF London
    British83455820001
    SMITH, Julian Matthew
    36 Ferndene Road
    Herne Hill
    SE24 0AB London
    Sekretär
    36 Ferndene Road
    Herne Hill
    SE24 0AB London
    British110194190001
    ANDREEN, Marcus
    Flat 3 39 Matheson Road
    W14 8SN London
    Geschäftsführer
    Flat 3 39 Matheson Road
    W14 8SN London
    Swedish44488170001
    BAJWA, Anwar Sharif, Dr
    7 Lavenda Close
    Hempstead
    ME7 3TB Gillingham
    Kent
    Geschäftsführer
    7 Lavenda Close
    Hempstead
    ME7 3TB Gillingham
    Kent
    United KingdomBritish32990830001
    BUTLER, Thomas Michael
    13 West Heath Road
    Hampstead
    NW3 7UU London
    Geschäftsführer
    13 West Heath Road
    Hampstead
    NW3 7UU London
    British24904420001
    CARPENTER, Peter Jon
    3a King Edward Mansions
    No 8 Grape Street
    WC2H 8DY London
    Geschäftsführer
    3a King Edward Mansions
    No 8 Grape Street
    WC2H 8DY London
    British37632220001
    CARRINGTON, John Christopher
    1 Anchor Brewhouse
    50 Shad Thames
    SE1 2LY London
    Geschäftsführer
    1 Anchor Brewhouse
    50 Shad Thames
    SE1 2LY London
    United KingdomBritish79087670001
    COPELAND, James
    4808 Prestwick Drive
    Colleyville Texas
    76034
    United States
    Geschäftsführer
    4808 Prestwick Drive
    Colleyville Texas
    76034
    United States
    United States Citizen94697790001
    DAIN, Mark St.John
    316 Shobnall Road
    DE14 2BG Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    316 Shobnall Road
    DE14 2BG Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish159246160001
    DAYA, Moez Rajabali Rahemtulla
    6 Christchurch Road
    CR8 2BY Purley
    Surrey
    Geschäftsführer
    6 Christchurch Road
    CR8 2BY Purley
    Surrey
    Kenya7644560001
    DONALDSON, Craig George
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    Geschäftsführer
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    United KingdomBritish79026210001
    HANKINS, Kevin
    485 The Hermitage Drive
    FOREIGN Alpharetta
    30004 Georgia
    Us
    Geschäftsführer
    485 The Hermitage Drive
    FOREIGN Alpharetta
    30004 Georgia
    Us
    United States Citizen105639200001
    HARDYMON, Gene Felda
    22 Newton Street
    02193 Weston
    Massachusetts
    Usa
    Geschäftsführer
    22 Newton Street
    02193 Weston
    Massachusetts
    Usa
    American62278260001
    HARRIS, Paul
    29 Eastfields Road
    CR4 2LS Mitcham
    Surrey
    Geschäftsführer
    29 Eastfields Road
    CR4 2LS Mitcham
    Surrey
    British68547980001
    HOLT, Martin Alan
    13 Heath Rise
    NN8 5QN Wellingborough
    Geschäftsführer
    13 Heath Rise
    NN8 5QN Wellingborough
    British81023100001
    IBRAHIM, Mohamed Fathi Ahmed, Doctor
    20 Park Street
    W1K 2JA London
    Geschäftsführer
    20 Park Street
    W1K 2JA London
    British72245030003
    JULIN, Sven Tomas
    Magnebergsvagen 51
    12134 Enskededalen
    Stockholm
    Sweden
    Geschäftsführer
    Magnebergsvagen 51
    12134 Enskededalen
    Stockholm
    Sweden
    Swedish47715430001
    KERN, Rene M
    151 East 92nd Street
    10128 New York
    New York
    Usa
    Geschäftsführer
    151 East 92nd Street
    10128 New York
    New York
    Usa
    German71085180001
    LONG, Jacqueline
    361 Hanworth Road
    TW12 3EJ Hampton
    Middlesex
    Geschäftsführer
    361 Hanworth Road
    TW12 3EJ Hampton
    Middlesex
    British77617710001
    MACGOWAN, Iain Angus William
    Flat2
    22 Saltoun Road
    SW2 1EP London
    Geschäftsführer
    Flat2
    22 Saltoun Road
    SW2 1EP London
    British68985510001
    MEADES, Derek Leslie
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    British8142960002
    MEYER, John Joseph
    3745 Sterling Road
    Downes Grove
    60515 Illinois
    U.S.A
    Geschäftsführer
    3745 Sterling Road
    Downes Grove
    60515 Illinois
    U.S.A
    American34273260001
    PORTER, Norman Charles
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish445360034
    REDDY, Sreenivasula Dhanireddy
    Ino 40 Coventry Drive
    60188 Wheaton
    Illinois
    Usa
    Geschäftsführer
    Ino 40 Coventry Drive
    60188 Wheaton
    Illinois
    Usa
    Indian50894490001
    RHODES, Terence
    12 Dartmouth Row
    Greenwich
    SE10 8AN London
    Geschäftsführer
    12 Dartmouth Row
    Greenwich
    SE10 8AN London
    British72245020001
    ROBINSON, Colin Lloyd
    3717 Atrium Dr
    FOREIGN Plano Tx 75075 Usa
    U S A
    Geschäftsführer
    3717 Atrium Dr
    FOREIGN Plano Tx 75075 Usa
    U S A
    Usa41651480001
    SCHICKLING, John Joseph
    Crawford Lodge Orchehill Avenue
    SL9 8QF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Crawford Lodge Orchehill Avenue
    SL9 8QF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    75042900002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Telent Limited
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    England
    06. Apr. 2016
    Haywood Road
    CV34 5AH Warwick
    Point 3
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngand & Wales
    Registrierungsnummer67307
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security trust and intercreditor deed
    Erstellt am 19. Mai 2003
    Geliefert am 05. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    If any intra-group creditor receives any sum in relation to any intra-group liability other than pursuant to clause 9.5 of the deed, that sum shall be promptly paid to the security trustee for application in accordance with the terms of the deed, and pending such payment it shall be held on trust for the security trustee.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    An australian asset fixed and floating charge
    Erstellt am 19. Mai 2003
    Geliefert am 04. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future indebtedness liabilities and obligations at any time of the company to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured creditors) or any of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. as Security Trustee
    Transaktionen
    • 04. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A debenture between the companies (including the chargor) and the law debenture trust corporation P.L.C. as security trustee for the secured creditors
    Erstellt am 19. Mai 2003
    Geliefert am 02. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future indebtedness liabilities and obligations at any time of the company to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured creditors) or any of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all of its right title and interest from time to time and to each of the following assets: the schedule 4 real property; the tangible moveable property; any goodwill; all rights in relation to the uncalled capital; the shares, all dividends, interest and other monies; all monetary claims. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. as Security Trustee
    Transaktionen
    • 02. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 25. Apr. 2000
    Geliefert am 11. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond in favour of centre d'etrudes et de recherches des telecommunications (cert) for us$37,270
    Kurze Angaben
    The sum of us$37,270 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 140-01-08153957.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 31. März 2000
    Geliefert am 10. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of centre d'etrudes et de recherches des telecommunications (cert) for us $ 37,270
    Kurze Angaben
    The sum of $37,270 us dollars together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 140/01/08153957 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 25. Okt. 1999
    Geliefert am 28. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from metapath software international, inc., Metapath software international (bellevue), inc., Metapath software international (dallas), inc. And metapath software international limited to the chargee under a facility document as defined in the guarantee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Greyrock Capital
    Transaktionen
    • 28. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 22. Okt. 1999
    Geliefert am 26. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a performance bond in favour of bharti cellular limited $25,300 us dollars
    Kurze Angaben
    The sum of $25,300 us dollars together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 140/01/08123748 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 22. Okt. 1999
    Geliefert am 26. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a performance bond in favour of singapore telecom mobile pte limited for s$345,576.65 Singapore dollars
    Kurze Angaben
    The sum of $249,700 us dollars together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 140/01/08123764 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 19. Okt. 1999
    Geliefert am 27. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a performance bond in favour of et communications sdn bhd for us$109,475.40
    Kurze Angaben
    The sum of us$109,475.40 Together with interest accrued now or to be he national westminster bank PLC on an account numbered 140-01-08119538 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 04. März 1999
    Geliefert am 11. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The sum of £18,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 90182111.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 30. März 1998
    Geliefert am 03. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    $1,563,000 us dollars with interest accrued on account no. 140-01-06422160 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 30. März 1998
    Geliefert am 03. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    $1,953,000 us dollars with interest thereon on account no. 140-01-06422160 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 19. Juni 1997
    Geliefert am 24. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 25. Nov. 1996
    Geliefert am 04. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a performance guarantee in favour of china resources (holdings) co LTD for hk$11,000,000
    Kurze Angaben
    The sum of £1,100,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 90122904 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Okt. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 25. Nov. 1996
    Geliefert am 03. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The sum of £1,375,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 90123298 and earmarked or designated ny reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Okt. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MP SOFTWARE INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    02. März 2022Beginn der Liquidation
    10. Apr. 2024Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Malone
    8th Floor One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Praktiker
    8th Floor One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Gareth Prince
    8th Floor One Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Praktiker
    8th Floor One Temple Row
    B2 5LG Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0