ROMAN RECOVERIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ROMAN RECOVERIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02436236 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ROMAN RECOVERIES LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich ROMAN RECOVERIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Whittington Hall Whittington Road, Whittington WR5 2ZX Worcester Worcestershire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ROMAN RECOVERIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| JUGWOOD PLC | 25. Okt. 1989 | 25. Okt. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROMAN RECOVERIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ROMAN RECOVERIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 14. Dez. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Andrew Reynolds am 09. Nov. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 31. Dez. 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA | ||||||||||||||
Change of details for Pemberstone Group Limited as a person with significant control on 03. Jan. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Martin Barker am 18. Juli 2014 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 1 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 2 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ROMAN RECOVERIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEMBERSTONE (SECRETARIES) LIMITED | Sekretär | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall Worcestershire |
| 77906620001 | ||||||||||
| ANNETTS, David Charles | Geschäftsführer | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall Worcestershire | United Kingdom | British | 81373880001 | |||||||||
| BARKER, Andrew Martin | Geschäftsführer | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall Worcestershire | United Kingdom | British | 149813130009 | |||||||||
| REYNOLDS, Mark Andrew | Geschäftsführer | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall Worcestershire | United Kingdom | British | 41446640003 | |||||||||
| LAWSON, Charles Bruce | Sekretär | Council Buildings Teme Street WR15 8AA Tenbury Wells Hereford & Worcester | British | 21691000001 | ||||||||||
| CAPITAL VENTURES PLC | Sekretär | Rutherford House Blackpole Road WR3 8YA Worcester Worcestershire | 4933620008 | |||||||||||
| CIM MANAGEMENT LIMITED | Sekretär | Whittington Hall Whittington Road WR5 2ZX Worcester Worcestershire | 70618260001 | |||||||||||
| ALCOCK, Timothy Robert | Geschäftsführer | 11 Winchester House Cambridge Park TW1 2JG Twickenham Middlesex | British | 41515620003 | ||||||||||
| ANNETTS, David Charles | Geschäftsführer | The Snead Pensax WR6 6AG Abberley Worcestershire | United Kingdom | British | 81373880001 | |||||||||
| BARKER, Andrew Martin | Geschäftsführer | Upper Birch Farm Shatterford DY12 1TR Bewdley Worcestershire | British | 54622310001 | ||||||||||
| BRUCKLAND, Andrew John | Geschäftsführer | 18 Eldorado Road GL50 2PT Cheltenham Gloucestershire | England | British | 22103780002 | |||||||||
| FREDJOHN, Dennis | Geschäftsführer | Manor Park Place Rutherford Way GL51 9TR Cheltenham Gloucestershire | British | 35572390001 | ||||||||||
| INSCOE, Michael John | Geschäftsführer | Kingswood House Old Kingswood Road WV7 3AQ Albrighton Wolverhampton | British | 35547690001 | ||||||||||
| TWEEDALE, Roger | Geschäftsführer | 86 Woodthorne Road South WV6 8SW Wolverhampton West Midlands | England | British | 54065540002 | |||||||||
| PEMBERSTONE (DIRECTORS) LIMITED | Geschäftsführer | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall Worcestershire |
| 82038280001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ROMAN RECOVERIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pgl (201) Limited | 06. Apr. 2016 | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ROMAN RECOVERIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 03. Juni 1999 Geliefert am 21. Juni 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the loan agreement dated 24 february 1999 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of sub-charge | Erstellt am 03. Juni 1999 Geliefert am 21. Juni 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the guarantee dated 3 june 1999 and under a loan agreement dated 24 february 1999 | |
Kurze Angaben The chargor with full title guarantee sub-charged, conveyed, transferred and assigned to the society by way of first fixed security for the discharge and payment of the secured amounts (subject to the subsisting rights of redemption of borrowers (such term to mean, in relation to each mortgage, the person or persons referred to as the borrower in each such mortgage)) all right, title, interest and benefit of the chargor existing then or in the future in the mortgages such sub-charge shall be effected by the execution of the transfer (as defined in the deed) on the date of the deed subject to cesser on redemption. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Juni 1999 Geliefert am 21. Juni 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the loan agreement dated 24 february 1999 | |
Kurze Angaben The property known as albyn house hemel hempstead title number HD256878 for further property details see ch microfiche. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 03. Juni 1999 Geliefert am 11. Juni 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All moneys obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the loan facility or other financial accommodation | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Apr. 1999 Geliefert am 16. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 24 second ave hendon london 21 william street ystrad rondda mid glam 35 leaford road kitts green burmingham 11 hamilton road topfham exeter for further details of all property charged please refer to form 395, with the goodwill of the business and the benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. März 1998 Geliefert am 07. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings on the east side of church side market weighton, l/h land at all saints court market weighton, f/h land on east side of archway market weighton, f/h land to the west of alexandra road hemel hempstead and f/h land at plots 1,2,3,13,14,15 & 16 leasowe road moreton wirral together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery goodwill of any business together with the benefit of all licences and registrations. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. März 1998 Geliefert am 24. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Sept. 1997 Geliefert am 07. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 1 mereheath gardens moreton wiral merseyside t/n MS340503. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Sept. 1997 Geliefert am 07. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 3, 5, 7, 8, 10, 12 and 14 leasowe gardens mereheath moreton wirral merseyside. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Sept. 1997 Geliefert am 07. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a albyn house alexandra road hemel hempstead hertfordshire t/n HD256878. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Sept. 1997 Geliefert am 07. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h and l/h proeprty k/a all saints court market weighton east riding of yorkshire t/n's HS154780 (f/h) and HS200144 (l/h). And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 23. Sept. 1997 Geliefert am 07. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Feb. 1991 Geliefert am 05. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 26-2-90 | |
Kurze Angaben All saints court east side of church side market weighton east yorkshire humberside. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Nov. 1990 Geliefert am 05. Dez. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 26/2/90 | |
Kurze Angaben Land & buildings east of church side market weighton east yorkshire t/n hs 154780. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Nov. 1990 Geliefert am 09. Nov. 1990 | Vollständig erf üllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 9 of an agreement dated 26-2-90. | |
Kurze Angaben F/H on west side of alexandra road hemel hempstead berkshire t/no hd 256878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0