AMEY BUILDING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AMEY BUILDING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02444100 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AMEY BUILDING LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
- Allgemeine öffentliche Verwaltung (84110) / öffentliche Verwaltung und Verteidigung; Sozialversicherung
Wo befindet sich AMEY BUILDING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AMEY BUILDING LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| AMEY-FARR LIMITED | 04. Jan. 1991 | 04. Jan. 1991 |
| AMEY BUILDING LIMITED | 02. Feb. 1990 | 02. Feb. 1990 |
| INTERCEDE 757 LIMITED | 17. Nov. 1989 | 17. Nov. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AMEY BUILDING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AMEY BUILDING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Change of details for Amey Plc as a person with significant control on 21. Nov. 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Andrew Latham Nelson am 25. Nov. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Birch am 16. Jan. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Birch als Direktor am 15. Jan. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Lee Milner als Geschäftsführer am 12. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sherard Secretariat Services Limited am 02. Sept. 2019 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ zum Chancery Exchange 10 Furnival Street London EC4A 1AB am 02. Sept. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Change of details for Amey Plc as a person with significant control on 02. Sept. 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AMEY BUILDING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Sekretär | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom |
| 109588620001 | ||||||||||
| BIRCH, Paul | Geschäftsführer | 142 Speke Road L19 2PH Liverpool The Matchworks England England | United Kingdom | British | 76116640004 | |||||||||
| NELSON, Andrew Latham | Geschäftsführer | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London Amey United Kingdom | England | British | 36191090004 | |||||||||
| HUI, Carol | Sekretär | GU8 | British | 72371980001 | ||||||||||
| MANTZ, Ann Elizabeth | Sekretär | 21 Four Wents KT11 2NE Cobham Surrey | British | 37441550001 | ||||||||||
| TETLOW, John Richard | Sekretär | Whittaker Court, Gawsworth New Hall Church Lane, Gawsworth SK11 9RQ Macclesfield Cheshire | British | 68445840001 | ||||||||||
| ADCOCK, Roger Brian | Geschäftsführer | 20 Peter Avenue RH8 9LG Oxted Surrey | England | British | 8738440001 | |||||||||
| ARBUCKLE, John Robert | Geschäftsführer | 2 The Stables Chalke Pyt Broad Chalke SP5 5ET Salisbury Wiltshire | British | 116444950001 | ||||||||||
| ASHLEY, Neil | Geschäftsführer | Burcot Grange Burcot OX14 3DJ Abingdon Oxfordshire | United Kingdom | British | 14069580001 | |||||||||
| BAXTER, Paul | Geschäftsführer | Badgers Sett 16 Bilstone Road CV9 3PP Little Twycross Warwickshire | British | 82266440001 | ||||||||||
| BUTTERS, Nigel Carl | Geschäftsführer | 65 Mount Felix Rivermount KT12 2PJ Walton On Thames Surrey | British | 46089540002 | ||||||||||
| CAWTHORNE, David Alwyn | Geschäftsführer | 21 Park Road RH8 0AN Oxted Surrey | British | 12217320001 | ||||||||||
| COX, Colin Douglas | Geschäftsführer | Dolphin House 13 Wensley Gardens PO10 7RA Emsworth Hampshire | British | 29164670001 | ||||||||||
| DOUGLAS, Richard Colin | Geschäftsführer | Field House 26 Abingdon Road Dorchester On Thames OX10 7JY Wallingford Oxfordshire | British | 14069590002 | ||||||||||
| ENTWISTLE, Richard William | Geschäftsführer | Crossways Crays Pond RG8 7QE Goring Heath Oxfordshire | British | 50174710001 | ||||||||||
| EVELYN-WOOD, Mark William | Geschäftsführer | Holly Lodge 4 Sparrowhawk Close Ewshot GU10 5TJ Farnham Surrey | England | English | 13880480002 | |||||||||
| EWELL, Melvyn | Geschäftsführer | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | England | British | 61515760002 | |||||||||
| HINDLE, David Wilson | Geschäftsführer | Two Ways MK43 8SQ Stagsden Beds | British | 2312780001 | ||||||||||
| HYND, Peter | Geschäftsführer | The Old Hall Sandfield Park L12 Liverpool Merseyside | British | 15266180001 | ||||||||||
| JOHNSON, Peter James | Geschäftsführer | 7 Hall Lane Lydiate L31 4HN Liverpool | England | British | 46649010001 | |||||||||
| KAYSER, Michael Arthur | Geschäftsführer | 17 Hartsbourne Avenue WD23 1JP Bushey Heath Hertfordshire | United Kingdom | British | 141893610001 | |||||||||
| KING, Edmund Alec | Geschäftsführer | Spindlewood Pangbourne Hill RG8 8JS Pangbourne Berkshire | British | 13705700001 | ||||||||||
| LEO, Jose | Geschäftsführer | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | Spanish | 93348510004 | ||||||||||
| LUCAS, William Anthony | Geschäftsführer | Tanglewood Park Close Wilmcote CV37 9XE Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 27693460001 | ||||||||||
| LYNCH, Peter Anthony | Geschäftsführer | Ar-Y-Mynydd Piccadilly Llanblethian CF7 7JL Cowbridge South Glamorgan | British | 29164680001 | ||||||||||
| MILLER, David John | Geschäftsführer | 1 Asmara Road NW2 3SS London | United Kingdom | British | 152304230002 | |||||||||
| MILNER, Andrew Lee | Geschäftsführer | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England | England | British | 133714170002 | |||||||||
| MOGG, Charles Michael | Geschäftsführer | Ladywood Stray Church Road, Wilmcote CV37 9XD Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 87961010001 | ||||||||||
| OSBORNE, Robert Charles | Geschäftsführer | Heath View Bromstead Common TF10 9DG Newport Shropshire | British | 68448420001 | ||||||||||
| PEAT, Martin John | Geschäftsführer | 35 Augusta Avenue Collingtree Park NN4 0XP Northampton Northamptonshire | British | 81709330001 | ||||||||||
| PENYCATE, Christopher John | Geschäftsführer | Sashcu 156 Bullbrook Drive RG12 2QT Bracknell Berkshire | British | 2312770002 | ||||||||||
| PILBEAM, Michael | Geschäftsführer | Sloping Acre Lockeridge SN8 4ED Marlborough Wiltshire | British | 38883200001 | ||||||||||
| STAPLES, Brian Lynn | Geschäftsführer | Pendle House Castle Hill Prestbury SK10 4AR Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 55479560003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei AMEY BUILDING LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amey Limited | 06. Apr. 2016 | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat AMEY BUILDING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating security document | Erstellt am 14. März 2003 Geliefert am 26. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rental deposit deed | Erstellt am 11. Mai 1998 Geliefert am 13. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £15,000 and all other monies due from the company to the chargee under the terms of the lease and this deed | |
Kurze Angaben Rental deposit of £15,000 pursuant to the terms of a lease of even date. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge and assignment | Erstellt am 27. Sept. 1995 Geliefert am 04. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of charge the benefit of the agreement dated 24TH february 1995 and by way of assignment all monies due or owing due to the company under or by virtue of the agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge and assignment | Erstellt am 27. Sept. 1995 Geliefert am 04. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of fixed charge the benefit of an agreement dated 24TH february 1995 relating to land at milton cambridge cambridgeshire and by way of assignment all moneys owing to the company under or by virtue of the agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 08. März 1994 Geliefert am 23. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Details of charged account(s) barclays bank PLC re amey building limited business premium account number 80167568. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0