WALBROOK PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

WALBROOK PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWALBROOK PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02446397
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WALBROOK PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    • (7020) /

    Wo befindet sich WALBROOK PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WALBROOK PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TWIN TOWER PROPERTIES LIMITED15. Dez. 198915. Dez. 1989
    FURLONG DRIVE PROPERTIES LIMITED24. Nov. 198924. Nov. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WALBROOK PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für WALBROOK PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Okt. 2010

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009

    10 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Edward Moody als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    17 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Jan. 2010

    Kapitalaufstellung am 08. Jan. 2010

    • Kapital: GBP 182,900,944.21
    SH01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 31. Dez. 2009

    LRESSP

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 42 Wigmore Street London W1U 2RY am 07. Jan. 2010

    1 SeitenAD01

    Änderung der Details des Direktors für Edward Robert William Moody am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Salmaan Hasan am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Timothy Claude Garnham am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Ivan Howard Ezekiel am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Ivan Howard Ezekiel am 01. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008

    11 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten88(2)

    legacy

    2 Seiten88(2)

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten88(2)

    legacy

    2 Seiten88(2)

    legacy

    2 Seiten88(2)

    Eröffnungsbilanz

    6 SeitenSA

    legacy

    2 Seiten88(2)

    legacy

    1 Seiten123

    Wer sind die Geschäftsführer von WALBROOK PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Sekretär
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    British56155670004
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritish56155670004
    GARNHAM, Timothy Claude
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritish66502160002
    HASAN, Salmaan
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    United KingdomBritish106868320001
    KLEINER, Richard Howard
    26 Atwood Avenue
    Kew
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    Sekretär
    26 Atwood Avenue
    Kew
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    British29866240002
    ROSENFELD, Andrew Ian
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    Sekretär
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    British118467060001
    SHARP, Graham William
    34 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    Sekretär
    34 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    British13331010001
    COSTER, Paul Antony
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    British35406400003
    GARRARD, David Eardley, Sir
    29 Orchard Court
    Portman Square
    W1H 9PA London
    Geschäftsführer
    29 Orchard Court
    Portman Square
    W1H 9PA London
    EnglandBritish76373440001
    MOODY, Edward Robert William
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Great BritainBritish62122950001
    ROSENFELD, Andrew Ian
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    Geschäftsführer
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    SwitzerlandBritish118467060001
    SHARP, Graham William
    34 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    Geschäftsführer
    34 Hans Place
    SW1X 0JZ London
    British13331010001
    THOMPSON, Quentin
    44 Holmewood Gardens
    Brixton Hill
    SW2 3NA London
    Geschäftsführer
    44 Holmewood Gardens
    Brixton Hill
    SW2 3NA London
    British33552230001
    YEWMAN, Steven John
    114 Durham Road
    BR2 0SR Bromley
    Kent
    Geschäftsführer
    114 Durham Road
    BR2 0SR Bromley
    Kent
    British45742320001

    Hat WALBROOK PROPERTY INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 30. Jan. 2008
    Geliefert am 08. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first priority security interest or interests in the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch as Agent and Security Trustee for the Beneficiaries (Thesecured Party)
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 30. Jan. 2008
    Geliefert am 08. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first priority security interest or interests in the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch as Agent and Security Trustee for the Beneficiaries (Thesecured Party)
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Contract assignment
    Erstellt am 03. Nov. 2006
    Geliefert am 08. Nov. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the right, title, benefit and interest of each chargor whatsoever whether present or future, propietary, contractual or otherwise, arising out of or in, to or under any of the assigned agreements including all claims for damages or other remedies in respect of any breach of an assigned agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Postbank Ag London Branch as Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Amendment agreement
    Erstellt am 02. Okt. 2006
    Geliefert am 07. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First priority security interest or interests in the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Postbank Ag London Branch in Its Capacity as Agent and Security Trustee for Thebeneficiaries (The Secured Party)
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 31. Juli 2006
    Geliefert am 09. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The collateral being all right title and interest in and to the shares being 118,422,099 shares in the capital of the company and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch in Its Capacity as Agent and Security Trustee for Thebeneficiaries (The Secured Party)
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 21. März 2006
    Geliefert am 08. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The collateral meaning all right title and interest in and to the units. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch in Its Capacity as Agent and Security Trustee for Thebeneficiaries (Teh Secured Party)
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 30. Jan. 2006
    Geliefert am 07. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and helios property investments limited to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property known as st swithin's house 11-12 st swithin's lane london t/n LN91910, the f/h property known as walbrook house walbrook london t/n NGL70444,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Postbank Ag London Branch as Agent and Security Trustee for the Beneficiaries (Theagent)
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 12. März 1998
    Geliefert am 14. März 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the finance documents (as therein defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bhf-Bank Ag
    Transaktionen
    • 14. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juni 1997
    Geliefert am 11. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from angelmist limited to the chargee and the banks (as defined) under the loan agreement dated 25TH september 1995 and any security document (as defined) whether or not originally owed to the beneficiaries (as defined) and on any account whatsoever; and all liabilities of the company under any security document
    Kurze Angaben
    L/H property k/a quadrant house, the quadrant l/b of sutton surrey t/no : SGL375858; l/h property at wellesley road sutton l/b of sutton ; floating charge over the whole of its undertaking and property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bhf-Bank Ag (The "Agent") as Trustee for Itself and the Beneficiaries (as Defined)
    Transaktionen
    • 11. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Juli 1996
    Geliefert am 31. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or minerva PLC to the chargee under the terms of the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    L/H property being land and buildings on the west side of wellesley road and k/a delta point 35 wellesley road croydon CR9 2YZ t/no:- SGL438985. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bhf-Bank Ag(The Agent)
    Transaktionen
    • 31. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Apr. 1994
    Geliefert am 19. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries and any of them under or pursuant to or as a result of any breach of, as the case may be, the loan agreement, the interst rate hedging agreement, the new interest rate hedging agreement and any other security document to which the company is aparty.
    Kurze Angaben
    L/H land on the west side of wellesley road,croydon and all buildings trade fixtures fixed plant and machinery from time to time on any such property by way of floating charge with the payment and discharge of the secured obligations the whole of the company's undertaking and all its property,agreements rights,assets and income. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chemical Bank
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. März 1990
    Geliefert am 06. Apr. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself and the beneficiaries (as defined therein) under the terms of the facility letter dated 23/03/90, the note, the debenture and any other security document (as defined therein)
    Kurze Angaben
    L/H property on the west side of wellesley road, croydon. L.B. of croydon and buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Elders Real Estate Limited
    Transaktionen
    • 06. Apr. 1990Registrierung einer Belastung
    • 24. Juli 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. März 1990
    Geliefert am 29. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries as defined therein under the terms of the legal agreement dated 23/03/90 the interest rate hedging agreement dated 26/03/90 and any other security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    (Please see doc for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Manufacturers Hanover Trust Company
    Transaktionen
    • 29. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Okt. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. März 1990
    Geliefert am 02. Apr. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the beneficiaries (as defined therein). Under the terms of the agreement, the note, this debenture and any other security documents (as defined therein)
    Kurze Angaben
    (Please see form 395 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Minerva Corporation PLC as Trustee
    Transaktionen
    • 02. Apr. 1990Registrierung einer Belastung
    • 24. Juli 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WALBROOK PROPERTY INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    11. Feb. 2011Aufgelöst am
    31. Dez. 2009Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0