TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED

TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02449641
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?

    • (9999) /

    Wo befindet sich TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HORNGLADE PROJECTS LIMITED14. Aug. 199014. Aug. 1990
    PROPERTY DEVELOPMENT PROJECT LIMITED29. Dez. 198929. Dez. 1989
    HARLACRE LIMITED05. Dez. 198905. Dez. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Ernennung von Mr Stephen Derrick Breach als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Simon Lawton als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Änderung der Details des Direktors für Mr Peter John Martin am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Marcus Lawton am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Richard Hawke Collins am 01. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    11 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten225

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    17 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten353a

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    9 Seiten395

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COLLINS, Richard Hawke
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Sekretär
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    British53398040001
    BREACH, Stephen Derrick
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Geschäftsführer
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    United KingdomBritish147928530001
    MARTIN, Peter John
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Geschäftsführer
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    EnglandBritish176044430001
    BLANKS, Gareth John Ryder
    Little Sir Hughes
    West Hanningfield Road Great Baddow
    CM2 7SZ Chelmsford
    Essex
    Sekretär
    Little Sir Hughes
    West Hanningfield Road Great Baddow
    CM2 7SZ Chelmsford
    Essex
    British89781940001
    CANNINGS, Colin Graham
    20 Red Lion Street
    WC1R 4PS London
    Sekretär
    20 Red Lion Street
    WC1R 4PS London
    British4936580001
    LAWTON, Simon Marcus
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    Sekretär
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    British68807890004
    APPLEBY, Robert
    8 Stevenson Way
    Larkfield
    ME20 6UN Aylesford
    Kent
    Geschäftsführer
    8 Stevenson Way
    Larkfield
    ME20 6UN Aylesford
    Kent
    British100449850001
    BLANKS, Gareth John Ryder
    Little Sir Hughes
    West Hanningfield Road Great Baddow
    CM2 7SZ Chelmsford
    Essex
    Geschäftsführer
    Little Sir Hughes
    West Hanningfield Road Great Baddow
    CM2 7SZ Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish89781940001
    DICKS, Steven Trevor
    60 Penningtons
    CM23 4LF Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    60 Penningtons
    CM23 4LF Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    British72561270001
    GRANGER, Adam
    1 Wormbwell Gardens
    DA11 8BL Northfleet
    Kent
    Geschäftsführer
    1 Wormbwell Gardens
    DA11 8BL Northfleet
    Kent
    EnglandBritish97482630002
    JENKINS, David Charles
    12 Queens Road
    SS7 1JW Benfleet
    Essex
    Geschäftsführer
    12 Queens Road
    SS7 1JW Benfleet
    Essex
    British13763330002
    LAWTON, Simon Marcus
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Geschäftsführer
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    EnglandBritish68807890004
    NEILSON, Lindsay Stewart
    Ash House
    Ash Road New Ash Green
    DA3 8JD Longfield
    Kent
    Geschäftsführer
    Ash House
    Ash Road New Ash Green
    DA3 8JD Longfield
    Kent
    British60819520001
    PITMAN, Henry John
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish55231490005
    TODMAN, Andrew William
    4 St Marys Close
    Laddingford
    ME18 6DG Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    4 St Marys Close
    Laddingford
    ME18 6DG Maidstone
    Kent
    UkBritish115840330001

    Hat TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 14. Juni 2007
    Geliefert am 21. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each group company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 21. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 17. Okt. 2002
    Geliefert am 23. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 24. Apr. 2002
    Geliefert am 30. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Each of the Financeparties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee and debenture between the company (1) and the south place gresham partnership 2000 as trustee for itself and the noteholders ("trustee") (2)
    Erstellt am 14. Dez. 2000
    Geliefert am 28. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due, owing or incurred in whatever manner by the principal (as defined) to any noteholder (as defined) under or in respect of any designated loan note or any other secured party (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The South Place Gresham Partnership 2000
    Transaktionen
    • 28. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Dez. 2000
    Geliefert am 22. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 31. Mai 1995
    Geliefert am 12. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 12. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0