TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02449641 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 87-91 Newman Street London W1T 3EY |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HORNGLADE PROJECTS LIMITED | 14. Aug. 1990 | 14. Aug. 1990 |
| PROPERTY DEVELOPMENT PROJECT LIMITED | 29. Dez. 1989 | 29. Dez. 1989 |
| HARLACRE LIMITED | 05. Dez. 1989 | 05. Dez. 1989 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Ernennung von Mr Stephen Derrick Breach als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Simon Lawton als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter John Martin am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Marcus Lawton am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Richard Hawke Collins am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 11 Seiten | AA | ||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 17 Seiten | AA | ||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||
legacy | 1 Seiten | 353a | ||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||
legacy | 9 Seiten | 395 | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
Wer sind die Geschäftsführer von TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLINS, Richard Hawke | Sekretär | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | British | 53398040001 | ||||||
| BREACH, Stephen Derrick | Geschäftsführer | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | United Kingdom | British | 147928530001 | |||||
| MARTIN, Peter John | Geschäftsführer | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | England | British | 176044430001 | |||||
| BLANKS, Gareth John Ryder | Sekretär | Little Sir Hughes West Hanningfield Road Great Baddow CM2 7SZ Chelmsford Essex | British | 89781940001 | ||||||
| CANNINGS, Colin Graham | Sekretär | 20 Red Lion Street WC1R 4PS London | British | 4936580001 | ||||||
| LAWTON, Simon Marcus | Sekretär | Long Ash Woodbridge Lane Withington GL54 4BP Cheltenham Gloucestershire | British | 68807890004 | ||||||
| APPLEBY, Robert | Geschäftsführer | 8 Stevenson Way Larkfield ME20 6UN Aylesford Kent | British | 100449850001 | ||||||
| BLANKS, Gareth John Ryder | Geschäftsführer | Little Sir Hughes West Hanningfield Road Great Baddow CM2 7SZ Chelmsford Essex | United Kingdom | British | 89781940001 | |||||
| DICKS, Steven Trevor | Geschäftsführer | 60 Penningtons CM23 4LF Bishop's Stortford Hertfordshire | British | 72561270001 | ||||||
| GRANGER, Adam | Geschäftsführer | 1 Wormbwell Gardens DA11 8BL Northfleet Kent | England | British | 97482630002 | |||||
| JENKINS, David Charles | Geschäftsführer | 12 Queens Road SS7 1JW Benfleet Essex | British | 13763330002 | ||||||
| LAWTON, Simon Marcus | Geschäftsführer | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | England | British | 68807890004 | |||||
| NEILSON, Lindsay Stewart | Geschäftsführer | Ash House Ash Road New Ash Green DA3 8JD Longfield Kent | British | 60819520001 | ||||||
| PITMAN, Henry John | Geschäftsführer | Pinbury Park Duntisbourne Rouse GL7 7LG Cirencester Gloucestershire | United Kingdom | British | 55231490005 | |||||
| TODMAN, Andrew William | Geschäftsführer | 4 St Marys Close Laddingford ME18 6DG Maidstone Kent | Uk | British | 115840330001 |
Hat TRIBAL PROPERTY PROJECT MANAGEMENT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 14. Juni 2007 Geliefert am 21. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each group company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 17. Okt. 2002 Geliefert am 23. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Apr. 2002 Geliefert am 30. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture between the company (1) and the south place gresham partnership 2000 as trustee for itself and the noteholders ("trustee") (2) | Erstellt am 14. Dez. 2000 Geliefert am 28. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due, owing or incurred in whatever manner by the principal (as defined) to any noteholder (as defined) under or in respect of any designated loan note or any other secured party (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Dez. 2000 Geliefert am 22. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Mai 1995 Geliefert am 12. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0