NTL CABLECOMMS LANCASHIRE NO. 1

NTL CABLECOMMS LANCASHIRE NO. 1

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNTL CABLECOMMS LANCASHIRE NO. 1
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer 02453249
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NTL CABLECOMMS LANCASHIRE NO. 1?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich NTL CABLECOMMS LANCASHIRE NO. 1?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NTL CABLECOMMS LANCASHIRE NO. 1?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CABLE & WIRELESS COMMUNICATIONS CABLECOMMS LANCASHIRE NO.101. März 199901. März 1999
    NYNEX CABLECOMMS LANCASHIRE NO:1 LIMITED01. Sept. 199301. Sept. 1993
    COMMENT CABLEVISION LANCASHIRE NO: 1 LIMITED11. Dez. 199011. Dez. 1990
    COMMENT CABLEVISION CHESHIRE LIMITED22. Feb. 199022. Feb. 1990
    COMMENT CABLEVISION WIGAN LIMITED18. Dez. 198918. Dez. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NTL CABLECOMMS LANCASHIRE NO. 1?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für NTL CABLECOMMS LANCASHIRE NO. 1?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Änderung der Details des Sekretärs für Gillian Elizabeth James am 31. März 2011

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Robert Charles Gale am 31. März 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Dez. 2011

    Kapitalaufstellung am 20. Dez. 2011

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Ernennung von Joanne Christine Tillbrook als Direktor am 16. Sept. 2011

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Joanne Christine Tillbrook als Geschäftsführer am 16. Sept. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Joanne Christine Tillbrook als Direktor am 16. Sept. 2011

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Robert Mario Mackenzie als Geschäftsführer am 16. Sept. 2011

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    4 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 160 Great Portland Street London W1W 5QA am 01. Apr. 2011

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    4 SeitenAA

    legacy

    25 SeitenMG01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG04

    Ernennung von Gillian Elizabeth James als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Ernennung von Robert Mario Mackenzie als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Virgin Media Secretaries Limited als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Virgin Media Secretaries Limited als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Wer sind die Geschäftsführer von NTL CABLECOMMS LANCASHIRE NO. 1?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Sekretär
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    151351810001
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish96956740001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    ATHERSYCH, Christopher John
    Follye Ghyll The Beechings
    Rotherfield
    TN6 3JQ Crowborough
    East Sussex
    Sekretär
    Follye Ghyll The Beechings
    Rotherfield
    TN6 3JQ Crowborough
    East Sussex
    British78115670003
    DROLET, Robert
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Sekretär
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Canadian48244660002
    JAMES, Gillian Elizabeth
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    Sekretär
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    British72139660001
    LUBASCH, Richard Joel
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    Sekretär
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    British81075820001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Sekretär
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    British47785600002
    MCLEAN, Gregory Joseph
    Thame Cottage Grange Road
    Tilford
    GU10 2DQ Farnham
    Surrey
    Sekretär
    Thame Cottage Grange Road
    Tilford
    GU10 2DQ Farnham
    Surrey
    British33612180001
    MERCER, Edward Peter Opgard
    33 Cluny Street
    BN7 1LN Lewes
    East Sussex
    Sekretär
    33 Cluny Street
    BN7 1LN Lewes
    East Sussex
    British1581580001
    REPP, Paul Howard
    3 Eagle Place
    Roland Way
    SW7 3RG London
    Sekretär
    3 Eagle Place
    Roland Way
    SW7 3RG London
    British36232420001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    ANDERSON, Michael Coplen
    13 Joanna Way
    FOREIGN Kinnelon
    New Jersey 07405
    Usa
    Geschäftsführer
    13 Joanna Way
    FOREIGN Kinnelon
    New Jersey 07405
    Usa
    American4334720001
    BEVERIDGE, Robert James
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    Geschäftsführer
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    United KingdomBritish62452090001
    BLACKBURN, Richard Wallace
    52 Reeder Lane
    New Canaan
    Connecticut 06840 United States Of America
    Geschäftsführer
    52 Reeder Lane
    New Canaan
    Connecticut 06840 United States Of America
    American28865270001
    CARTER, Stephen Andrew
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    Geschäftsführer
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    United KingdomBritish59445920002
    CLARKE, Gregory Allison
    Pinehurst
    Friary Road
    SL5 9HD Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Pinehurst
    Friary Road
    SL5 9HD Ascot
    Berkshire
    British143319900001
    CLESHAM, Philip
    1 The Old House
    Horseshoe Lane
    GU6 8QL Cranleigh
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 The Old House
    Horseshoe Lane
    GU6 8QL Cranleigh
    Surrey
    British70777230001
    CONNELL, Eugene Patrick
    9 Rushmere Place Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5RP London
    Geschäftsführer
    9 Rushmere Place Marryat Road
    Wimbledon
    SW19 5RP London
    American34358920001
    DEW, Bryony
    2 Winton Road
    GU9 9QW Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Winton Road
    GU9 9QW Farnham
    Surrey
    British70776760001
    DROLET, Robert
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Geschäftsführer
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Canadian48244660002
    FARINA, Joseph Carmelo
    50 Riverside Drive
    10024 New York
    Usa
    Geschäftsführer
    50 Riverside Drive
    10024 New York
    Usa
    American35864100001
    GALE, Robert Charles
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    Geschäftsführer
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    EnglandBritish96956740001
    GREGG, John Francis
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    Geschäftsführer
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    American75381740001
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish87146390001
    KILLIAN, John Francis
    Five Anchors
    21 Eriswell Crescent
    KT12 5DS Burwood Park
    Surrey
    Geschäftsführer
    Five Anchors
    21 Eriswell Crescent
    KT12 5DS Burwood Park
    Surrey
    American57965080001
    KNAPP, James Barclay
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Geschäftsführer
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Us Citizen79688880001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Geschäftsführer
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Geschäftsführer
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    MCLEAN, Gregory Joseph
    Thame Cottage Grange Road
    Tilford
    GU10 2DQ Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Thame Cottage Grange Road
    Tilford
    GU10 2DQ Farnham
    Surrey
    British33612180001
    MEARING-SMITH, Nicholas Paul
    Elmfield
    Portsmouth Road
    KT10 9JB Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    Elmfield
    Portsmouth Road
    KT10 9JB Esher
    Surrey
    British2077430001
    MOLYNEUX, Mary Bridget
    33 Saint Jamess Gardens
    W11 4RF London
    Geschäftsführer
    33 Saint Jamess Gardens
    W11 4RF London
    Australian63615470001
    MYERS, Stephen Elmer
    6640 Se South Marina Way
    Stuart Florida 34996
    FOREIGN
    Usa
    Geschäftsführer
    6640 Se South Marina Way
    Stuart Florida 34996
    FOREIGN
    Usa
    Us Citizen10109950001
    RABUFFO, Lawrence Bruce
    Cherrywood
    17 The Barton
    KT11 2NJ Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Cherrywood
    17 The Barton
    KT11 2NJ Cobham
    Surrey
    American36236680002

    Hat NTL CABLECOMMS LANCASHIRE NO. 1 Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 04. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 04. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An alternative bridge composite debenture
    Erstellt am 16. Juni 2006
    Geliefert am 29. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Alternative Bridge Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 29. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 24. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 13. Apr. 2004
    Geliefert am 22. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charges all right, title and interest in: 1) the english charged land 2) the tangible moveable property 3) the accounts 4) the intellectual property 5) any goodwill 6) the investments 7) the shares and all dividends 8) all monetary claims by way of assignment all right, title and interest in: 1) any insurance policy 2) all agreements, contracts, deeds, licences, undertakings 3) chattels hired, leased or rented 4) licences held, by way of floating charge the whole undertaking and assets not effectively charged. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second debenture made by the company in favour of chase manhattan international limited as second security trustee for the secured parties (the "second security trustee")
    Erstellt am 27. Sept. 2001
    Geliefert am 03. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations which the company may at any time have to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under or pursuant to the finance documents (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made under the finance documents, whether present or future, actual or contingent (and whether incurred solely or jointly and whether as principal or as surety or in some other capacity)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited(As Trustee for the Secured Parties on the Terms and Conditions Set Out in the Second Trust Agreement)
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture made by the company in favour of chase manhattan international limited as security trustee for the secured parties (the "security trustee")
    Erstellt am 21. Feb. 2001
    Geliefert am 23. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations which the company may at any time have to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under or pursuant to the finance documents (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made under the finance documents, whether present or future, actual or contingent (and whether incurred solely or jointly and whether as principal or as surety or in some other capacity)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited(As Trustee for the Secured Parties on the Terms and Conditions Set Out in the Security Trust Agreement)
    Transaktionen
    • 23. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture in favour of chase manhattan international limited as security trustee for the secured parties (the "security trustee") on the terms and conditions set out in the security trust agreement
    Erstellt am 28. Juli 2000
    Geliefert am 03. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations which the company may at any time have to the security trustee (as defined) or any of the other secured parties (as defined) under or pursuant to the finance documents (as defined) (including the debenture) and including any liability in respect of any further advances made under the finance documents, whether present or future, actual or contingent on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0