WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED

WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02454379
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DE FACTO 174 LIMITED20. Dez. 198920. Dez. 1989

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 10. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 15,000,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2011

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    18 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2010

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    18 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    18 SeitenAA

    legacy

    10 Seiten395

    legacy

    1 Seiten403b

    legacy

    1 Seiten403b

    legacy

    9 Seiten395

    legacy

    6 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Sekretär
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57-63
    Geschäftsführer
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57-63
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    Geschäftsführer
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    135415010001
    AUTY, Kenneth Ian
    10 Wendron Way
    Idle
    BD10 8TW Bradford
    West Yorkshire
    Sekretär
    10 Wendron Way
    Idle
    BD10 8TW Bradford
    West Yorkshire
    British50948540001
    DOWNES, Jane Claire
    3 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    West Yorkshire
    Sekretär
    3 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    West Yorkshire
    British48088850001
    DOWNES, Jane Claire
    3 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    West Yorkshire
    Sekretär
    3 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    West Yorkshire
    British48088850001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Sekretär
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Sekretär
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Sekretär
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Sekretär
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    PLIMLEY, Martin Wilfred
    The Bungalow Oakwood Grove
    LS8 2PA Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    The Bungalow Oakwood Grove
    LS8 2PA Leeds
    West Yorkshire
    British58693940001
    BATTY, Malcolm Child
    20 Old Hall Road
    WF17 0AX Batley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    20 Old Hall Road
    WF17 0AX Batley
    West Yorkshire
    British30753710001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    British2748600001
    BRIMBLECOMBE, David John
    2 Kirklees Close
    Farsley
    LS28 5TF Leeds
    Geschäftsführer
    2 Kirklees Close
    Farsley
    LS28 5TF Leeds
    British51190580001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    HARROWSMITH, John Anthony
    Plum Tree Cottage
    Low Way Bramham
    LS23 6QT Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Plum Tree Cottage
    Low Way Bramham
    LS23 6QT Wetherby
    West Yorkshire
    British62531490001
    HELLIWELL, David Alistair
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    8 Farndale Close
    Spofforth Hill
    LS22 4XE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish15578740001
    HOPE, Mark Nicholas John
    Kingsley 48 Green Lane
    HG2 9LP Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Kingsley 48 Green Lane
    HG2 9LP Harrogate
    North Yorkshire
    British48039200002
    JONES, Gordon Pearce, Sir
    Bryngower Sitwell Grove
    S60 3AY Rotherham
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Bryngower Sitwell Grove
    S60 3AY Rotherham
    South Yorkshire
    British2677770001
    KNIGHT, Ian Graham
    92 Town Lane
    Thackley
    BD10 8PJ Bradford
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    92 Town Lane
    Thackley
    BD10 8PJ Bradford
    West Yorkshire
    British36849090002
    KNIGHT, Ian Graham
    3 Harehill Close
    Thackley
    BD10 8PG Bradford
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    3 Harehill Close
    Thackley
    BD10 8PG Bradford
    West Yorkshire
    British36849090001
    LEAVESLEY, James David
    Needwood House
    Needwood
    DE13 9PQ Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Needwood House
    Needwood
    DE13 9PQ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish22565050001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Geschäftsführer
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    NEWMAN, James Henry
    Smithy Cottage Newton Kyme
    LS29 9LS Tadcaster
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Smithy Cottage Newton Kyme
    LS29 9LS Tadcaster
    North Yorkshire
    British6036000006
    NEWTON, Trevor
    Upper Park House
    5 Park House Road Low Moor
    BD12 0QB Bradford
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Upper Park House
    5 Park House Road Low Moor
    BD12 0QB Bradford
    West Yorkshire
    British53363050001
    SMITHIES, James Marchant
    109 Marsh Lane
    Shepley
    HD8 8AS Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    109 Marsh Lane
    Shepley
    HD8 8AS Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish37603190001
    SYERS, Alan Matthew
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    135 Temple Lane
    Copmanthorpe
    YO23 3TE York
    North Yorkshire
    EnglandBritish65588650002
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001
    WILSON, Brian Joseph
    5 Fern Way
    Scarcroft
    LS14 3JJ Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Fern Way
    Scarcroft
    LS14 3JJ Leeds
    West Yorkshire
    British13236280002

    Hat WHITE ROSE DEVELOPMENT ENTERPRISES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental security agreement
    Erstellt am 19. Feb. 2009
    Geliefert am 25. Feb. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Units 17A and 17B of that property k/a follingsby park gateshead t/no TY367999 (part thereof). See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag, London Branch as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 25. Feb. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Tenth supplemental trust deed
    Erstellt am 24. Dez. 2008
    Geliefert am 07. Jan. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £100,000,000 11% first mortgage debenture stock 2025 and all moneys due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a units 17A and 17B follingsby park, gateshead t/no TY367999 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    A security agreement
    Erstellt am 24. Dez. 2008
    Geliefert am 07. Jan. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Units 17A and 17B follingsby park, gateshead t/no TY367999 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 19. Sept. 2007
    Geliefert am 26. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Ag,London Branch
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Jan. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Ninth supplemental trust deed
    Erstellt am 15. März 2007
    Geliefert am 03. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property known as unit 1, follingsby park, follingsby avenue, follingsby park, gateshead t/no TY344000; property known as unit 2 follingsby park, follingsby avenue, gateshead t/no TY306533. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Jan. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Supplemental legal mortgage to composite guarantee and debenturedated 27 may 1999
    Erstellt am 17. Jan. 2002
    Geliefert am 02. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the obligors or any of them to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (I) f/hol lnd and buildings known as unit 6A follingsby park,follingsby ave,wardley; t/no ty 344006; (ii) f/hold land/blds known as units 1,1A and 14 follingsby par,follingsby ave,wardley; ty 344000; plus other properties listed. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC,as Security Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession (supplemental to a composite guaranteeand mortgage debenture dated 27 may 1999)
    Erstellt am 12. Jan. 2001
    Geliefert am 25. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the finance documents (or any of them) and/or on any account whatsoever (terms as defined)
    Kurze Angaben
    Freehold and leasehold and and buildings at york business park nether poppletontitle number(s) NYK72823 NYK72824 NYK87325 NYK67562 NYK59785 NYK85871 NYK70416 NYK176559 freehold land and buildings atfollingsby park gateshead title number TY306533 freehold land and buildings at follingsby lane gateshead title number(s)all its right title and interest in andto the leases,the insurances, the assigned documents,the receivables account and any monies and rental income. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself Andthe Beneficiaries
    Transaktionen
    • 25. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. März 1997
    Geliefert am 08. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over f/h land and buildings on the north east side of millfield lane nether poppleton york title number NYK59785, land at ings lane millfield nether poppleton york title number NYK85871, land lying to the south of A1237, nether poppleton york title number NYK70416, land lying to the north east of millfield lane nether poppleton york title number NYK176559, land at poppleton ings york title number NYK72823, land at skelton junction millfield lane nether poppleton york title number NYK72824, l/h land at skelton junction millfield lane york title number NYK87325 land on the south east of ings lane millfield nether poppleton york title number NYK67562 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. März 1997
    Geliefert am 08. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over the freehold land lying to the north side of follingsby lane wardley gateshead title number TY306533 and the freehold land lying to the north of follingsby lane pelaw gateshead title number TY243775 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 27. März 1997
    Geliefert am 08. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. März 1996
    Geliefert am 14. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H land comprising 11.4 acres or thereabouts and situate at nether poppleton north yorkshire t/no:- NYK17615 and fixed and floating charge over all assets of the company.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Water Estates Limited
    Transaktionen
    • 14. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Feb. 1996
    Geliefert am 15. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever (excepting the existing subordinated loan of £615,000 advanced on 1ST february 1993)
    Kurze Angaben
    Land/blds lying to the north of follingsby lane,pelaw gateshead in the county of tyne and wear; t/no ty 243775.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Water Estates Limited
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Dez. 1995
    Geliefert am 15. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the legal charge
    Kurze Angaben
    1. freehold land at poppleton ings york title number nyk 72823 2. freehold land lying to the south of A1237 nether poppleton york title number nyk 70416. 3. freehold land at skelton junction millfield lane nether poppleton york and those other properties detailed on the form M395 and a fixed and floating charge over all the assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Water Estates Limited
    Transaktionen
    • 15. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. März 1995
    Geliefert am 10. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (but excepting the existing subordinated loan advanced on 1ST february 1993)
    Kurze Angaben
    78 acres 770 square yards approx situate at follingsby county of tyne and wear with a fixed and floating charge over all the assets.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Water Estates Limited
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 1993
    Geliefert am 03. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and premises at thorp arch leeds west yorkshire a fixed and flaoting charge over all the assets present and future of the borrower for full details see form 395.
    Berechtigte Personen
    • Yw Enterprises LTD
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 1993
    Geliefert am 03. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H and f/h properties on the north side of varley st leeds west yorkshire t/nos WYK486001 WYK486002 and wyk 486004 a fixed and floating charge over all the assets of the borrower present and future for full details see form 395.
    Berechtigte Personen
    • Yw Enterprises LTD
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 1993
    Geliefert am 03. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at owlcotes hill stanningley leeds west yorkshire t/n wyk 464352A fixed and floating charge over all the assets present and future of the borrower.
    Berechtigte Personen
    • Yw Enterprises LTD
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 1993
    Geliefert am 03. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a leigh house varley st stanningley leeds west yorkshire for full details see form 395.
    Berechtigte Personen
    • Yw Enterprises LTD
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Aug. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 1993
    Geliefert am 03. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and premises k/a apex quarry butcher hill horsforth west yorkshire t/n wyk 345268 a fixed and floating charge over all the assets present and future of the borrower.
    Berechtigte Personen
    • Yw Enterprises LTD
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 1993
    Geliefert am 03. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and premises on the s/w side of commercial rd kirkstall leeds west yorkshire t/n wyk 60216 a fixed and floating charge over all the assets present and future of the borrower.
    Berechtigte Personen
    • Yw Enterprises LTD
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 1993
    Geliefert am 03. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and premises k/a citygate wellington st leeds west yorkshire t/n wyk 219237 a fixed and floating charge over all the assets present and future of the borrower.
    Berechtigte Personen
    • Yw Enterprises LTD
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 1993
    Geliefert am 03. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and premises k/a priestly mills swinnow green pudsey west yorkshire t/n YWE58726 fixed and floating charge over all the assets present and future of the borrower.
    Berechtigte Personen
    • Yw Enterprises Limited
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental mortgage
    Erstellt am 10. Jan. 1992
    Geliefert am 13. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The benefit of an agreement dated 2ND december 1991 between (1) white rose development enterprises limited and (2) safeway PLC. Relating to land at chow dene bank team valley gateshead (formerly k/a coal house) all proceeds of sale and all monies received under the agreement described.
    Berechtigte Personen
    • Yw Enterprises Limited.
    Transaktionen
    • 13. Jan. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Mai 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 30. Sept. 1991
    Geliefert am 01. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Benefit of an agreement for lease dated 30/3/90 benefit of an agreement dated 27/12/90 and proceeds of sale.
    Berechtigte Personen
    • Yw Enterprises Limited
    Transaktionen
    • 01. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 16. Mai 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0