UNIVERSAL MEATS (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | UNIVERSAL MEATS (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02454386 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von UNIVERSAL MEATS (UK) LIMITED?
- Großhandel mit Fleisch und Fleischwaren (46320) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich UNIVERSAL MEATS (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von UNIVERSAL MEATS (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für UNIVERSAL MEATS (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 150 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Dez. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 24. März 2022 | 150 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Change of details for Tyson Foods Uk Limited as a person with significant control on 08. März 2021 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Dez. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Oaks, Apex 12 Old Ipswich Road Ardleigh Colchester CO7 7QR England zum The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG am 26. Apr. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2020 bis 07. März 2021 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 43 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 43 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 17. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Biltz Elser als Direktor am 21. Feb. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Gibbs als Geschäftsführer am 21. Feb. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Dez. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Brf Invicta Limited as a person with significant control on 23. Aug. 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
legacy | 27 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 27 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 28. Feb. 2019 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von UNIVERSAL MEATS (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLYDE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 138 Houndsditch EC3A 7AR London St Boltoph Building England |
| 38770650001 | ||||||||||
| CALAWAY, Curt | Geschäftsführer | 32 London Bridge Street SE1 9SG London The Shard | United States | American | 259746950001 | |||||||||
| ELSER, Mark Biltz | Geschäftsführer | 32 London Bridge Street SE1 9SG London The Shard | United States | American | 267706220001 | |||||||||
| VAN DE BOVENKAMP, Brett | Geschäftsführer | Old Ipswich Road Ardleigh CO7 7QR Colchester The Oaks, Apex 12 England | United Kingdom | American | 261435090001 | |||||||||
| BURKE, Susan | Sekretär | Hall Place Stone Street, Seal TN15 0LG Sevenoaks Kent | British | 21557860003 | ||||||||||
| NORTON, Colin | Sekretär | Upper Pemberton Boughton Aluph TN25 4AZ Ashford 130 Eureka Park Kent England | 205292220001 | |||||||||||
| BANFI, Roberto | Geschäftsführer | Upper Pemberton Boughton Aluph TN25 4AZ Ashford 130 Eureka Park Kent England | Austria | Italian | 205809370001 | |||||||||
| BIFFI, Djavan | Geschäftsführer | 1110 Vienna Guglgasse 17/5/1.Og Austria | Austria | Brazilian | 211074590001 | |||||||||
| BURKE, Alan Jeffrey | Geschäftsführer | Hall Place Stone Steet Seal TN15 0LG Sevenoaks Kent | England | British | 65227040001 | |||||||||
| BURKE, Susan | Geschäftsführer | Hall Place Stone Street, Seal TN15 0LG Sevenoaks Kent | England | British | 21557860003 | |||||||||
| CHENG, Simon | Geschäftsführer | 1110 Vienna Guglgasse 17/5/1.Og Austria | Singapore | Brazilian | 240300040001 | |||||||||
| COELHO, Rodrigo Alves | Geschäftsführer | 1110 Vienna Guglgasse 17/5/1.Og Austria | Austria | Brazilian | 204593080001 | |||||||||
| GIBBS, Stephen | Geschäftsführer | Old Ipswich Road Ardleigh CO7 7QR Colchester The Oaks, Apex 12 England | United States | American | 259767250001 | |||||||||
| HAMADA, Daniel Paulo | Geschäftsführer | 1110 Vienna Guglgasse 17/5/1.Og Austria | Singapore | Brazilian | 240300180001 | |||||||||
| NORTON, Colin James | Geschäftsführer | Upper Pemberton Boughton Aluph TN25 4AZ Ashford 130 Eureka Park Kent England | United Kingdom | British | 91349590003 | |||||||||
| PEREIRA, Rubens Fernandes | Geschäftsführer | Old Ipswich Road Ardleigh CO7 7QR Colchester The Oaks, Apex 12 England | Brazil | Brazilian | 253444380001 | |||||||||
| PEROTTONI, Jose Lourenco | Geschäftsführer | 1110 Vienna Guglgasse 17/5/1.Og Austria | Austria | Brazilian | 219821920001 | |||||||||
| ROWE, Jeffrey Brian | Geschäftsführer | 39 Great Nelmes Chase Emerson Park RM11 2PS Hornchurch Essex | England | British | 13519440001 | |||||||||
| RUDECK, Dalvi Marcelo | Geschäftsführer | Upper Pemberton Kennington TN25 4AZ Ashford Eureka Park (Units 130-140) England | England | Brazilian | 211074430001 | |||||||||
| VAN KREIJ, Remy Marinus Antonius Johannes | Geschäftsführer | Hall Place Stone Street, Seal TN15 0LG Sevenoaks Kent | England | Dutch | 188501400001 | |||||||||
| WIGMAN, Marcelo Josef | Geschäftsführer | 1110 Vienna Guglgasse 17/5/1.Og Austria | Austria | Dutch | 219745050001 | |||||||||
| WOFFINDIN, Samantha Ann | Geschäftsführer | 58 Meadow Road RM16 2ET Grays Essex | United Kingdom | British | 116553870003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei UNIVERSAL MEATS (UK) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Foods Uk Holding Limited | 06. Apr. 2016 | Upper Pemberton Kennington TN25 4AZ Ashford 130 Eureka Park England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat UNIVERSAL MEATS (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| All assets debenture | Erstellt am 07. Nov. 2011 Geliefert am 09. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 06. Apr. 1999 Geliefert am 13. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a the cottage hall place seal sevenoaks kent t/no.K475304 & part t/nos.K452527, K668891, K708890. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over contract | Erstellt am 15. Juli 1998 Geliefert am 28. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that benefit of euler trade indemnity policy no BJ02/98/100954801. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 11. Juni 1998 Geliefert am 22. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben £120,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on account numbered 50661140 and earmarked or designated by eference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 29. Mai 1998 Geliefert am 18. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 14. Feb. 1997 Geliefert am 04. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a guarantee dated 10TH february 1997 in favour of h m customs & excise for £40,000 | |
Kurze Angaben £80,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 50636154 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 20. Juli 1992 Geliefert am 24. Juli 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond dated D20/7/92 FORFF801,350 to maitre mochel robert administrative judiciave sur la liste nationalef | |
Kurze Angaben The sum of £85,000 with interest held bythe chargee on a/c no.50509756 And earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat UNIVERSAL MEATS (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0