CERACRYL LABORATORIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CERACRYL LABORATORIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02456262 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CERACRYL LABORATORIES LIMITED?
- Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich CERACRYL LABORATORIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Bupa Dental Care Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CERACRYL LABORATORIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CERACRYL LABORATORIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Ernennung von Gabriela Pueyo Roberts als Direktor am 01. Feb. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Catherine Elizabeth Barton als Geschäftsführer am 05. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Edward Joseph Coyle als Geschäftsführer am 14. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Dr Steven John Preddy als Direktor am 14. Sept. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 8 Seiten | AA | ||
legacy | 48 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Ms Catherine Elizabeth Barton als Direktor am 28. Feb. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von David Jon Leatherbarrow als Geschäftsführer am 28. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2018 bis 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Bupa House 15-19 Bloomsbury Way London WC1A 2BA England zum 1 Angel Court London EC2R 7HJ geändert | 1 Seiten | AD02 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Bupa Secretaries Limited am 08. Dez. 2017 | 1 Seiten | CH04 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Compliance Manager Oasis Support Centre, Vantage Office Park Old Gloucester Road Hambrook Bristol BS16 1GW zum Bupa Dental Care Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook Bristol BS16 1GW am 27. Nov. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||
Change of details for Jdh Holdings Ltd as a person with significant control on 24. Nov. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 10 Seiten | AA | ||
legacy | 44 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
Ernennung von Mr Jake Stephen Hockley Wright als Direktor am 30. Juni 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Julian Francis Perry als Geschäftsführer am 30. Juni 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von CERACRYL LABORATORIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom |
| 162768400001 | ||||||||||
| PREDDY, Steven John, Dr | Geschäftsführer | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | United Kingdom | British | 250614010001 | |||||||||
| PUEYO ROBERTS, Gabriela | Geschäftsführer | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | Spain | Spanish | 254904830001 | |||||||||
| WRIGHT, Jake Hockley | Geschäftsführer | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | United Kingdom | British | 184341770001 | |||||||||
| BERRY, Stephen Richard | Sekretär | 27 Victoria Road Penarth CF64 3HY Cardiff South Glamorgan | British | 117104600001 | ||||||||||
| POWIS, Sarah | Sekretär | 104 Princess Victoria Street Clifton Village BS8 4DB Bristol | British | 91325010002 | ||||||||||
| WHITELEY, Alan | Sekretär | 2 The Court Corntown CF35 5BJ Bridgend Mid Glamorgan | British | 59879390001 | ||||||||||
| OASIS HEALTHCARE LIMITED | Sekretär | c/o Compliance Manager Old Gloucester Road Hambrook BS16 1GW Bristol Oasis Support Centre, Vantage Office Park England |
| 163513320001 | ||||||||||
| QUAYSECO LIMITED | Sekretär | Glass Wharf BS2 0ZX Bristol One |
| 146837890001 | ||||||||||
| ASH, Justinian Joseph | Geschäftsführer | c/o Compliance Manager Old Gloucester Road Hambrook BS16 1GW Bristol Oasis Support Centre, Vantage Office Park England | England | British | 188659180001 | |||||||||
| BARTON, Catherine Elizabeth | Geschäftsführer | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | England | British | 243693740001 | |||||||||
| BRAMALL, Colin Stephen | Geschäftsführer | Eastern Building Park CF3 5EA St. Mellons Building 1 Cardiff | United Kingdom | British | 155983960002 | |||||||||
| COYLE, Edward Joseph, Dr | Geschäftsführer | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | United Kingdom | British | 200405130002 | |||||||||
| HULL, James Desmond, Doctor | Geschäftsführer | 13 Brunswick Gardens W8 4AS London | England | British | 95331820002 | |||||||||
| LEATHERBARROW, David Jon | Geschäftsführer | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | England | British | 135618280010 | |||||||||
| MAGRATH, Bryan Robert | Geschäftsführer | Curzon Street W1J 7UW London 50 United Kingdom | England | British | 159813330001 | |||||||||
| O'NEILL, Emmet Eugene | Geschäftsführer | c/o Compliance Manager Old Gloucester Road Hambrook BS16 1GW Bristol Oasis Support Centre, Vantage Office Park England | Ireland | Irish | 171421220001 | |||||||||
| PERRY, Julian Francis | Geschäftsführer | c/o Compliance Manager Old Gloucester Road Hambrook BS16 1GW Bristol Oasis Support Centre, Vantage Office Park England | England | British | 84437900002 | |||||||||
| PUGH, Robin James Mostyn | Geschäftsführer | BS2 0ZX Bristol One Glass Wharf United Kingdom | United Kingdom | British | 64458370003 | |||||||||
| RAETHORNE, David William | Geschäftsführer | c/o Compliance Manager Old Gloucester Road Hambrook BS16 1GW Bristol Oasis Support Centre, Vantage Office Park England | Ireland | Irish | 171537250001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CERACRYL LABORATORIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jdh Holdings Ltd | 06. Apr. 2016 | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CERACRYL LABORATORIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 07. Mai 2013 Geliefert am 11. Mai 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Dez. 2010 Geliefert am 22. Dez. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security accession deed | Erstellt am 13. Dez. 2010 Geliefert am 22. Dez. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all material properties and assets including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security accession deed | Erstellt am 13. Dez. 2010 Geliefert am 22. Dez. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all material properties and assets including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. März 2006 Geliefert am 04. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Apr. 2001 Geliefert am 04. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (other than dividend on any shares) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Jan. 1999 Geliefert am 09. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. März 1997 Geliefert am 27. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0