HALIFAX CABLE COMMUNICATIONS LIMITED

HALIFAX CABLE COMMUNICATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHALIFAX CABLE COMMUNICATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02459173
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HALIFAX CABLE COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Sonstige Telekommunikationsaktivitäten (61900) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich HALIFAX CABLE COMMUNICATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HALIFAX CABLE COMMUNICATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TELECABLE OF CALDERDALE LIMITED 26. Sept. 199026. Sept. 1990
    TELECABLE OF CALDERDALE AND KIRKLEES LIMITED30. Jan. 199030. Jan. 1990
    LEGIBUS 1490 LIMITED12. Jan. 199012. Jan. 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HALIFAX CABLE COMMUNICATIONS LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2015
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2016
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für HALIFAX CABLE COMMUNICATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Nov. 2016

    8 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 Seiten4.71

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire United Kingdom RG27 9UP verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire United Kingdom RG27 9UP geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP zum 1 More London Place London United Kingdom SE1 2AF am 24. Nov. 2015

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 05. Nov. 2015

    LRESSP

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    16 SeitenAA

    legacy

    94 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Erfüllung der Belastung 024591730014 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 024591730017 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 024591730015 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 024591730016 vollständig

    4 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung 024591730017, erstellt am 28. Jan. 2015

    90 SeitenMR01

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 12. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    18 SeitenAA

    legacy

    92 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    Wer sind die Geschäftsführer von HALIFAX CABLE COMMUNICATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Sekretär
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    151215870001
    DUNN, Robert Dominic
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish182167230001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Sekretär
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Sekretär
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    British8207040001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Geschäftsführer
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    CAMPBELL-ROSS, Roderick Clavil Hakewill
    9 Moorlands
    LS29 9QZ Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    9 Moorlands
    LS29 9QZ Ilkley
    West Yorkshire
    British73356750005
    CAMPBELL-ROSS, Roderick Clavil Hakewill
    56 Cambridge Road
    TW1 2HL East Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    56 Cambridge Road
    TW1 2HL East Twickenham
    Middlesex
    British & South African73356750002
    CHIA, Choon Wei, Doctor
    32 Adis Road
    01-41 Sophia Court
    Singapore 0922
    Geschäftsführer
    32 Adis Road
    01-41 Sophia Court
    Singapore 0922
    Singaporean35806810001
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Geschäftsführer
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    COSGROVE, Charles Henry
    52 Oxley Road
    Valley Mansion
    0923 Singapore
    Geschäftsführer
    52 Oxley Road
    Valley Mansion
    0923 Singapore
    American36156420001
    GALE, Robert Charles
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish96956740001
    GALTEAU, Philippe Xavier
    10 Rue De La Cure
    75016 Paris
    France
    Geschäftsführer
    10 Rue De La Cure
    75016 Paris
    France
    French34577670001
    GRAY, Ian
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    Geschäftsführer
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    United KingdomBritish50246030004
    HARDY, George James Allan
    9 Regents Park Terrace
    NW1 7EE London
    Geschäftsführer
    9 Regents Park Terrace
    NW1 7EE London
    United KingdomBritish2276710001
    HERRING, Gordon Rea
    1489 Trading Point Lane
    Virginia Beach Virginia 23452
    FOREIGN
    Usa
    Geschäftsführer
    1489 Trading Point Lane
    Virginia Beach Virginia 23452
    FOREIGN
    Usa
    American2523390001
    HO, Alan Boon Teck
    1 Moorlands
    Westwood Drive
    LS29 9QZ Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    1 Moorlands
    Westwood Drive
    LS29 9QZ Ilkley
    West Yorkshire
    British38041190001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    Geschäftsführer
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    ILLSLEY, Anthony Kim
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish43836970001
    LEA, Page Gravely
    1102 Ditchley Road
    Virginia Beach Virginia 23451
    FOREIGN
    Usa
    Geschäftsführer
    1102 Ditchley Road
    Virginia Beach Virginia 23451
    FOREIGN
    Usa
    American2523400001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    MASSEY, Bruce Madison
    Brook House
    Hardings Lane Middleton
    LS29 0BB Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Brook House
    Hardings Lane Middleton
    LS29 0BB Ilkley
    West Yorkshire
    American27256040001
    MILLER, David John
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    Geschäftsführer
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    United KingdomBritish152304230002
    NOBLET, Marc Marie Bruno
    10 Rue Lafayette
    Versailles 78000
    France
    Geschäftsführer
    10 Rue Lafayette
    Versailles 78000
    France
    French39159970001
    RITTER JNR, Alfred Francis
    1555 Blandford Circle
    Norfolk Virginia 23505
    FOREIGN
    Usa
    Geschäftsführer
    1555 Blandford Circle
    Norfolk Virginia 23505
    FOREIGN
    Usa
    American2523410001
    ROBERTS, Richard David
    6121 Studeley Avenue
    Norfolk Virginia 23508
    Geschäftsführer
    6121 Studeley Avenue
    Norfolk Virginia 23508
    American2523420001
    RYAN, Louis F
    854 Jamestown Crescent
    23508 Norfolk
    Virginia
    Usa
    Geschäftsführer
    854 Jamestown Crescent
    23508 Norfolk
    Virginia
    Usa
    American53419240002
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    British79956240002
    STENHAM, Anthony William Paul
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    Geschäftsführer
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    British8281170001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TURNER, John Charles
    25 Fontarabia Road
    SW11 5PE London
    Geschäftsführer
    25 Fontarabia Road
    SW11 5PE London
    British45740430001
    VAN VALKENBURG, David Raynor
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    Geschäftsführer
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    American53941940001

    Hat HALIFAX CABLE COMMUNICATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 28. Jan. 2015
    Geliefert am 06. Feb. 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 15. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 04. Apr. 2014
    Geliefert am 10. Apr. 2014
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 15. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 28. März 2014
    Geliefert am 02. Apr. 2014
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 02. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 15. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 07. Juni 2013
    Geliefert am 14. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag,London Branch
    Transaktionen
    • 14. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 15. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Confirmation deed
    Erstellt am 03. März 2011
    Geliefert am 15. März 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the security trustee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the issuance of the new notes, the new guarantees and the new indenture and the transactions contemplated thereby and hereby confirms all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of liens under and subject to the terms of the liens, the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 15. März 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 15. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 10. Juni 2010
    Geliefert am 18. Juni 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the chargee and the senior finance parties (or any one or more of them) and the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 18. Juni 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 15. Mai 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 31. Dez. 1997
    Geliefert am 20. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability which the company may on or after 31ST december 1997 have to the chargee (whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the operative documents (including the debenture) and pay to the chargee when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) on or after 31ST december 1997 owing due or incurred by the company to the chargee in respect of any such liabilities (the secured obligations)
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the real property being all estates and other interests in freehold leasehold and other immovable property and all buildings trade and other fixtures, the tangible movable property being all headend equipment all switch equipment all wire cable computer software, all goodwill and rights by way of first floating charge the whole of the undertaking and assets (for full details please refer to form 395 and continuation sheets). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Robert Fleming Leasing (Number 4) Limited
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Dez. 1997
    Geliefert am 20. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability which the company may on or after 31ST december 1997 have to the chargee (whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the operative documents (including the debenture) and pay to the chargee when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) on or after 31ST december 1997 owing due or incurred by the company to the chargee in respect of any such liabilities (the secured obligations)
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the real property being all estates and other interests in freehold leasehold and other immovable property and all buildings trade and other fixtures, the tangible movable property being all headend equipment all switch equipment all wire cable computer software, all goodwill and rights by way of first floating charge the whole of the undertaking and assets (for full details please refer to form 395 and continuation sheets). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard Commercial Limited
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Dez. 1997
    Geliefert am 20. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability which the company may on or after 31ST december 1997 have to the chargee (whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the operative documents (including the debenture) and pay to the chargee when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) on or after 31ST december 1997 owing due or incurred by the company to the chargee in respect of any such liabilities (the secured obligations)
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the real property being all estates and other interests in freehold leasehold and other immovable property and all buildings trade and other fixtures, the tangible movable property being all headend equipment all switch equipment all wire cable computer software, all goodwill and rights by way of first floating charge the whole of the undertaking and assets (for full details please refer to form 395 and continuation sheets). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Natwest Specialist Finance Limited
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Dez. 1997
    Geliefert am 20. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability which the company may on or after 31ST december 1997 have to the chargee (whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the operative documents (including the debenture) and pay to the chargee when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) on or after 31ST december 1997 owing due or incurred by the company to the chargee in respect of any such liabilities (the secured obligations)
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the real property being all estates and other interests in freehold leasehold and other immovable property and all buildings trade and other fixtures, the tangible movable property being all headend equipment all switch equipment all wire cable computer software, all goodwill and rights by way of first floating charge the whole of the undertaking and assets (for full details please refer to form 395 and continuation sheets). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Natwest Specialist Finance Limited
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Dez. 1997
    Geliefert am 15. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the beneficiaries) on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (including the debenture)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all undertaking property and assets present and future including goodwill intellectual property benefit of licences all earnings all debts shares and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Dez. 1996
    Geliefert am 10. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability now due or to become due from the company to the chargee under the terms of the operative docuemnts (as defined) and this debenture
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all its real property and all its tangible movable property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Natwest Specialist Finance Limited
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Dez. 1996
    Geliefert am 10. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability which the company may on or after 24TH december, 1996 have to the chargee (wether soley or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the operative documents (including the debenture) and pay to the chargee when due and payable every sum (of principal, interest or otherwise) on or after 24TH december, 1996 owing, due or incurred by the company to the chargee in respect of any such liabilities (the "secured obligations") provided that every payment by the company of any sum in respect of the liabilities covenanted to be discharged in clause 2.1 of the debenture by the company to or for the account of the chargee which is made in accordance with the terms of the operative document under which such sum is payable to the chargee shall operate in satisfaction pro tanto of such covenant
    Kurze Angaben
    The company charges in favour of the lessor by way of fixed charge (a) the real property; (b) its tangible movable property; (c) subject to clause 9.3 of the debenture, all rights and claims to which the company is on or may after the 24TH december 1996 become entitled in relation to all moneys on or at any time after 24TH december 1996 standing to the credit of any bank accounts (including each charged account and each lessor collateral account but excluding each lc collateral account and each transit account) together with all rights and claims relating or attaching thereto (including the right to interest); (d) the intellectual property; (e) all goodwill (including all brand names not otherwise subject to a fixed charge or assignment by or pursuant to the debenture) on or at any time after the 24TH december 1996 belonging to the company;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Robert Fleming Leasing (Number 4) Limited
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Dez. 1996
    Geliefert am 10. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the operative documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard Commercial Limited
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Dez. 1996
    Geliefert am 09. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "facility documents" (as defined in the debenture)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Juli 1996
    Geliefert am 22. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the company to the trustee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the facility documents (as defined)
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the real property, its tangible movable property, all rights and claims the company may after 4 july 1996 be entitled in relation to monies standing to the credit of any bank account the intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 1994
    Geliefert am 23. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the financing documents (as defined in the debenture)
    Kurze Angaben
    First floating charge over all assets (as defined) other than (I) any real property (as defined) and (ii) all or any of the company's rights (as defined) under or in connection with all present and future licences (as defined), environmental licences (as defined) and any other necessary authorisations (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Robert Fleming & Co. Limited
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat HALIFAX CABLE COMMUNICATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Mai 2017Aufgelöst am
    05. Nov. 2015Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Derek Hyslop
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0