BL HC INVIC LEISURE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBL HC INVIC LEISURE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02464159
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INVICTA LEISURE LIMITED26. Jan. 199026. Jan. 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2022

    Welche sind die letzten Einreichungen für BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Feb. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Cessation of Bl Hc Health and Fitness Holdings Limited as a person with significant control on 25. Nov. 2022

    1 SeitenPSC07

    Notification of Bl Retail Warehousing Holding Company Limited as a person with significant control on 25. Nov. 2022

    2 SeitenPSC02

    Beendigung der Bestellung von Katherine Fyfe als Geschäftsführer am 17. Okt. 2022

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Katherine Fyfe am 20. Juli 2022

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mrs Katherine Fyfe als Direktor am 20. Juli 2022

    2 SeitenAP01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    23. Mai 2023Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 23rd May 2023 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022

    5 SeitenAA

    Kapitalaufstellung am 21. Apr. 2022

    • Kapital: GBP 1.00
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beendigung der Bestellung von Charles John Middleton als Geschäftsführer am 31. März 2022

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Gavin Bergin als Direktor am 18. März 2022

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Sarah Morrell Barzycki als Geschäftsführer am 18. März 2022

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Jonathan Charles Mcnuff als Geschäftsführer am 18. März 2022

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Nick Taunt als Direktor am 18. März 2022

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Nigel Mark Webb als Geschäftsführer am 18. März 2022

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Paul Stuart Macey als Geschäftsführer am 18. März 2022

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Sekretär
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer8992198
    187856670001
    BERGIN, Gavin
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish251327820001
    TAUNT, Nicholas Henry
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish275050860001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Sekretär
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    British58961410002
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Sekretär
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    162246380001
    FALLOWS, Michael Joseph
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    Sekretär
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    British58345490001
    SCALES, Eugene Patrick
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Sekretär
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Other124193970001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Sekretär
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    British113777700001
    WEATHERLEY, Kenneth Frank
    8 Langtons Court
    Sun Lane
    SO24 9UE Alresford
    Hampshire
    Sekretär
    8 Langtons Court
    Sun Lane
    SO24 9UE Alresford
    Hampshire
    British50477690001
    WONG, Wai Chung
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    Sekretär
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    British123616460002
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Geschäftsführer
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritish58961410002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish32809050044
    BRAINE, Anthony
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish32809000002
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish170891060001
    CHARLTON, Stephen Paul
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    Geschäftsführer
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritish96743210001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish146698270001
    CONNON, Daniel Francis
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    British35128740001
    COUPE, David John
    1 Chelsea House
    13 Edith Grove
    SW10 0JZ London
    Geschäftsführer
    1 Chelsea House
    13 Edith Grove
    SW10 0JZ London
    United KingdomBritish125432970002
    CREED, Stuart John
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    Geschäftsführer
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    United KingdomBritish3716600001
    CURRY, John Arthur Hugh
    Stokewood Park House Sheardley Lane
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    Geschäftsführer
    Stokewood Park House Sheardley Lane
    Droxford
    SO32 3QY Southampton
    EnglandBritish2968140002
    DAVIES, Rhian Lynn
    32 Caldervale Road
    SW4 9LZ Clapham
    London
    Geschäftsführer
    32 Caldervale Road
    SW4 9LZ Clapham
    London
    British48466920001
    DHODY, Jog
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish104269910002
    DICKSON, Peter Alan
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Pointer House Farm
    Langley Lane Goosnargh
    PR3 2JS Preston
    Lancashire
    British13332510001
    FALLOWS, Michael Joseph
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    Geschäftsführer
    11 Greville Drive
    Edgbaston
    B15 2UU Birmingham
    EnglandBritish58345490001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish1898090001
    FYFE, Katherine
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish293284010001
    GIBSON, Clive Patrick, The Honourable
    Monmouth House
    29a Hyde Park Gate
    SW7 5DJ London
    Geschäftsführer
    Monmouth House
    29a Hyde Park Gate
    SW7 5DJ London
    British45468220001
    GILLIS, Neil Duncan
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    EnglandBritish69204500003
    GRIFFITHS, Paul Richard
    21 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9EF London
    Geschäftsführer
    21 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9EF London
    British54611260001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    GUYER, Paul John
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    British100971720002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    LEATHERBARROW, David Jon
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish135618280002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BL HC INVIC LEISURE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Bl Retail Warehousing Holding Company Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    25. Nov. 2022
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland
    Registrierungsnummer06002154
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Bl Hc Health And Fitness Holdings Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06. Apr. 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Ja
    RechtsformPrivate Company Limited By Shares
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat BL HC INVIC LEISURE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 18. Juni 2009
    Geliefert am 26. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 26. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment of receivables
    Erstellt am 18. Juni 2009
    Geliefert am 26. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title and interest in and to the receivables see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Esporta Financial Services Limited
    Transaktionen
    • 26. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juli 2009
    • 08. Feb. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Group debenture
    Erstellt am 08. Feb. 2006
    Geliefert am 18. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties)(in Such Capacity the "Security Agent")
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Jan. 2004
    Geliefert am 07. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any other member of the group to the note finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electra Partners Europe Limited as Noteholders' Agent and Noteholders' Security Trustee Andnoteholders Security Trust (The "Noteholders' Security Trustee")
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Jan. 2004
    Geliefert am 03. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any member of the group (meaning the borrower or its subsidiaries from time to time) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Dukes meadow chiswick hounslow t/no NGL147830; imperial way croydon surrey t/no SGL454522; llandarcy neath swansea t/no CYM43829 and WA953690 for details of further properties charged please refer to form 395 unscheduled property, rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, reights as tenant, book and other debts, bank accounts, charged securities, uncalled capital , goodwill, intellectual property, licences, credit agreements, contracts floating charge undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 09. Sept. 2003
    Geliefert am 12. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H premises together with buildings erected on them k/a the bridgend health & fitness club, waterton park, waterton lane, bridgend, mid glamorgan together with all buildings and fixtures thereon and the proceeds of sale or any part thereon, all other estates or interests in the property and any rights under any licence or other agreement fixed charge present and future book and other debts, all equipment owned present and future , the benefit of all licences, permissions, consents and authorisations present and future, benefits of all insurance by way of assignment all its right, title and interest in and to all contracts and insurances.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 05. Sept. 2002
    Geliefert am 09. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the issuer and by each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage all properties now owned by or vested in each charging company including t/n HS293663 humberston country club, humberston avenue, grimsby. T/n HS293701 humberston country club, humberston avenue, grimsby and leasehold unit 9C, upper winbury farm, wingrave, aylesbury, buckinghamshire. By way of first fixed mortgage the securities, first fixed charge all properties thereafter acquired, all present and future interests in or over freehold or leasehold property; all present and future rights, licences, guarantees, rents, deposits, contracts, covenants and warranties relating to the properties.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Electra Partners Europe Limited (As Noteholders' Agent and Noteholders' Security Agent for Thenote Finance Parties)
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit deed
    Erstellt am 14. Juni 2001
    Geliefert am 28. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £100,000 including all monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The deposit and all rights titles and benefits whatsoever present and future therein.
    Berechtigte Personen
    • Arrowcroft Leisure Limited
    Transaktionen
    • 28. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit deed
    Erstellt am 18. Apr. 2000
    Geliefert am 26. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £100,000 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Charge over the deposit of £100,000.
    Berechtigte Personen
    • Arrowcroft Leisure Limited
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. Okt. 1999
    Geliefert am 28. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and security trustee for the finance parties (as therein defined)) on any account whatsoever, under or in connection with the financing documents (including, without limitation, the guarantee and debenture)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 28. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. März 1999
    Geliefert am 24. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings lying to the north of humberston avenue humberston north east lincolnshire t/no;-HS228117 together with goodwill of any business carried on at the property and all right title and interest in and to the "acquisition documents" (as defined in the charge). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Kingsway Nominees Limitedas Trustee on Behalf of Electra Fleming Privateequity Partners (The Lender)
    Transaktionen
    • 24. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 08. März 1999
    Geliefert am 23. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    191 humberston avenue grimsby t/no ;-HS256419 together with land at the rear with title number HS228117 (part) and goodwill of any business carried on at the property and all the company's interest in and to the acquisition documents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 23. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. Mai 1996
    Geliefert am 10. Juni 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 10. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. Mai 1996
    Geliefert am 07. Juni 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or any group member to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kingsway Nominees Limitedas Trustee on Behalf of Electra Fleming Privateequity Partners
    Transaktionen
    • 07. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juli 1994
    Geliefert am 20. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £150000 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Land to south of batlet road west end hampshire t/n HP471547.
    Berechtigte Personen
    • The Lawn Tennis Association
    Transaktionen
    • 20. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment
    Erstellt am 13. Feb. 1992
    Geliefert am 20. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    As specified in previous debenture see form 395 m/66/l for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Co.
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of life policies
    Erstellt am 07. Jan. 1992
    Geliefert am 15. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility agreement dated 16/9/91 and/or this charge
    Kurze Angaben
    The policies as defined below and all moneys thereby assured which may become payable thereunder and all the full benefit thereof please see form 395 5 16/1 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Co.
    Transaktionen
    • 15. Jan. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Sept. 1991
    Geliefert am 23. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 16 sept, 1991 and the charge
    Kurze Angaben
    (See form 395 and continuation sheets relevant to this charge). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Co.
    Transaktionen
    • 23. Sept. 1991Registrierung einer Belastung
    • 26. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0