BL HC INVIC LEISURE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BL HC INVIC LEISURE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02464159 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BL HC INVIC LEISURE LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BL HC INVIC LEISURE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BL HC INVIC LEISURE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| INVICTA LEISURE LIMITED | 26. Jan. 1990 | 26. Jan. 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BL HC INVIC LEISURE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BL HC INVIC LEISURE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Feb. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Cessation of Bl Hc Health and Fitness Holdings Limited as a person with significant control on 25. Nov. 2022 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Bl Retail Warehousing Holding Company Limited as a person with significant control on 25. Nov. 2022 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Katherine Fyfe als Geschäftsführer am 17. Okt. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Katherine Fyfe am 20. Juli 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Katherine Fyfe als Direktor am 20. Juli 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 21. Apr. 2022
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Charles John Middleton als Geschäftsführer am 31. März 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Gavin Bergin als Direktor am 18. März 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sarah Morrell Barzycki als Geschäftsführer am 18. März 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Charles Mcnuff als Geschäftsführer am 18. März 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Nick Taunt als Direktor am 18. März 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel Mark Webb als Geschäftsführer am 18. März 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Stuart Macey als Geschäftsführer am 18. März 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BL HC INVIC LEISURE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| BERGIN, Gavin | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 251327820001 | |||||||||
| TAUNT, Nicholas Henry | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 275050860001 | |||||||||
| BALL, Michael David | Sekretär | Mulberry House Trumps Green Road GU25 4JA Virginia Water Surrey | British | 58961410002 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Sekretär | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | 162246380001 | |||||||||||
| FALLOWS, Michael Joseph | Sekretär | 11 Greville Drive Edgbaston B15 2UU Birmingham | British | 58345490001 | ||||||||||
| SCALES, Eugene Patrick | Sekretär | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | Other | 124193970001 | ||||||||||
| TYSON, Roger Thomas Virley | Sekretär | 2 Gadd Close RG40 5PQ Wokingham Berkshire | British | 113777700001 | ||||||||||
| WEATHERLEY, Kenneth Frank | Sekretär | 8 Langtons Court Sun Lane SO24 9UE Alresford Hampshire | British | 50477690001 | ||||||||||
| WONG, Wai Chung | Sekretär | Flat 3 Rowsley Lodge 72a Lady Margaret Road N19 5EL London | British | 123616460002 | ||||||||||
| BALL, Michael David | Geschäftsführer | Mulberry House Trumps Green Road GU25 4JA Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | 58961410002 | |||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 32809050044 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 32809000002 | |||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CHARLTON, Stephen Paul | Geschäftsführer | 9 Rowan Close L40 4LP Burscough Lancashire | England | British | 96743210001 | |||||||||
| CLELAND, Jonathan Bradley | Geschäftsführer | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 146698270001 | |||||||||
| CONNON, Daniel Francis | Geschäftsführer | Elmhurst Dundle Road Matfield TN12 7HD Tonbridge Kent | British | 35128740001 | ||||||||||
| COUPE, David John | Geschäftsführer | 1 Chelsea House 13 Edith Grove SW10 0JZ London | United Kingdom | British | 125432970002 | |||||||||
| CREED, Stuart John | Geschäftsführer | Jade House The Avenue Claverton Down BA2 7AX Bath | United Kingdom | British | 3716600001 | |||||||||
| CURRY, John Arthur Hugh | Geschäftsführer | Stokewood Park House Sheardley Lane Droxford SO32 3QY Southampton | England | British | 2968140002 | |||||||||
| DAVIES, Rhian Lynn | Geschäftsführer | 32 Caldervale Road SW4 9LZ Clapham London | British | 48466920001 | ||||||||||
| DHODY, Jog | Geschäftsführer | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 104269910002 | |||||||||
| DICKSON, Peter Alan | Geschäftsführer | Pointer House Farm Langley Lane Goosnargh PR3 2JS Preston Lancashire | British | 13332510001 | ||||||||||
| FALLOWS, Michael Joseph | Geschäftsführer | 11 Greville Drive Edgbaston B15 2UU Birmingham | England | British | 58345490001 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 1898090001 | |||||||||
| FYFE, Katherine | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 293284010001 | |||||||||
| GIBSON, Clive Patrick, The Honourable | Geschäftsführer | Monmouth House 29a Hyde Park Gate SW7 5DJ London | British | 45468220001 | ||||||||||
| GILLIS, Neil Duncan | Geschäftsführer | Lodge Farm High Street, Thelnetham IP22 1JL Diss Norfolk | England | British | 69204500003 | |||||||||
| GRIFFITHS, Paul Richard | Geschäftsführer | 21 Manor Way Blackheath SE3 9EF London | British | 54611260001 | ||||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| GUYER, Paul John | Geschäftsführer | Oakwood House 29 Leydene Park GU32 1HF East Meon Hampshire | British | 100971720002 | ||||||||||
| HALL, Andrew James | Geschäftsführer | Tanglewood 3 Badingham Drive AL5 2DA Harpenden Hertfordshire | England | British | 30306840002 | |||||||||
| LEATHERBARROW, David Jon | Geschäftsführer | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | England | British | 135618280002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BL HC INVIC LEISURE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bl Retail Warehousing Holding Company Limited | 25. Nov. 2022 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Bl Hc Health And Fitness Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BL HC INVIC LEISURE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating security document | Erstellt am 18. Juni 2009 Geliefert am 26. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of receivables | Erstellt am 18. Juni 2009 Geliefert am 26. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Right title and interest in and to the receivables see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Group debenture | Erstellt am 08. Feb. 2006 Geliefert am 18. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Jan. 2004 Geliefert am 07. Feb. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any other member of the group to the note finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Jan. 2004 Geliefert am 03. Feb. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any member of the group (meaning the borrower or its subsidiaries from time to time) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Dukes meadow chiswick hounslow t/no NGL147830; imperial way croydon surrey t/no SGL454522; llandarcy neath swansea t/no CYM43829 and WA953690 for details of further properties charged please refer to form 395 unscheduled property, rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, reights as tenant, book and other debts, bank accounts, charged securities, uncalled capital , goodwill, intellectual property, licences, credit agreements, contracts floating charge undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental charge | Erstellt am 09. Sept. 2003 Geliefert am 12. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H premises together with buildings erected on them k/a the bridgend health & fitness club, waterton park, waterton lane, bridgend, mid glamorgan together with all buildings and fixtures thereon and the proceeds of sale or any part thereon, all other estates or interests in the property and any rights under any licence or other agreement fixed charge present and future book and other debts, all equipment owned present and future , the benefit of all licences, permissions, consents and authorisations present and future, benefits of all insurance by way of assignment all its right, title and interest in and to all contracts and insurances. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 05. Sept. 2002 Geliefert am 09. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the issuer and by each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage all properties now owned by or vested in each charging company including t/n HS293663 humberston country club, humberston avenue, grimsby. T/n HS293701 humberston country club, humberston avenue, grimsby and leasehold unit 9C, upper winbury farm, wingrave, aylesbury, buckinghamshire. By way of first fixed mortgage the securities, first fixed charge all properties thereafter acquired, all present and future interests in or over freehold or leasehold property; all present and future rights, licences, guarantees, rents, deposits, contracts, covenants and warranties relating to the properties.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit deed | Erstellt am 14. Juni 2001 Geliefert am 28. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £100,000 including all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The deposit and all rights titles and benefits whatsoever present and future therein. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit deed | Erstellt am 18. Apr. 2000 Geliefert am 26. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £100,000 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Charge over the deposit of £100,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Okt. 1999 Geliefert am 28. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and security trustee for the finance parties (as therein defined)) on any account whatsoever, under or in connection with the financing documents (including, without limitation, the guarantee and debenture) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 10. März 1999 Geliefert am 24. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings lying to the north of humberston avenue humberston north east lincolnshire t/no;-HS228117 together with goodwill of any business carried on at the property and all right title and interest in and to the "acquisition documents" (as defined in the charge). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 08. März 1999 Geliefert am 23. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 191 humberston avenue grimsby t/no ;-HS256419 together with land at the rear with title number HS228117 (part) and goodwill of any business carried on at the property and all the company's interest in and to the acquisition documents. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 30. Mai 1996 Geliefert am 10. Juni 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 30. Mai 1996 Geliefert am 07. Juni 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or any group member to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Juli 1994 Geliefert am 20. Juli 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £150000 due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Land to south of batlet road west end hampshire t/n HP471547. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment | Erstellt am 13. Feb. 1992 Geliefert am 20. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben As specified in previous debenture see form 395 m/66/l for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of life policies | Erstellt am 07. Jan. 1992 Geliefert am 15. Jan. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility agreement dated 16/9/91 and/or this charge | |
Kurze Angaben The policies as defined below and all moneys thereby assured which may become payable thereunder and all the full benefit thereof please see form 395 5 16/1 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Sept. 1991 Geliefert am 23. Sept. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 16 sept, 1991 and the charge | |
Kurze Angaben (See form 395 and continuation sheets relevant to this charge). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0