SCH INTERNATIONAL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SCH INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02467201 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SCH INTERNATIONAL LIMITED?
- (9305) /
Wo befindet sich SCH INTERNATIONAL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | FISHER PARTNERS Acre House 11-15 William Road NW1 3ER London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SCH INTERNATIONAL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| JACK MORTON WORLDWIDE LIMITED | 14. Aug. 2000 | 14. Aug. 2000 |
| SCH INTERNATIONAL LIMITED | 11. Sept. 1992 | 11. Sept. 1992 |
| SPECTRUM COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED | 16. Juli 1990 | 16. Juli 1990 |
| DRIVETAPE LIMITED | 05. Feb. 1990 | 05. Feb. 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SCH INTERNATIONAL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SCH INTERNATIONAL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Insolvenzmeldung Insolvency:s/s cert. Release of liquidator | 1 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order insolvency:replacement of liquidator | 15 Seiten | LIQ MISC OC | ||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Okt. 2009 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SCH INTERNATIONAL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAN, Louise | Sekretär | 18 Newbury Close DA2 6AQ Dartford Kent | British | 88994320002 | ||||||
| HAMID, Mohamed Arif | Sekretär | 11 Mackenzie Road B11 4EP Birmingham West Midlands | British | 51714150001 | ||||||
| HARRY III, William | Geschäftsführer | The Brake House Back Lane CV37 8SF Lower Quinton Warwickshire | England | American | 117064700001 | |||||
| BERNERS-PRICE, Peter Devonald | Sekretär | White Gates Common Wood WD4 9BB Kings Langley Hertfordshire | British | 61833410001 | ||||||
| CALCOTT, Ronald | Sekretär | The Haven Altwood Bailey SL6 4PQ Maidenhead Berkshire | British | 4221120001 | ||||||
| HAMID, Mohamed Arif | Sekretär | 11 Mackenzie Road B11 4EP Birmingham West Midlands | British | 51714150001 | ||||||
| SCHWARTZ, Harold | Sekretär | 23 West 73rd Street Apartment 706-A 10023 New York Ny Usa | American | 53562220003 | ||||||
| BERNERS-PRICE, Peter Devonald | Geschäftsführer | White Gates Common Wood WD4 9BB Kings Langley Hertfordshire | United Kingdom | British | 61833410001 | |||||
| BUSSY, Bernard | Geschäftsführer | Woodlands House Whittle Close Forest End Road GU17 8JT Sandhurst Surrey | British | 4221140001 | ||||||
| CALCOTT, Ronald | Geschäftsführer | The Haven Altwood Bailey SL6 4PQ Maidenhead Berkshire | British | 4221120001 | ||||||
| CRAWFORD, Anthony | Geschäftsführer | The End House Parsons Wood Parsonage Lane SL2 3NZ | British | 4318170001 | ||||||
| CRONEEN, Laurence Victor | Geschäftsführer | 5 Broomhouse Road SW6 3QU London | United Kingdom | British | 63310130002 | |||||
| CRONEEN, Laurence Victor | Geschäftsführer | 5 Broomhouse Road SW6 3QU London | United Kingdom | British | 63310130002 | |||||
| DIGNAM, Arthur | Geschäftsführer | 2255 Sherman Avenue North Merrick New York 11566 United States Of America | America | 49151370001 | ||||||
| ELLIOTT, Timothy | Geschäftsführer | 66 Cumberland Road Hanwell W7 2EB London | British | 67673980001 | ||||||
| EVANS, Rupert | Geschäftsführer | Spectrum Communications Plc PO BOX 14208 Bin Khedia Centre 3rd Floor Al Garhoud Bridge Croad Dubai | British | 49151840002 | ||||||
| HAMID, Arif | Geschäftsführer | 6 Kew Lodge 226 Kew Road TW9 3LQ Richmond Surrey | British | 80328030001 | ||||||
| HAMID, Mohamed Arif | Geschäftsführer | 11 Mackenzie Road B11 4EP Birmingham West Midlands | England | British | 51714150001 | |||||
| HOLTZ, Norman | Geschäftsführer | 469 Brookline Street 02459 Newton Center Massachusetts Usa | Usa | 70742250001 | ||||||
| INGLEBY, Raymond Simon | Geschäftsführer | Flat 57 Abbey Lodge Park Road NW8 7RL London | United Kingdom | British | 73515570001 | |||||
| MASON, Debra Schneider | Geschäftsführer | 300 East 54th Street 4k New York 10022 America | United Kingdom | American | 251723400001 | |||||
| MCCALL, Joseph | Geschäftsführer | 42 Glezen Lane 01778 Wayland Massachusetts Usa | United States | American | 70741140001 | |||||
| PENTONY-WOOLWICH, Martin | Geschäftsführer | 11 Kingsley Avenue GU15 2NA Camberley Surrey | British | 37722320001 | ||||||
| PHILBIN, Kevin | Geschäftsführer | 28 Dingle Road Middleton M24 1NH Manchester | United Kingdom | British | 95735720001 | |||||
| SHEPHERD, Brian George | Geschäftsführer | The Old Malt House South Side OX25 4RT Steeple Aston Oxfordshire | United Kingdom | British | 101648160001 | |||||
| SWAN, Paul | Geschäftsführer | Woodlands Hollybush Hill Stoke Poges SL2 4QN Slough Berkshire | British | 4221150001 | ||||||
| THOMPSON, John Allan | Geschäftsführer | 1 Victoria Square SW1W 0QY London | Australian | 29254280001 | ||||||
| WALLACE, Mark | Geschäftsführer | Woodmans Cottage Fingest Road Frieth RG9 6PU Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 61959290001 | |||||
| WALLWORK, Simon John | Geschäftsführer | 5 Thatcher Close Bowdon WA14 3FX Altrincham Cheshire | British | 57880660003 |
Hat SCH INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental mortgage. | Erstellt am 15. Juli 1993 Geliefert am 23. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By the supplemental memorandum of deposit the company charges :- the shares -please see doc for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture. | Erstellt am 15. Juli 1993 Geliefert am 23. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Please see doc for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of deposit | Erstellt am 16. Mai 1990 Geliefert am 24. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of loan agreement dated 6/4/90. and/or this charge. | |
Kurze Angaben For more details see form 395 ref M5. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Mai 1990 Geliefert am 24. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under terms of loan agreement dated 6/4/90 and/or this debenture | |
Kurze Angaben All of the companys right title and interest in and to the shares stocks bonds debentures certificates of deposit & other securities of any kind of spectrum communications limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SCH INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0