PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02467508 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP am 14. Sept. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Kenneth Mcintyre Carlaw als Direktor am 28. Aug. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel Paul Featham als Geschäftsführer am 28. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Anthony Bowler als Geschäftsführer am 28. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 26. Mai 2012 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Nigel Paul Featham als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan May als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 14. Dez. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jonathan Paul May am 14. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Richard Anthony Bowler am 14. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIES, Elizabeth Anne | Sekretär | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | British | 102907000002 | ||||||
| CARLAW, Kenneth Mcintyre | Geschäftsführer | Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 | England | British | 161250030001 | |||||
| CAMPBELL, David Gerard | Sekretär | 47 Ridgely Drive Ponteland NE20 9BJ Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 8159840001 | ||||||
| JONES, Michael Adrian | Sekretär | 5 Sandycroft Warsash SO31 9AA Southampton Hampshire | British | 36134870001 | ||||||
| TURNER, David Paul | Sekretär | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
| BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED | Sekretär | 54 Endless Street SP1 3UH Salisbury Wiltshire | 42985760001 | |||||||
| BAYFIELD, Stephen | Geschäftsführer | Windy Ridge Riverside Close Stoford SP2 0PX Salisbury Wiltshire | British | 42058550001 | ||||||
| BOWLER, Richard Anthony | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 35116070001 | |||||
| FEATHAM, Nigel Paul | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | England | British | 161124990001 | |||||
| FICKLING, John Matthew | Geschäftsführer | 62 Gainsborough Close NE25 9XB Whitley Bay Tyne & Wear | British | 40818470001 | ||||||
| JONES, Michael Adrian | Geschäftsführer | 3 Old Shaftesbury Drive Old Blandford Road Harnham SP2 8QH Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 77984700001 | |||||
| KENNAN, Anthony Denis | Geschäftsführer | 13 The Poplars Gosforth NE3 4AE Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 8159860001 | ||||||
| LONSDALE, Stephen Philip | Geschäftsführer | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | 4971910001 | |||||
| MARTIN, David Robert | Geschäftsführer | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 6874440001 | |||||
| MARTIN, David Robert | Geschäftsführer | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 6874440001 | |||||
| MAY, Jonathan Paul | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business Park SR3 3XP Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 125675730002 | |||||
| MONAGHAN, David Bell | Geschäftsführer | 43 Well Ridge Close Redhouse Farm NE25 9PN Whitley Bay Tyne & Wear | British | 35862500001 | ||||||
| NOBLE, Stephen Leslie | Geschäftsführer | Brewery Close Stamfordham NE18 0PQ Northumberland Close House United Kingdom | United Kingdom | British | 128655430001 | |||||
| RAY, John Alfred | Geschäftsführer | 50 The Gables Sedgefield TS21 3EU Stockton On Tees Cleveland | British | 58415290001 | ||||||
| WATT, Gordon George | Geschäftsführer | Alderbury Holt Southampton Road,Clarendon SP5 3DG Salisbury Wiltshire | England | British | 67622780002 | |||||
| WILLIAMS, Dawson Thomas | Geschäftsführer | Chately Wood House Rockford BH24 3LZ Ringwood Hampshire | British | 2719600006 |
Hat PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Chattel mortgage | Erstellt am 29. Dez. 1994 Geliefert am 29. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from kentish bus & coach company limited and northumbria - motor services limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and singular the vehicles as described in the schedule to the form 395 including 17 x leyland olympian double decker buses and 2 x optare delta buses. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of charge and set-off over credit balances | Erstellt am 15. Aug. 1994 Geliefert am 31. Aug. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the working capital facility letter dated 15TH august 1994 | |
Kurze Angaben All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 11. Aug. 1994 Geliefert am 26. Aug. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the loan agreement dated 4TH may 1994, any interest rate agreement, or any of the security documents (as defined in the charge) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 13. Juli 1990 Geliefert am 23. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever (see form 395 for further details) | |
Kurze Angaben (See form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Juli 1990 Geliefert am 23. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for standard chartered bank and dresdner bank A.G. pursuant to a loan agreement of even date and under the terms of the charge | |
Kurze Angaben (See form 395 for further details of specific property). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat PROUDMUTUAL FLEET MANAGEMENT LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0