ASPECT VENTURES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ASPECT VENTURES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02468264 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ASPECT VENTURES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich ASPECT VENTURES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Resolve Advisory Limited 22 York Buildings WC2N 6JU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ASPECT VENTURES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| THE LANGDALE GROUP LIMITED | 02. Apr. 1990 | 02. Apr. 1990 |
| THE LANGDALE GROUP LIMITED | 02. Apr. 1990 | 02. Apr. 1990 |
| LEGIBUS 1520 LIMITED | 08. Feb. 1990 | 08. Feb. 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASPECT VENTURES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 29. Apr. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ASPECT VENTURES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Jan. 2021 | 10 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom zum Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU am 27. Jan. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. Dez. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2019 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Apr. 2018 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Smothers als Direktor am 31. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kirk Dyson Davis als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2017 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Mai 2016 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 19 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 22 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 22 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ASPECT VENTURES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESWICK, Lindsay Anne | Sekretär | 22 York Buildings WC2N 6JU London Resolve Advisory Limited | 207524030001 | |||||||
| SMOTHERS, Richard | Geschäftsführer | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 242658700001 | |||||
| BRIDGE, John Nigel | Sekretär | Millhouse Parkstile Lane L11 0BG Liverpool Merseyside | British | 39560640001 | ||||||
| DOWNIE, Robert Arran | Sekretär | Glendale Horrocks Road Edgworth BL7 0QJ Bolton Lancashire | British | 97033480001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Sekretär | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JONES, Henry | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 180591790001 | |||||||
| KENDALL, Timothy James | Sekretär | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172444930001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Sekretär | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEVENS, Mark | Sekretär | 5 Lyon Drive Murieston EH54 9HF Livingston West Lothian | British | 80951870001 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181022150001 | |||||||
| STEWART, Claire Susan | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Sekretär | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Lucy Jane | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164754670001 | |||||
| CRICHTON, Roger Wells | Geschäftsführer | Pitsford House West Manor Road, Pitsford NN6 9AR Northampton Northamptonshire | British | 67937290001 | ||||||
| CUMMING, Johanna Louise | Geschäftsführer | 18 Prospect Quay 98 Point Pleasant SW18 1PR London | United Kingdom | British | 111108910001 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DAVIS, Kirk Dyson | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158484730001 | |||||
| DOWNIE, Robert Arran | Geschäftsführer | Glendale Horrocks Road Edgworth BL7 0QJ Bolton Lancashire | England | British | 97033480001 | |||||
| DUTTON, Philip | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| DYSON, Ian | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 154003250001 | |||||
| GALLAGHER, Patrick James | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 205366190001 | |||||
| GODWIN-BRATT, Robert James | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 170184800001 | |||||
| HOMER, Colin David | Geschäftsführer | 39 The Avenue Ingol PR2 7AX Preston Lancashire | United Kingdom | British | 1850120001 | |||||
| HOMER, Neville Rex | Geschäftsführer | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| IZATT, George Gordon Maclean | Geschäftsführer | 11 Broom Road KY13 8BU Kinross Kinross Shire | United Kingdom | British | 895970001 | |||||
| JONES, Karen Elisabeth Dind | Geschäftsführer | Paddock House 9 Spencer Park Wandsworth SW18 2SX London | United Kingdom | British | 47793260007 | |||||
| KELLY, Daryl Antony | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 86246470001 | |||||
| KNIGHT, Andrew Ronald | Geschäftsführer | 89 Main Street DE13 7ED Alrewas Staffordshire | British | 81555100002 | ||||||
| LANGFORD, Jonathan Robert | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 135408140001 | |||||
| LESLIE, John Stewart | Geschäftsführer | Bec House Church End HP27 9PD Bledlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | 59934350001 | |||||
| MARGERRISON, Russell John | Geschäftsführer | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 170590800001 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Geschäftsführer | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ASPECT VENTURES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit Retail Bidco Limited | 06. Apr. 2016 | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ASPECT VENTURES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Amendment and restatement deed | Erstellt am 07. Juli 2006 Geliefert am 21. Juli 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each security provider or any other security provider to the chargee or any of the other borrower group secured creditors on any account whatsoever. All monies due or to become due from each security provider and/or any other security provider and/or the punch borrower to the chargee or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Real property scottish property ancillary property rights shares contractual rights insurance intellectual property book debts accounts licences and consents. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed of charge | Erstellt am 21. März 2006 Geliefert am 31. März 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any other security provider and/or the punch borrower or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H abbey 944 chesterfield road sheffield t/no SYK428293,f/h abington park brewery wellingborough road northampton t/no NN160993,f/h adam & eve high street homerton t/no EGL413814 (for details of further properties charged please refer to form 395) all estates or interests in such property and all buildings,trade and other fixtures,fixed plant and machinery from time to time on such f/h or l/h property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Borrower group deed of charge | Erstellt am 25. Nov. 2004 Geliefert am 13. Dez. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other security provider to the borrower group security trustee or any of the other borrower group secured creditors on any account whatsoever and all monies due or to become due from the company and/or any other security provider and/or bankco and/or loanco to the borrower group security trustee or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a abbey 944 chesterfield road sheffield t/no SYK428293, f/h property k/a abington park brewery wellingborough road northampton t/no NN160993, f/h property k/a adam & eve st james 81 & 82 petty france westminster london t/no LN211870. For details of further properties charged please refer to form 395. by way of fixed security all right title interest and benefit in to and under all shares stocks debentures and other securities and all dividends, the relevant documents, the insurance policies, the intellectual property rights, book debts and floating charge all undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 15. Dez. 2003 Geliefert am 31. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Ansty arms, coventry f/h t/n's WK251251 & WK251242. Bay horse, wigan f/h t/n's GM85094 & GM484585. Berkshire arms, nr newbury f/h t/n BK249470 for details of further property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 15. Dez. 2003 Geliefert am 31. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ASPECT VENTURES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0