ASPECT VENTURES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameASPECT VENTURES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02468264
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ASPECT VENTURES LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich ASPECT VENTURES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Resolve Advisory Limited
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ASPECT VENTURES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    THE LANGDALE GROUP LIMITED02. Apr. 199002. Apr. 1990
    THE LANGDALE GROUP LIMITED02. Apr. 199002. Apr. 1990
    LEGIBUS 1520 LIMITED08. Feb. 199008. Feb. 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASPECT VENTURES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis29. Apr. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für ASPECT VENTURES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    11 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Jan. 2021

    10 SeitenLIQ03

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom zum Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU am 27. Jan. 2020

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 16. Jan. 2020

    LRESSP

    Kapitalaufstellung am 30. Dez. 2019

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2019 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Apr. 2018

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Richard Smothers als Direktor am 31. Jan. 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Kirk Dyson Davis als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2017

    18 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Dez. 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Mai 2016

    20 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 03. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    19 SeitenAR01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    30. Nov. 2016Replacement This document replaces the AR01 registered on 04/01/2012 as it was not properly delivered

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    22 SeitenAR01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    30. Nov. 2016Replacement This document replaces the AR01 registered on 04/01/2011 as it was not properly delivered

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    22 SeitenAR01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    30. Nov. 2016Replacement This document replaces the AR01 registered on 04/01/2010 as it was not properly delivered

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Wer sind die Geschäftsführer von ASPECT VENTURES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Sekretär
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    207524030001
    SMOTHERS, Richard
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish242658700001
    BRIDGE, John Nigel
    Millhouse
    Parkstile Lane
    L11 0BG Liverpool
    Merseyside
    Sekretär
    Millhouse
    Parkstile Lane
    L11 0BG Liverpool
    Merseyside
    British39560640001
    DOWNIE, Robert Arran
    Glendale
    Horrocks Road Edgworth
    BL7 0QJ Bolton
    Lancashire
    Sekretär
    Glendale
    Horrocks Road Edgworth
    BL7 0QJ Bolton
    Lancashire
    British97033480001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Sekretär
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180591790001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172444930001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Sekretär
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEVENS, Mark
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    Sekretär
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    British80951870001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181022150001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Sekretär
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    CRICHTON, Roger Wells
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    British67937290001
    CUMMING, Johanna Louise
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    Geschäftsführer
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    United KingdomBritish111108910001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    DOWNIE, Robert Arran
    Glendale
    Horrocks Road Edgworth
    BL7 0QJ Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Glendale
    Horrocks Road Edgworth
    BL7 0QJ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish97033480001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    DYSON, Ian
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish154003250001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    HOMER, Colin David
    39 The Avenue
    Ingol
    PR2 7AX Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    39 The Avenue
    Ingol
    PR2 7AX Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish1850120001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Geschäftsführer
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    IZATT, George Gordon Maclean
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    Geschäftsführer
    11 Broom Road
    KY13 8BU Kinross
    Kinross Shire
    United KingdomBritish895970001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Geschäftsführer
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    KNIGHT, Andrew Ronald
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    British81555100002
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    LESLIE, John Stewart
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish59934350001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ASPECT VENTURES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer4872046
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat ASPECT VENTURES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Amendment and restatement deed
    Erstellt am 07. Juli 2006
    Geliefert am 21. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each security provider or any other security provider to the chargee or any of the other borrower group secured creditors on any account whatsoever. All monies due or to become due from each security provider and/or any other security provider and/or the punch borrower to the chargee or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Real property scottish property ancillary property rights shares contractual rights insurance intellectual property book debts accounts licences and consents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Truste Company Limited in Its Capacity as the "Issuer Security Trustee" and "Borrowergroup Security Trustee"
    Transaktionen
    • 21. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed of charge
    Erstellt am 21. März 2006
    Geliefert am 31. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any other security provider and/or the punch borrower or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H abbey 944 chesterfield road sheffield t/no SYK428293,f/h abington park brewery wellingborough road northampton t/no NN160993,f/h adam & eve high street homerton t/no EGL413814 (for details of further properties charged please refer to form 395) all estates or interests in such property and all buildings,trade and other fixtures,fixed plant and machinery from time to time on such f/h or l/h property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Trustee Company Limited as Agent and Trustee for the Borrower Secured Parties
    Transaktionen
    • 31. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Borrower group deed of charge
    Erstellt am 25. Nov. 2004
    Geliefert am 13. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other security provider to the borrower group security trustee or any of the other borrower group secured creditors on any account whatsoever and all monies due or to become due from the company and/or any other security provider and/or bankco and/or loanco to the borrower group security trustee or any of the other junior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a abbey 944 chesterfield road sheffield t/no SYK428293, f/h property k/a abington park brewery wellingborough road northampton t/no NN160993, f/h property k/a adam & eve st james 81 & 82 petty france westminster london t/no LN211870. For details of further properties charged please refer to form 395. by way of fixed security all right title interest and benefit in to and under all shares stocks debentures and other securities and all dividends, the relevant documents, the insurance policies, the intellectual property rights, book debts and floating charge all undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Trustee Company Limited (As Trustee for the Borrower Secured Parties)
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 15. Dez. 2003
    Geliefert am 31. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Ansty arms, coventry f/h t/n's WK251251 & WK251242. Bay horse, wigan f/h t/n's GM85094 & GM484585. Berkshire arms, nr newbury f/h t/n BK249470 for details of further property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transaktionen
    • 31. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 09. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 15. Dez. 2003
    Geliefert am 31. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transaktionen
    • 31. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 07. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ASPECT VENTURES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Jan. 2020Beginn der Liquidation
    25. Apr. 2022Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Praktiker
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Praktiker
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0