MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02469968 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED?
- (7260) /
Wo befindet sich MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3 Rosevale Business Park Rosevale Road ST5 7UB Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MITEK GROUP LIMITED | 29. März 1994 | 29. März 1994 |
FINANCEDATE LIMITED | 14. Feb. 1990 | 14. Feb. 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2005 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ |
---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | |
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | |
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | |
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | |
legacy | 1 Seiten | 288b | |
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 04. Juli 2006 | 2 Seiten | 1.3 | |
Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs | 5 Seiten | 1.4 | |
legacy | 2 Seiten | 403a | |
legacy | 1 Seiten | 288a | |
legacy | 1 Seiten | 288b | |
legacy | 1 Seiten | 288a | |
legacy | 1 Seiten | 288b | |
legacy | 1 Seiten | 288a | |
legacy | 1 Seiten | 288b | |
legacy | 2 Seiten | 363a | |
legacy | 1 Seiten | 288a | |
legacy | 1 Seiten | 288b | |
legacy | 1 Seiten | 288b | |
legacy | 1 Seiten | 288b | |
legacy | 2 Seiten | 288a | |
Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs | 3 Seiten | 1.1 | |
legacy | 1 Seiten | 288b | |
legacy | 1 Seiten | 288b | |
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2005 | 22 Seiten | AA | |
legacy | 1 Seiten | 288a |
Wer sind die Geschäftsführer von MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYRE, Satbinderpal Singh | Geschäftsführer | 42 Lytham Road Perton WV6 7YY Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | Sales Manager | 111959520001 | ||||
GREATOREX, Ian | Sekretär | The Old Coach House 4, Park Vale Road SK11 8AR Macclesfield Cheshire | British | Accountant | 111957800001 | |||||
HANKEY, Kelly Jane | Sekretär | 6 Westholme Close CW12 4FZ Congleton Cheshire | British | Sales Executive | 110490520001 | |||||
HOWARD, Joseph William | Sekretär | 101 St Georges Road BL1 2BY Bolton Lancashire | British | Chartered Accountant | 8789820001 | |||||
ROACH, Jacqueline Frances | Sekretär | 6 Lake View Astbury Mere CW12 4FP Congleton Cheshire | British | Director | 12644760001 | |||||
ROACH, Jacqueline Frances | Sekretär | 6 Lake View Astbury Mere CW12 4FP Congleton Cheshire | British | Director | 12644760001 | |||||
ROACH, Malcolm David | Sekretär | 22 Oak Drive ST7 3LY Scholar Green Cheshire | British | Credit Manager | 92070380001 | |||||
ROACH, Mark Damion | Sekretär | 6 Lakeview Astbury Mere CW12 4FP Congleton Cheshire | British | 57429240001 | ||||||
SPOONER, Paul Rodney | Sekretär | Post Box Cottage Wall Hill CW12 4TE Congleton Cheshire | British | Operations Director | 40878670001 | |||||
BISHTON, Paul Neil | Geschäftsführer | 85 Ennerdale Drive CW12 4FJ Congleton Cheshire | United Kingdom | British | Sales Director | 80342690001 | ||||
DEOL, Hardip Singh | Geschäftsführer | 171 Warwick Road B92 7AW Solihull West Midlands | British | Director | 109512210001 | |||||
LARKIN, Michael Scott | Geschäftsführer | 12 Goldney Court Horsehay TF4 3UH Telford Shropshire | British | Sales Manager | 94365430001 | |||||
MATTHEWS, Robert Morton | Geschäftsführer | 12 Blackbird Way Biddulph ST8 7UH Stoke On Trent Staffordshire | British | Finance Director | 104245720001 | |||||
ROACH, Jacqueline Frances | Geschäftsführer | 6 Lake View Astbury Mere CW12 4FP Congleton Cheshire | British | Director | 12644760001 | |||||
ROACH, Malcolm David | Geschäftsführer | 22 Oak Drive ST7 3LY Scholar Green Cheshire | United Kingdom | British | Co Director | 92070380001 | ||||
ROACH, Mark Damion | Geschäftsführer | 6 Westholme Close CW12 4FZ Congleton Cheshire | England | British | Purchasing Manager | 57429240002 | ||||
SPOONER, Paul Rodney | Geschäftsführer | Post Box Cottage Wall Hill CW12 4TE Congleton Cheshire | British | General Manager | 40878670001 |
Hat MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Erstellt am 21. Mai 2003 Geliefert am 23. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 21. Juni 2000 Geliefert am 23. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement for ibm global financing dated 13TH june 2000 | |
Kurze Angaben All book and other debts and full benefit of the rights and remedies thereon; floating charge over the company's stock-in-trade and all assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge on purchased debts which fail to vest | Erstellt am 02. Juli 1998 Geliefert am 04. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement for the purchase of debts between the company and the chargee or otherwise | |
Kurze Angaben By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 06. Apr. 1998 Geliefert am 16. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The freehold property known as mitek house greenfield farm trading estate congleton cheshire title number CH332640. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 15. Mai 1996 Geliefert am 28. Mai 1996 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge by way of debenture | Erstellt am 08. Sept. 1994 Geliefert am 10. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to or in connection with the financing agreement or on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 18. Jan. 1994 Geliefert am 02. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land on the north east side of sands road harriseahead newcastle under lyme staffordshire t/n SF255700 and/or the proceeds of sale thereof the entry in col.6 Above has this day been amended please see doc.M27L.R.M.groves 12/5/94. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat MITEK COMPUTER COMPONENTS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0