NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02470056 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 140 Aldersgate Street EC1A 4HY London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| GLE PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 14. Feb. 1990 | 14. Feb. 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2020 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Carl Wright als Geschäftsführer am 08. Nov. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Arthur Rushton als Geschäftsführer am 11. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2019 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Steven Carl Wright als Direktor am 14. Nov. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Greater London Enterprise Investments Limited as a person with significant control on 07. Okt. 2016 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 40 Aldersgate Street London EC1A 4HY England zum 140 Aldersgate Street London EC1A 4HY am 25. Apr. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 10-12 Queen Elizabeth Street London SE1 2JN England zum 40 Aldersgate Street London EC1A 4HY am 24. Apr. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 5th Floor Valiant Building 14 South Parade Leeds LS1 5QS zum 10-12 Queen Elizabeth Street London SE1 2JN am 06. Okt. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Hofman als Sekretär am 31. Mai 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Bernard Walsh als Sekretär am 31. Mai 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOFMAN, Michael | Sekretär | Aldersgate Street EC1A 4HY London 140 England | 209188220001 | |||||||
| MANSON, Christopher John | Geschäftsführer | Aldersgate Street EC1A 4HY London 140 England | United Kingdom | British | 175493670001 | |||||
| WALSH, Michael Bernard | Geschäftsführer | Aldersgate Street EC1A 4HY London 140 England | England | British | 74086660002 | |||||
| CHAPMAN, Paul Stephen | Sekretär | 13 Southbourne Hayes BR2 7NJ Bromley Kent | British | 1403010005 | ||||||
| GERVASIO, James Ernest Peter | Sekretär | Chapeltown Road LS7 4HZ Leeds Saint Martins House 210-212 West Yorkshire | British | 2093810001 | ||||||
| NOEL, Dawn | Sekretär | 6 Cantley Road Hanwell W7 2BQ London | British | 79021070001 | ||||||
| WALSH, Michael Bernard | Sekretär | 14 South Parade LS1 5QS Leeds 5th Floor Valiant Building England | 159189680001 | |||||||
| WOODALL, Michael David | Sekretär | Glovers Cottage Reigate Hill RH2 9PN Reigate Surrey | British | 4777030001 | ||||||
| COMPTON, Colin Richard | Geschäftsführer | Kingsland House Kingsland Lane Leavenheath CO6 4PD Colchester Essex | British | 12075710001 | ||||||
| LARGE, Martin Gerald | Geschäftsführer | 14 South Parade LS1 5QS Leeds 5th Floor Valiant Building England | England | British | 44118740003 | |||||
| ROGERS, Mary | Geschäftsführer | Basement Flat 46 Gordon Square WC1H 0PD London | British | 85165800001 | ||||||
| RUSHTON, Christopher Arthur | Geschäftsführer | Aldersgate Street EC1A 4HY London 140 England | England | British | 44369580002 | |||||
| WRIGHT, Steven Carl | Geschäftsführer | Aldersgate Street EC1A 4HY London 140 England | England | British | 232556880001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newable Uk Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Aldersgate Street EC1A 4HY London 140 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat NEWABLE DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment of share sale agreement | Erstellt am 25. Sept. 2001 Geliefert am 15. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge all that an agreement relating inter alia to the sale by the company of it's shares in gle property developments (kingston) limited dated 02 february 2001... see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of building contract | Erstellt am 25. Sept. 2001 Geliefert am 15. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge all that the agreement dated 05 june 2001 and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder... See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge on shares | Erstellt am 25. Sept. 2001 Geliefert am 15. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All of the company's obligations to the chargee (or any company which is a member of the same group of companies of the bank) of any kind and in any currency | |
Kurze Angaben The one ordinary share held by the company in gle property developments (kingston) limited (which constitutes the entire issued share capital of that company) together with all other stocks, shares, bonds, or other securities at any time deposited with or transferred to the bank or its nominee by the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of building contract | Erstellt am 28. Feb. 2001 Geliefert am 14. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Building contract means the agreement dated the 6 february 2001 made between the customer and the contractor and includes the drawings specifications and attachments referred to therein contractor means buxton building contractors limited c/number 2261235 of cedar house 91 high street caterham surrey CR3 5UH. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Feb. 2001 Geliefert am 14. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge | Erstellt am 28. Feb. 2001 Geliefert am 14. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a land and premises at st georges square (west) gore street deptford london SE8 t/n TGL182465. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Mai 1994 Geliefert am 26. Mai 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H-part of number 90 and the wholes of numbers 92 to 104 (even) newington butts kennington london. Fixed charge over the plant machinery and fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils of the company and the present or future goodwill of any business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Dez. 1993 Geliefert am 13. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 112,114,116,118,120,122,124 newington butts and 76/77 holyoak road kenniongton t/ns ln 13388 sgl 298102. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Nov. 1993 Geliefert am 24. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H-land lying to the north east of therapia lane L.B. of sutton land and buildings to the north east of therapia lane L.B. of sutton and land on the south east side of the south east of the junction of therapia lane and beddington lane beddington L.B. of sutton greater london t/n-SGL532994, SGL556142, SGL213815. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Aug. 1993 Geliefert am 26. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge | |
Kurze Angaben F/H- parcels of land in boot street hoxton market shoreditch london N1 t/n-EGL287091. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter | Erstellt am 18. Aug. 1993 Geliefert am 01. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the letter | |
Kurze Angaben Cash sum of £4,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Jan. 1992 Geliefert am 20. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £200,000 | |
Kurze Angaben F/H land containing 5.81 acres or thereabouts at therapia lane off beddington lane L.B. of sutton. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Jan. 1992 Geliefert am 20. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land containing 5.81 acres or thereabouts at therapia lane off beddington lane L.B. of sutton together with all buildings and fixtures fixed charge on all attached plant and machinery and other chattels floatings charge over all unattached plant and machinery and other chattels. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0