DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL
Überblick
| Unternehmensname | DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | 02475089 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL?
- (6712) /
Wo befindet sich DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | One Cabot Square London E14 4QJ |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DLJ (UK) LIMITED | 09. Juli 1990 | 09. Juli 1990 |
| HACKREMCO (NO.575) LIMITED | 28. Feb. 1990 | 28. Feb. 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 8 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Susannah Louise Aliker als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Long als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Paul Edward Hare als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kevin Studd als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Costas Michaelides am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Costas Michaelides am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David Long am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Paul Edward Hare am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Kevin Lester Studd am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 9 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARE, Paul Edward | Sekretär | Cabot Square E14 4QJ London One United Kingdom | British | 23220350004 | ||||||
| ALIKER, Susannah Louise | Geschäftsführer | Cabot Square E14 4QJ London 1 | United Kingdom | British | 99766410001 | |||||
| HARE, Paul Edward | Geschäftsführer | Cabot Square E14 4QJ London One | United Kingdom | British | 23220350004 | |||||
| MICHAELIDES, Costas, Chair Of The Board Of Directors | Geschäftsführer | Cabot Square E14 4QJ London One United Kingdom | United Kingdom | American,Cypriot | 73091230001 | |||||
| HARRIMAN, John Patrick William | Sekretär | Flat 3 6 Tedworth Square SW3 4DY London | British | 49828030001 | ||||||
| HORNSEY, Nicholas John | Sekretär | Eremue 8 The Avenue TW12 3RS Hampton Middlesex | British | 50650950002 | ||||||
| SIEGLER, Thomas Edmund | Sekretär | 39 Wildwood Drive Dix Hills New York 11746 Usa | American | 47358850001 | ||||||
| AITCHINSON, Carolyn Jane | Geschäftsführer | 126 Palace Gardens Terrace W8 4RT London | British | 62873110004 | ||||||
| ALEXANDRE, James Lawrence | Geschäftsführer | 33 Blomfield Road W9 1AA London | American | 63091430001 | ||||||
| BRETTON, Nigel Paul | Geschäftsführer | Blue Clay 33 Rose Walk AL4 9AA St Albans Hertfordshire | British | 75188550001 | ||||||
| BURROWES, Kevin James | Geschäftsführer | Samuelson House Hatchford Park Ockham Lane KT11 1LP Cobham Surrey | British | 105411790001 | ||||||
| CATANIA, Alejandro Miguel | Geschäftsführer | 90 Palace Gardens Terrace W8 4RF London | Itialian | 74299160001 | ||||||
| DISLEY, Kevin John | Geschäftsführer | 18 Larksway CM23 4DG Bishops Stortford Hertfordshire | United Kingdom | British | 147923330001 | |||||
| GORMLEY, Peter Vincent | Geschäftsführer | Pinehill Sunning Avenue SL5 9PW Sunningdale Berkshire | Usa | 52530740001 | ||||||
| GREEN, Darryl John | Geschäftsführer | Wychden Wildernesse Avenue TN15 0EA Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 60672010001 | |||||
| HALE, Charles Martin | Geschäftsführer | 33 Lyall Mews SW1X 8DJ London | United Kingdom | British | 105772830001 | |||||
| HARRIMAN, John Patrick William | Geschäftsführer | Flat 3 6 Tedworth Square SW3 4DY London | British | 49828030001 | ||||||
| HART, Mark | Geschäftsführer | 39 Gilhams Avenue SM7 1QW Banstead Surrey | British | 67366820001 | ||||||
| HIARD, Michael Henry | Geschäftsführer | Foxes High Wych Road CM21 OHH Sawbridgeworth Hertfordshire | British | 18403810002 | ||||||
| HOHMANN III, Frank Lynn | Geschäftsführer | 242 Hendrickson Drive Princeton Junction New Jersey 08550 Usa | American | 33491720001 | ||||||
| KAWKABANI, Nagi Robert | Geschäftsführer | 47 Lennox Gardens SW1 London | United Kingdom | Canadian | 33491730003 | |||||
| LONG, David | Geschäftsführer | Cabot Square E14 4QJ London One United Kingdom | United Kingdom | British | 126956520001 | |||||
| MASMEJEAN, Pierre Olivier | Geschäftsführer | 66 Redcliffe Road SW10 9NQ London | French | 49032650001 | ||||||
| PETRILLI, Anthony Mario | Geschäftsführer | 18 Icklingham Road KT11 2NQ Cobham Surrey | British | 54390740001 | ||||||
| PIKE, Catherine Elizabeth | Geschäftsführer | 75 Noel Road N1 8HE London | British | 45313610002 | ||||||
| RATTNER, Steven Charles | Geschäftsführer | 408 Grace Church Street Rye New York Ny 10580 Usa | American | 70635020001 | ||||||
| ROBINSON, Nicholas Ian | Geschäftsführer | Beechwood Little Orchards Salvington Hill BN13 3BD Worthing West Sussex | British | 44793820001 | ||||||
| ROE, Steven Robin Charles | Geschäftsführer | 10 Eastwood Bridgewater Road KT13 0EG Weybridge Surrey | British | 34616850002 | ||||||
| SANTS, Hector William Hepburn | Geschäftsführer | Court Farm Worminghall HP18 9LD Aylesbury Buckinghamshire | British | 1576920001 | ||||||
| SEET, Joe Lip Poh | Geschäftsführer | 6 Padbrook RH8 0DW Oxted Surrey | British | 52359050001 | ||||||
| SMITH, Martin, Sir | Geschäftsführer | 4 Essex Villas W8 7BN London | United Kingdom | British | 35552480001 | |||||
| STUDD, Kevin Lester | Geschäftsführer | Cabot Square E14 4QJ London One United Kingdom | United Kingdom | British | 86302520001 | |||||
| WRIGHT, Geraldine Helen | Geschäftsführer | 30 High Gables 1 Scotts Avenue BR2 0NB Bromley Kent | British | 83599210001 |
Hat DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE INTERNATIONAL Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Collateral agreement governing secured borrowings by participants in the euroclear system | Erstellt am 06. Sept. 1996 Geliefert am 11. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All borrowings (meaning overdraft, fixed term advances or securities borrowing, or any other extension of credit by morgan guaranty trust company of new york to the borrower, in whatever form, that relates to or results from the borrower's use of the euroclear system, as well as any fees or accrued interest with respect thereto), and other obligations, in whatever form, that relate to or result from the borrower's use of the euroclear system, now outstanding or which may be outstanding at any time in the future to morgan guaranty brussels and to any other office of morgan guaranty trust company of new york | |
Kurze Angaben All "collateral" including in particular cash and securities clearance accounts opened in connection with the euroclear system by the brussels office of morgan guaranty on its books in the name of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 22. Sept. 1992 Geliefert am 07. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All shares, stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities, together with all benefits arising therefrom and not transferred or delivered by or at the direction of the stock exchange to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0