NORTHAMPTON CABLE TELEVISION LIMITED

NORTHAMPTON CABLE TELEVISION LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNORTHAMPTON CABLE TELEVISION LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02475464
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NORTHAMPTON CABLE TELEVISION LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich NORTHAMPTON CABLE TELEVISION LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    160 Great Portland Street
    London
    W1W 5QA
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NORTHAMPTON CABLE TELEVISION LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WATCHCHART LIMITED28. Feb. 199028. Feb. 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NORTHAMPTON CABLE TELEVISION LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für NORTHAMPTON CABLE TELEVISION LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Sept. 2010

    Kapitalaufstellung am 02. Sept. 2010

    • Kapital: GBP 201
    SH01

    legacy

    25 SeitenMG01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG04

    Beendigung der Bestellung von Virgin Media Secretaries Limited als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Robert Charles Gale als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Gillian Elizabeth James als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Virgin Media Directors Limited als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Robert Mario Mackenzie als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Virgin Media Secretaries Limited als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    legacy

    15 SeitenMG01

    legacy

    19 SeitenMG01

    legacy

    18 SeitenMG01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    4 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    6 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von NORTHAMPTON CABLE TELEVISION LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Sekretär
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    151240110001
    GALE, Robert Charles
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish96956740001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    BUCHANAN, Kenneth William
    7 Alexander Place
    KA12 0UR Irvine
    North Ayrshire
    Sekretär
    7 Alexander Place
    KA12 0UR Irvine
    North Ayrshire
    British94162280001
    CLIFFORD, John Francis
    Dragoon House 37 Artillery Lane
    E1 7LT London
    Sekretär
    Dragoon House 37 Artillery Lane
    E1 7LT London
    British10294370001
    JAMES, Gillian Elizabeth
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    Sekretär
    148 Selwyn Avenue
    Highams Park
    E4 9LS London
    British72139660001
    LUBASCH, Richard Joel
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    Sekretär
    4 Beech Tree Lane
    NEW YORK Brookville
    11545
    Usa
    British81075820001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Sekretär
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    British47785600002
    VELTHUIJSEN, Dirk Peter
    Boerhaavelaan 73
    Leiden 2334ee
    FOREIGN The Netherlands
    Sekretär
    Boerhaavelaan 73
    Leiden 2334ee
    FOREIGN The Netherlands
    Dutch57377690001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    ACHBER, Vernon
    2 Ashton Place
    Sandisplatt Road
    SL6 Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    2 Ashton Place
    Sandisplatt Road
    SL6 Maidenhead
    Berkshire
    Canadian30200520001
    ADAMS, Dorothy Dehart
    Noord Crailoseweg 4a
    1272 Re Huizen
    Holland
    Geschäftsführer
    Noord Crailoseweg 4a
    1272 Re Huizen
    Holland
    Netherlands76660320001
    ALLEN, Charles George
    16 Sunny Rose Court
    Whitby
    L1R 2V8 Ontario
    Canada
    Geschäftsführer
    16 Sunny Rose Court
    Whitby
    L1R 2V8 Ontario
    Canada
    Canadian34264050001
    CARTER, Stephen Andrew
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    Geschäftsführer
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    United KingdomBritish59445920002
    DEAN, Pamela Margaret
    Gayfere Mark Way
    GU7 2BQ Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    Gayfere Mark Way
    GU7 2BQ Godalming
    Surrey
    British2100680001
    DEAN, Ronald William
    Gayfere Mark Way
    GU7 2BQ Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    Gayfere Mark Way
    GU7 2BQ Godalming
    Surrey
    British2100690001
    DEELMAN, Gerard Betto
    Kerkweg 41
    Nootdorp
    2631 Cc
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    Kerkweg 41
    Nootdorp
    2631 Cc
    The Netherlands
    Dutch53867330001
    FAIBISH, Roy Abraham
    22 Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Geschäftsführer
    22 Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British10294410001
    GALE, Robert Charles
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    Geschäftsführer
    Station Road
    KT7 0NS Thames Ditton
    42
    Surrey
    EnglandBritish96956740001
    GRAFSTEIN, Jerahmiel Samson, Senator
    499 Spadina Road
    M5P 2W6 Toronto
    Ontario
    Canada
    Geschäftsführer
    499 Spadina Road
    M5P 2W6 Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian16084800001
    GREGG, John Francis
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    Geschäftsführer
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    American75381740001
    HAGENDOORN, Robert Jan
    Voorweg 79c
    2391 AD Hazerswoude Dorp
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Voorweg 79c
    2391 AD Hazerswoude Dorp
    Netherlands
    Dutch57284700001
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish87146390001
    KNAPP, James Barclay
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Geschäftsführer
    54 Hodge Road
    Princeton
    New Jersey 08540
    Usa
    Us Citizen79688880001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Geschäftsführer
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Geschäftsführer
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    MCDONALD, James Douglas
    Box 22 Site 5 Rr2
    Stony Plain Alberta T6e 2g0
    FOREIGN Canada
    Geschäftsführer
    Box 22 Site 5 Rr2
    Stony Plain Alberta T6e 2g0
    FOREIGN Canada
    Canadian34612650001
    MCKELLAR, Ronald Alexander
    Halstead
    Stratfield Saye
    RG7 2EJ Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Halstead
    Stratfield Saye
    RG7 2EJ Reading
    Berkshire
    British7345780001
    PARROTTA, Frank
    99 Wakina Drive
    TOE 2GO Edmonton
    Alberta T5t 2x4
    Canada
    Geschäftsführer
    99 Wakina Drive
    TOE 2GO Edmonton
    Alberta T5t 2x4
    Canada
    Italian34759200001
    PETTY, George Kibbe
    5016-154 Street
    T6H 5P3 Edmonton
    Alberta
    Canada
    Geschäftsführer
    5016-154 Street
    T6H 5P3 Edmonton
    Alberta
    Canada
    American45398580001
    RICHTER, Bret
    245 East 63rd Street
    Apartment 20h
    10021 New York
    New York
    United States
    Geschäftsführer
    245 East 63rd Street
    Apartment 20h
    10021 New York
    New York
    United States
    American86830760001
    ROBERTS, Gareth Nigel Christopher
    20 Aspen Lodge
    Abbots Walk
    W8 5UN London
    Geschäftsführer
    20 Aspen Lodge
    Abbots Walk
    W8 5UN London
    British145824690001
    ROSS, Stuart
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    Geschäftsführer
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    EnglandBritish20168110001
    SCHERMERHORN, Dirk, Drs
    Baron Van Heemstralaan 12
    2172 JE Sassenheim
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    Baron Van Heemstralaan 12
    2172 JE Sassenheim
    The Netherlands
    Dutch55373980001
    SCHUBERT, Scott Elliott
    9 William Street House
    William Street
    SW1X 9HH London
    Geschäftsführer
    9 William Street House
    William Street
    SW1X 9HH London
    American89618040001

    Hat NORTHAMPTON CABLE TELEVISION LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 29. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 24. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An alternative bridge composite debenture
    Erstellt am 16. Juni 2006
    Geliefert am 29. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Alternative Bridge Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 29. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 24. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 13. Apr. 2004
    Geliefert am 22. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charges all right, title and interest in: 1) the english charged land 2) the tangible moveable property 3) the accounts 4) the intellectual property 5) any goodwill 6) the investments 7) the shares and all dividends 8) all monetary claims by way of assignment all right, title and interest in: 1) any insurance policy 2) all agreements, contracts, deeds, licences, undertakings 3) chattels hired, leased or rented 4) licences held. By way of floating charge the whole undertaking and assets not effectively charged. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Aug. 2002
    Geliefert am 30. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • J.P.Morgan Europe Limited
    Transaktionen
    • 30. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 08. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    First legal mortgage on the category and first fixed equitable charge on all other real property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Chase Manhattan Bank N.A.London Branch, as Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Dez. 1994
    Geliefert am 23. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the debenture and the facility agreement (as defined in the deed)
    Kurze Angaben
    First legal mortgage on the category a real property and first fixed equitable charge over all other real property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Chase Manhattan Bank N.A.London Branch
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0