DELTA ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DELTA ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02477045 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DELTA ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich DELTA ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | KROLL ADVISORY LTD The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DELTA ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DELTA COOLING SEVICES LIMITED | 20. Apr. 1990 | 20. Apr. 1990 |
| PRIORSHINE LIMITED | 05. März 1990 | 05. März 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DELTA ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DELTA ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 42 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Velocity 1 Brooklands Drive Brooklands Weybridge Surrey KT13 0SL England zum The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG am 14. Dez. 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Cessation of Iss Technical Services Ltd as a person with significant control on 04. Nov. 2022 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Iss Brightspark Limited as a person with significant control on 04. Nov. 2022 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 12 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. März 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Joanne Roberts als Direktor am 22. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bruce Andrew Van Der Waag als Geschäftsführer am 22. Okt. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephanie Louise Hamilton als Geschäftsführer am 31. Juli 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Elizabeth Michelle Benison als Direktor am 21. Mai 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. März 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Stephanie Louise Hamilton als Direktor am 22. Feb. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip John Leigh als Geschäftsführer am 28. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Purvin Kumar Madhusudan Patel als Geschäftsführer am 23. Dez. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Purvin Kumar Madhusudan Patel als Direktor am 16. Juni 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Edward Stanley Brabin als Geschäftsführer am 16. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DELTA ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENISON, Elizabeth Michelle | Geschäftsführer | 32 London Bridge Street SE1 9SG London The Shard | England | British | 283639230001 | |||||
| ROBERTS, Joanne | Geschäftsführer | 32 London Bridge Street SE1 9SG London The Shard | England | British | 288760280001 | |||||
| BRABIN, Matthew | Sekretär | Genesis Business Park Albert Drive GU21 5RW Woking Iss House Surrey England | 194305230001 | |||||||
| CHANDLER, Edward Charles | Sekretär | Poole CW5 6AP Nantwich Orchard Cottage Cheshire England | British | 135515060001 | ||||||
| DAVIDSON, Ian | Sekretär | Genesis Business Park Albert Drive GU21 5RW Woking Iss House Surrey England | 149169280001 | |||||||
| GORNALL, Anthony Thomas | Sekretär | 20 The Elms ST5 8RP Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | 30889020002 | ||||||
| HODGSON, Julie Sandra | Sekretär | 17 Glendale Grove Spital L63 9FP Bebington Wirral | British | 32508700001 | ||||||
| SIMONS, David Thomas | Sekretär | 8 Rowley Hall Drive Rowley Hall Park ST17 9FF Stafford Staffordshire | British | 74951460001 | ||||||
| ADAMS, Stephen Kenneth | Geschäftsführer | Ivy Gardens FY5 4NZ Thornton-Cleveleys 17 Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 135344800001 | |||||
| BRABIN, Matthew Edward Stanley | Geschäftsführer | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | England | British | 92458830002 | |||||
| BRABIN, Matthew Edward Stanley | Geschäftsführer | Genesis Business Park Albert Drive GU21 5RW Woking Iss House Surrey England | England | British | 92458830002 | |||||
| BROOKS, Graham | Geschäftsführer | 48 Charterhouse Drive L10 8JZ Liverpool Merseyside | England | British | 73570670002 | |||||
| CHANDLER, Edward Charles | Geschäftsführer | Orchard Cottage Poole CW5 6AP Nantwich Cheshire | United Kingdom | British | 106101920001 | |||||
| DAVIDSON, Ian | Geschäftsführer | Forge Lane ST1 5PZ Stoke On Trent Gsh House Staffordshire | England | British | 127506640001 | |||||
| DAVY, John | Geschäftsführer | Genesis Business Park Albert Drive GU21 5RW Woking Iss House Surrey England | United Kingdom | British | 149169980001 | |||||
| GORNALL, Anthony Thomas | Geschäftsführer | 20 The Elms ST5 8RP Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | 30889020002 | ||||||
| HAMILTON, Stephanie Louise | Geschäftsführer | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | United Kingdom | British | 280463790001 | |||||
| HODGSON, Gary Lawrence | Geschäftsführer | Casa Sarga Liverpool Road CH64 7TW Thornton Hough Cheshire | British | 32508710005 | ||||||
| KIDD, Gary John | Geschäftsführer | Genesis Business Park Albert Drive GU21 5RW Woking Iss House Surrey England | United Kingdom | British | 190462280001 | |||||
| LEIGH, Philip John | Geschäftsführer | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | England | British | 156680600002 | |||||
| MCLAIN, Christopher Ian | Geschäftsführer | 11 Fairhaven Wychwood Park CW2 5GG Weston Cheshire | British | 116641750001 | ||||||
| PATEL, Purvin Kumar Madhusudan | Geschäftsführer | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | England | British | 271205360001 | |||||
| PLUCNAR JENSEN, Barbara | Geschäftsführer | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | England | Danish | 216409100001 | |||||
| REYNOLDS, Jamie | Geschäftsführer | 254 Leek Road Endon ST9 9DY Stoke On Trent Broomfield House Staffordshire England | England | British | 148711330001 | |||||
| SIMONS, David Thomas | Geschäftsführer | 8 Rowley Hall Drive Rowley Hall Park ST17 9FF Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | 74951460001 | |||||
| SYKES, Richard Ian | Geschäftsführer | Genesis Business Park Albert Drive GU21 5RW Woking Iss House Surrey England | United Kingdom | British | 93113770004 | |||||
| TENNENT, Colin Robert | Geschäftsführer | 69a Main Road Goostrey CW4 8JR Crewe Cheshire | England | British | 23661940005 | |||||
| VAN DER WAAG, Bruce Andrew | Geschäftsführer | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | England | Dutch | 195067340001 | |||||
| VESTERGAARD, Jorn | Geschäftsführer | Genesis Business Park Albert Drive GU21 5RW Woking Iss House Surrey | United Kingdom | Danish | 198906050001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DELTA ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iss Brightspark Limited | 04. Nov. 2022 | Brooklands Drive KT13 0SL Weybridge Velocity 1 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Iss Technical Services Ltd | 06. Apr. 2016 | Brooklands Drive KT13 0SL Weybridge Velocity 1 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat DELTA ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture | Erstellt am 05. Juli 2012 Geliefert am 12. Juli 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture and guarantee | Erstellt am 23. Feb. 2010 Geliefert am 05. März 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & equipment see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 26. Sept. 2001 Geliefert am 09. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The leasehold property known as or being delta house dutton green stanney mill chester CH2 4SA. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Juni 1995 Geliefert am 27. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 8 westminster road ellesmere port south wirral cheshire together with all buildings and fixtures thereoassigns goodwill of the business (if any. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Juni 1995 Geliefert am 24. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £12,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H premises k/a 8 westminster road, ellesmere port, south wirral, cheshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 08. Mai 1990 Geliefert am 17. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat DELTA ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0