CYNEDVE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCYNEDVE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02477631
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CYNEDVE LIMITED?

    • Pflegeheime für ältere und behinderte Menschen (87100) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich CYNEDVE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Pinsent Masons Llp
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CYNEDVE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis29. Juni 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für CYNEDVE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    13 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Jan. 2020

    9 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Jan. 2019

    8 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 30. Jan. 2018

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Part Ground Floor & First Floor Two Parklands, Great Park Rubery, Rednal Birmingham B45 9PZ zum C/O Pinsent Masons Llp 1 Park Row Leeds LS1 5AB am 20. Dez. 2017

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Patricia Lesley Lee als Geschäftsführer am 31. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Feb. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Juni 2016

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. März 2016

    Kapitalaufstellung am 01. März 2016

    • Kapital: GBP 67,180
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Juni 2015

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Feb. 2015

    Kapitalaufstellung am 18. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 67,180
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Juni 2014

    8 SeitenAA

    Ernennung von Ms Patricia Lesley Lee als Direktor am 22. Okt. 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Albert Edward Smith als Geschäftsführer am 22. Okt. 2014

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 27 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Juni 2013

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 18. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 67,180
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Katharine Kandelaki als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Verschiedenes

    Auditor resignation sec 519
    2 SeitenMISC

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Dez. 2012 bis 29. Juni 2013

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    5 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von CYNEDVE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MANSON, David Lindsay
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    C/O Pinsent Masons Llp
    England
    Geschäftsführer
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    C/O Pinsent Masons Llp
    England
    United KingdomBritishDirector167628190001
    AMLANI, Pritesh
    Birling Road
    Ryarsh
    ME19 5LS West Malling
    Ryarsh Oast House
    Kent
    United Kingdom
    Sekretär
    Birling Road
    Ryarsh
    ME19 5LS West Malling
    Ryarsh Oast House
    Kent
    United Kingdom
    British125206220002
    DAVIES, Vera
    Tyddyn Uchaf Henllan Road
    LL16 3AP Denbigh
    Denbighshire
    Sekretär
    Tyddyn Uchaf Henllan Road
    LL16 3AP Denbigh
    Denbighshire
    British52017050001
    KANDELAKI, Katharine Amelia Christabel
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    Sekretär
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    160358440001
    THOMAS, Cynthia
    Tan Y Graig
    High St Trelawnyd
    LL18 6DT Rhyl
    Clwyd
    Sekretär
    Tan Y Graig
    High St Trelawnyd
    LL18 6DT Rhyl
    Clwyd
    BritishDirector9443400004
    THOMAS, Edward John
    Tan Y Graig
    High St Trelawnyd
    LL18 6DT Rhyl
    Clwyd
    Sekretär
    Tan Y Graig
    High St Trelawnyd
    LL18 6DT Rhyl
    Clwyd
    British9443390004
    DAVIES, Vera
    Tyddyn Uchaf Henllan Road
    LL16 3AP Denbigh
    Denbighshire
    Geschäftsführer
    Tyddyn Uchaf Henllan Road
    LL16 3AP Denbigh
    Denbighshire
    BritishDirector Secretary52017050001
    LEE, Patricia Lesley
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    Geschäftsführer
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United KingdomBritishChief Executive192233540001
    PERRY, David William
    28 Welbeck Street
    London
    W1G 8EW
    Geschäftsführer
    28 Welbeck Street
    London
    W1G 8EW
    EnglandBritishDirector33988060002
    SMITH, Albert Edward
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Two Parklands, Great Park
    Rubery, Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Part Ground Floor & First Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector77631340001
    THOMAS, Craig Vaughan
    Cae Glas
    Marian, Trelawnyd
    LL18 6EB Rhyl
    Clwyd
    Geschäftsführer
    Cae Glas
    Marian, Trelawnyd
    LL18 6EB Rhyl
    Clwyd
    BritishBusiness Manager59897250002
    THOMAS, Cynthia
    Tan Y Graig
    High St Trelawnyd
    LL18 6DT Rhyl
    Clwyd
    Geschäftsführer
    Tan Y Graig
    High St Trelawnyd
    LL18 6DT Rhyl
    Clwyd
    BritishDirector9443400004
    THOMAS, Edward John
    Tan Y Graig
    High St Trelawnyd
    LL18 6DT Rhyl
    Clwyd
    Geschäftsführer
    Tan Y Graig
    High St Trelawnyd
    LL18 6DT Rhyl
    Clwyd
    BritishDirector9443390004
    THOMAS, Mark Ellis
    111 Meliden Road
    LL19 8LU Prestatyn
    Clwyd
    Geschäftsführer
    111 Meliden Road
    LL19 8LU Prestatyn
    Clwyd
    WalesBritishCompany Director61217970001
    TREON, Anoup
    Apt 1, Cambridge Gate
    Regents Park
    NW1 4JX London
    Geschäftsführer
    Apt 1, Cambridge Gate
    Regents Park
    NW1 4JX London
    United KingdomBritishBusiness Adviser152212470001
    TREON, Jaynee Sunita
    28 Welbeck Street
    London
    W1G 8EW
    Geschäftsführer
    28 Welbeck Street
    London
    W1G 8EW
    United KingdomBritishDirector42532090004

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CYNEDVE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Embrace Realty (Cavendish) Ltd
    Parklands
    Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands Business Park
    England
    06. Apr. 2016
    Parklands
    Rednal
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands Business Park
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Company Limited Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortEngland
    Registrierungsnummer05930808
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat CYNEDVE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 25. Juli 2012
    Geliefert am 03. Aug. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 10. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 25. März 2011
    Geliefert am 06. Apr. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the lenders or any of them on any account whatsoever and to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge and all monies due or to become due from each other chargor and each other member of the group to the lenders or any of them on any account whatsoever and to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 01. Aug. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 18. Jan. 2007
    Geliefert am 01. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rp&C International Investments Llc
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Jan. 2007
    Geliefert am 26. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 26. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Mai 2006
    Geliefert am 23. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    81A dyserth road rhyl denbighshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Nov. 2004
    Geliefert am 26. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Cartref y borth nursing home betws road llanrwst county borough of conwy. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Juli 2004
    Geliefert am 31. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Cartrefle residential home betws road ll. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 2003
    Geliefert am 13. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plas gwynfa care home plastirion park towyn abergele conwy. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Dez. 2003
    Geliefert am 13. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 2003
    Geliefert am 13. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Sandy lodge nursing home 83 dyserth road rhyl denbighshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 2003
    Geliefert am 13. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Bryn cwybra rhyl road rhuddlan denbighshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 2003
    Geliefert am 13. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Bryn cwybra rhyl road rhuddlan denbighshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 2003
    Geliefert am 13. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Preswylfa 20 russell road rhyl denbighshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Juni 2000
    Geliefert am 13. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or an affliate
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings as plas gwynfa nursing and residential care home plastirion abergele conwy - WA869363 together with all licences and the benefits of all agreements relating to such property or proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 13. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Dez. 1998
    Erworben am 30. Juni 2000
    Geliefert am 07. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a plas gwynfa nursing and residential care home, plastirion park towyn abergele.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Healthcare Finance No.1 Limited
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2001Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 17. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Dez. 1998
    Erworben am 30. Juni 2000
    Geliefert am 07. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a plas gwynfa nursing and residential care home, plastirion park, towyn, abergele.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2001Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 17. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Dez. 1998
    Geliefert am 21. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Nov. 1997
    Geliefert am 26. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Canterbury house nursing home 77 dyserth road rhyl denbighshire t/n WA679542 the benefit of all licences all compensation payable the goodwill of the business the benefit of all guarantees. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Healthcare Finance Number 1 Limited
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Nov. 1997
    Geliefert am 26. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Canterbry house nursing home 77 dyserth road rhyl denbighshire t/n WA679542 prewylfa nursing home 20 russell road rhyl denbighshire t/n WA621510 sandy lodge nursing home 83 dyserth road rhyl denbighshire t/n WA410142 bryn cwybr nursing home rhyl road rhuddlan denbighshire t/n WA603429 the benefit of all licences,the goodwill of the business and the benefit of all guarantees. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Policy assignment deed
    Erstellt am 05. Sept. 1997
    Geliefert am 23. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Allied dunbar policies numbered 5090-765-das and 5809-765-das together with all rights to all monies that may become payable thereunder and all securities and other benefit which may accrue thereunder.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Sept. 1997
    Geliefert am 23. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Preswylfa nursing home 20 russell road rhyl denbigshire t/n WA621510; sandy lodge nursing home 83 dyserth road rhyl denbigshire t/n WA410142; bryn cwybr nursing house rhyl road rhuddlan denbigshire t/n WA603429 assigns: the benefit of all licences, all compensation payable, the goodwill of the business, the benefit of all guarantees or covenants. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Sept. 1997
    Geliefert am 23. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Sept. 1996
    Geliefert am 12. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The poplars, 23 st margarets drive rhyl; any goodwill of any business from time to time carried on at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juli 1992
    Geliefert am 15. Juli 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H bryn cwybr nursing home rhyl road rhuddlan clwyd together with all fixtures and fittings and the benefits of rights licences and the goodwill of the business.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 16. Juni 1992
    Geliefert am 17. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge on all bookdebts and other debts goodwill and uncalled capital trademarks patents floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CYNEDVE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Jan. 2018Beginn der Liquidation
    09. Sept. 2020Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0