HUTLEY LAND LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHUTLEY LAND LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02477738
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HUTLEY LAND LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich HUTLEY LAND LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Wintershall Estate
    Bramley
    GU5 0LR Guildford
    Surrey
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HUTLEY LAND LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HUTLEY LAND INDUSTRIAL LIMITED28. Juni 199028. Juni 1990
    HALFBRIDGE ASSOCIATES LIMITED06. März 199006. März 1990

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HUTLEY LAND LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für HUTLEY LAND LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für HUTLEY LAND LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Ernennung von Mr Alastair Manson als Sekretär am 01. Juli 2014

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Sharon Louise Craigie als Sekretär am 01. Juli 2014

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mrs Sharon Louise Craigie als Sekretär am 30. Apr. 2014

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Teresa Abercrombie als Sekretär am 30. Apr. 2014

    1 SeitenTM02

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2013 bis 30. Sept. 2013

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 25. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Ernennung von Ms Teresa Abercrombie als Sekretär am 21. Dez. 2012

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Alastair Manson als Sekretär am 21. Dez. 2012

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Ernennung von Mr Alastair Manson als Sekretär am 24. Feb. 2012

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Douglas Terence Dean als Sekretär am 24. Feb. 2012

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Douglas Terence Dean als Sekretär am 09. Nov. 2011

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Margaret Elizabeth Bardsley als Sekretär am 09. Nov. 2011

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Henrietta Fiddian Green am 31. Aug. 2010

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Andrea Disley als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mrs Margaret Elizabeth Bardsley als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    12 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    12 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von HUTLEY LAND LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MANSON, Alastair
    Wintershall Estate
    Bramley
    GU5 0LR Guildford
    Surrey
    Sekretär
    Wintershall Estate
    Bramley
    GU5 0LR Guildford
    Surrey
    189500620001
    DE KLEE, Charlotte Ann Margaret
    Lochiehead
    Auchtermuchty
    KY14 7EH Cupar
    Fife
    Geschäftsführer
    Lochiehead
    Auchtermuchty
    KY14 7EH Cupar
    Fife
    ScotlandBritish3306730004
    FIDDIAN GREEN, Henrietta
    Wintershall Cottage
    Thorncombe Street, Bramley
    GU5 0LT Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Wintershall Cottage
    Thorncombe Street, Bramley
    GU5 0LT Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish71523600002
    HUTLEY, Edward Thomas William
    Slades Farm House
    Thorncombe Street
    GU5 0LT Bramley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Slades Farm House
    Thorncombe Street
    GU5 0LT Bramley
    Surrey
    EnglandEnglish43684040004
    HUTLEY, Nicholas Peter
    Gate Street Farm House
    GU5 0LR Bramley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Gate Street Farm House
    GU5 0LR Bramley
    Surrey
    United KingdomBritish6182110001
    HUTLEY, Peter William
    Wintershall Estate
    Bramley
    GU5 0LR Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Wintershall Estate
    Bramley
    GU5 0LR Guildford
    Surrey
    EnglandEnglish34336720001
    ABERCROMBIE, Teresa
    Wintershall Estate
    Bramley
    GU5 0LR Guildford
    Surrey
    Sekretär
    Wintershall Estate
    Bramley
    GU5 0LR Guildford
    Surrey
    174577040001
    BAMFORD, Ruth Elizabeth
    1 Elm Terrace, Hawkley Road
    GU33 6JH Liss
    Hampshire
    Sekretär
    1 Elm Terrace, Hawkley Road
    GU33 6JH Liss
    Hampshire
    British121364550001
    BARDSLEY, Margaret Elizabeth
    Brecon Close
    GU14 9JH Farnborough
    15
    Hampshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Brecon Close
    GU14 9JH Farnborough
    15
    Hampshire
    United Kingdom
    152948020001
    COLEBY, Angela
    24 Leavesden Road
    KT13 9BX Weybridge
    Surrey
    Sekretär
    24 Leavesden Road
    KT13 9BX Weybridge
    Surrey
    British75664550001
    CRAIGIE, Sharon Louise
    Gate Street
    Bramley
    GU5 0LR Guildford
    Wintershall Estate
    Surrey
    England
    Sekretär
    Gate Street
    Bramley
    GU5 0LR Guildford
    Wintershall Estate
    Surrey
    England
    187295540001
    DEAN, Douglas Terence
    Wintershall Estate
    Bramley
    GU5 0LR Guildford
    Surrey
    Sekretär
    Wintershall Estate
    Bramley
    GU5 0LR Guildford
    Surrey
    164448350001
    DISLEY, Andrea Clare
    Mary Road
    GU1 4QU Guildford
    8
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Mary Road
    GU1 4QU Guildford
    8
    Surrey
    United Kingdom
    British134466560001
    EVANS, Brian
    Inholms Inholms Lane
    North Holmwood
    RH5 4JH Dorking
    Surrey
    Sekretär
    Inholms Inholms Lane
    North Holmwood
    RH5 4JH Dorking
    Surrey
    British43417740001
    HOWIE, Pamela Cheryl
    16 Grosvenor Mews
    Prices Lane
    RH2 8BG Reigate
    Surrey
    Sekretär
    16 Grosvenor Mews
    Prices Lane
    RH2 8BG Reigate
    Surrey
    British66953480001
    HURTLEY, Charles Frederick
    Raglan
    New Park Road
    GU6 7HJ Cranleigh
    Surrey
    Sekretär
    Raglan
    New Park Road
    GU6 7HJ Cranleigh
    Surrey
    British112422010001
    HUTLEY, Edward Thomas William
    Slades Farm House
    Thorncombe Street
    GU5 0LT Bramley
    Surrey
    Sekretär
    Slades Farm House
    Thorncombe Street
    GU5 0LT Bramley
    Surrey
    English43684040004
    MANSON, Alastair
    Wintershall Estate
    Bramley
    GU5 0LR Guildford
    Surrey
    Sekretär
    Wintershall Estate
    Bramley
    GU5 0LR Guildford
    Surrey
    167022170001
    MICHELL, Simon Toby
    73 Lynette Avenue
    Clapham
    SW4 9HF London
    Sekretär
    73 Lynette Avenue
    Clapham
    SW4 9HF London
    British4760440001
    PELLY, Douglas Edwyn Vincent
    10 Freelands Road
    KT11 2ND Cobham
    Surrey
    Sekretär
    10 Freelands Road
    KT11 2ND Cobham
    Surrey
    British27223770001
    SHILLING, Ruth Elizabeth
    1 Elm Terrace
    Hawkley Road
    GU33 6JH Liss
    Hampshire
    Sekretär
    1 Elm Terrace
    Hawkley Road
    GU33 6JH Liss
    Hampshire
    British86913320001
    DE KEE, Ruper Murray
    29 Kensington Park Square
    W11 2QS London
    Geschäftsführer
    29 Kensington Park Square
    W11 2QS London
    British36649500005

    Hat HUTLEY LAND LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of assignment of hedging arrangement monies
    Erstellt am 16. Apr. 2002
    Geliefert am 27. Apr. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights,title and interein respect of any hedging instrument,as defined,cap or other interest regulating agreement completed by the company (if at all) in respect of the interest or acceptance commission and discount charges payable under the facility agreement; see form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Apr. 2002
    Geliefert am 27. Apr. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold and l/hold property known as 103 high street,putney,london; t/no 231576 with all buildings,fixtures,plant,machinery,vehicles,computers,office and other equipment thereon; first fixed charge over all the benefit of all rights and claims whatsoever and floating charge over all undertaking,property,rents,assets,revenues,rights and uncalled capital; see form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Apr. 2002
    Geliefert am 27. Apr. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold and l/hold property known as eastgate house 221/227 high street,guildford; SY244706;with all buildings,fixtures,plant,machinery,vehicles,computers,office and other equipment thereon; first fixed charge over all the benefit of all rights and claims whatsoever and floating charge over all undertaking,property,rents,assets,revenues,rights and uncalled capital; see form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. März 2001
    Geliefert am 11. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as 103 high street putney london SW15 title number 231576 all buildings and fixtures (excluding tenant's and trade fixtures) all plant machinery vehicles computers and office and other equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge with floating charge (including assignment of rents)
    Erstellt am 31. März 2000
    Geliefert am 15. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan facility agreement dated 09/07/98
    Kurze Angaben
    Freehold land k/a eastgate house 221/227 high street guildford surrey t/n SY244706 and all buildings and fixtures fittings (including trade fixtures and fittings)and fixed plant machinery all plant machinery & equipment all rights please refer to form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Riggs Bank Europe Limited
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Memorandum of deposit of securities
    Erstellt am 15. Jan. 1999
    Geliefert am 19. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All the liabilities of tilebox limited to the chargee of any kind in any currency (whether present or future actual or contingent and whether incurred alone or jointly with another) together with the chargee charges and commission interest and expenses
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the securities and all income derived from the securities and all rights attaching to the securities.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage over securities
    Erstellt am 21. Apr. 1998
    Geliefert am 02. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the loan facility or other financial accomodation from time to time granted or otherwise made available pursuant thereto,together with all expenses and any interest under the terms of the mortgage
    Kurze Angaben
    Two ordinary £1 shares held in hutley land (tunsgate) limited and all investments. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 02. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 19. Sept. 1997
    Geliefert am 03. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a 103 putney high street l/b of wandsworth together with all buildings and structures and all fixtures (including trade and tenants fixtures) at any time thereon floating charge over all unattached plant and machinery and other chattels at the time of the charge. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Sept. 1997
    Geliefert am 03. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land situate at spring street in the city of bristol together with all buildings and structures and all fixtures (including trade and enants fixtures) at any time thereon floating charge all unattached plant and other chattels at the time of the charge. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. März 1997
    Geliefert am 13. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the property k/a midleton industrial estate guildford as comprised in a lease dated 21 november 1996 together with all buildings and structures and all fixtures (including trade and tenants' fixtures). By way of fixed charge all plant and machinery and other chattels. By way of floating charge all unattached plant machinery and other chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 13. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Jan. 1996
    Geliefert am 02. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 02. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 22. Aug. 1995
    Geliefert am 30. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the finance documents (as defined) and/or in connection with the loan facility or other financial accommodation and this charge
    Kurze Angaben
    An assignment by way of security to the company's rights title and interest in and to a contract dated 17 august 1995 k/a isda master agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 30. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Aug. 1995
    Geliefert am 29. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All f/h property comprised in a conveyance dated 21/7/80 together with all buildings fixtures & improvements plant & machinery and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 29. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit agreement
    Erstellt am 22. Aug. 1995
    Geliefert am 29. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the assets being all monies standing to the credit of any account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 29. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the terms of this charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 103 putney street t/n 231576, buildings structures and all fixtures (including trade and tenants'fixtures), fixed charge all plant machinery and other chattels, floating charge over all unattached plant and machinery and other chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Apr. 1993
    Geliefert am 13. Mai 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever as amended by a supplemental debenture of even date
    Kurze Angaben
    All estates,rights and other interests in the f/h and l/h or other immovable property comprised in the land and buildings lying to the south of midleton road,guildford.t/no.SY300116,and the land adjoining weyside engineering works,midleton industrial estate,guildford.t/no.SY362450 together with all buildings,structures,fixtures and fittings and the fixed plant and machinery and all related spare parts,fuels,equipment and tools.floating charge all the undertaking and all the assets whatsoever and wheresoever of the company both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 13. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 06. Apr. 1992
    Geliefert am 21. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter
    Kurze Angaben
    All the co's entitlement to draw the balance standing to the credit of a deposit account....see form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • The British Linen Bank Limited
    Transaktionen
    • 21. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge and assignment
    Erstellt am 06. Apr. 1992
    Geliefert am 21. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge the sterling deposit account of the company with the lender designated "huntley land industrial limited -rental income account" and all moneys standing to the credit thereof and all rights title and interest in and to all rents profits etc please see doc M212C for details.
    Berechtigte Personen
    • The British Linen Bank Limited
    Transaktionen
    • 21. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 23. Aug. 1990
    Geliefert am 28. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A sterling deposit account with the bank ("the account") and all monies which may from time to time constitute the balance standing to the credit of the account.
    Berechtigte Personen
    • The British Linen Bank Limited
    Transaktionen
    • 28. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 17. Mai 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 31. Juli 1990
    Geliefert am 09. Aug. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold land & buildings lying to the south of midleton road and land adjoining weyside engineering works buildford, surrey t/no.s sy 3006116 sy 362450 including all fixtures, fittings, fixed plant & machinery. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The British Linen Bank Limited
    Transaktionen
    • 09. Aug. 1990Registrierung einer Belastung
    • 17. Mai 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0