ISI DISTRIBUTION LTD
Überblick
| Unternehmensname | ISI DISTRIBUTION LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02478802 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ISI DISTRIBUTION LTD?
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich ISI DISTRIBUTION LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Redwood 2 Crockford Lane Chineham Business Park, Chineham RG24 8WQ Basingstoke Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ISI DISTRIBUTION LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| IQ SYS LIMITED | 05. Okt. 2006 | 05. Okt. 2006 |
| INTERQUAD SYSTEMS LIMITED | 29. Dez. 2000 | 29. Dez. 2000 |
| INTERQUAD DISTRIBUTION LIMITED | 14. Mai 1998 | 14. Mai 1998 |
| EXOCOM INTERNATIONAL LIMITED | 03. Juli 1990 | 03. Juli 1990 |
| POWERBAND LIMITED | 08. März 1990 | 08. März 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ISI DISTRIBUTION LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ISI DISTRIBUTION LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Aug. 2018 | 9 Seiten | LIQ03 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 4 Seiten | LIQ01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 27. Juni 2017
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. März 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Hubbard als Geschäftsführer am 29. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr David Watts als Direktor am 26. Okt. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Howard Tuffnail als Direktor am 26. Okt. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Andy Gass als Direktor am 26. Okt. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 19 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Andrew Eccleston als Geschäftsführer am 28. Nov. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 20 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2014 bis 30. Juni 2014 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ISI DISTRIBUTION LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLLIS, Rachel Anne | Sekretär | Crockford Lane Chineham Business Park, Chineham RG24 8WQ Basingstoke Redwood 2 Hampshire United Kingdom | 178574660001 | |||||||
| GASS, Andrew | Geschäftsführer | Crockford Lane Chineham Business Park, Chineham RG24 8WQ Basingstoke Redwood 2 Hampshire | England | British | 49358720003 | |||||
| TUFFNAIL, Howard | Geschäftsführer | Crockford Lane Chineham Business Park, Chineham RG24 8WQ Basingstoke Redwood 2 Hampshire | United Kingdom | Canadian | 202334610001 | |||||
| WATTS, David | Geschäftsführer | Crockford Lane Chineham Business Park, Chineham RG24 8WQ Basingstoke Redwood 2 Hampshire | England | British | 160214110001 | |||||
| ARNETT, Edward Alan | Sekretär | 21 Clearwater Place Long Ditton KT6 4ET Surbiton Surrey | British | 84568350002 | ||||||
| HYAMS, Mitchell Spencer | Sekretär | Pipers Barn 55 Copperkins Lane HP6 5RA Amersham Buckinghamshire | British | 13800580002 | ||||||
| JOHNSON, Ian Paul | Sekretär | 20 Anglesey Drive SK12 1BT Poynton Ringwood Cheshire United Kingdom | British | 136279590001 | ||||||
| PENNELLS, John Richard | Sekretär | Enclave Wych Hill Way GU22 0AE Woking Surrey | British | 7347950001 | ||||||
| TRAINER, Martin John | Sekretär | 6 Stone Pine Road MK43 8GG Bromham Bedfordshire | British | 124180840001 | ||||||
| ARNETT, Edward Alan | Geschäftsführer | 21 Clearwater Place Long Ditton KT6 4ET Surbiton Surrey | British | 84568350002 | ||||||
| CORNWALL, Douglas Charles | Geschäftsführer | Domaine De La Roche Le Bigard GY8 0HT Forest Guernsey Channel Islands | United Kingdom | British | 84669710001 | |||||
| ECCLESTON, Paul Andrew | Geschäftsführer | Crockford Lane Chineham Business Park, Chineham RG24 8WQ Basingstoke Redwood 2 Hampshire United Kingdom | England | British | 139879610001 | |||||
| FANE, Sean Paul | Geschäftsführer | Nashgrove Lane Finchampstead RG40 4HG Wokingham 131 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 67225450007 | |||||
| HERRON, Bonnie Lea | Geschäftsführer | 1959 Trotters Lane Stone Mountain 30087 Georgia Usa | American | 16958430002 | ||||||
| HUBBARD, Peter | Geschäftsführer | Crockford Lane Chineham Business Park, Chineham RG24 8WQ Basingstoke Redwood 2 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 167795150001 | |||||
| HYAMS, Mitchell Spencer | Geschäftsführer | Pipers Barn 55 Copperkins Lane HP6 5RA Amersham Buckinghamshire | England | British | 13800580002 | |||||
| JAMES, Philip John | Geschäftsführer | Crockford Lane Chineham Business Park, Chineham RG24 8WQ Basingstoke Redwood 2 Hampshire United Kingdom | England | British | 118754760002 | |||||
| JOHNSON, Ian Paul | Geschäftsführer | 20 Anglesey Drive SK12 1BT Poynton Ringwood Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 136279590001 | |||||
| MACPHERSON, William Robert George | Geschäftsführer | Benenden TN17 4LG Cranbrook Little Nineveh Kent United Kingdom | England | British | 132097710001 | |||||
| MARTIN, Christian John | Geschäftsführer | Kingswood House Tag Lane Wargrave RG10 9ST Reading Berkshire | England | British | 113992220001 | |||||
| MCCORMICK, John Edgar | Geschäftsführer | 5275 Cameron Forest Parkway FOREIGN Alpharetti Georgia Usa | American | 16958460001 | ||||||
| MINNS, Gregory Leslie John | Geschäftsführer | 113 Paddick Drive RG6 4HF Lower Earley Berkshire | United Kingdom | British | 72170360001 | |||||
| PENNELLS, John Richard | Geschäftsführer | Enclave Wych Hill Way GU22 0AE Woking Surrey | England | British | 7347950001 | |||||
| RIGBY, James Peter | Geschäftsführer | Crockford Lane Chineham Business Park, Chineham RG24 8WQ Basingstoke Redwood 2 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 88633720001 | |||||
| RIGBY, Peter, Sir | Geschäftsführer | Crockford Lane Chineham Business Park, Chineham RG24 8WQ Basingstoke Redwood 2 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 15654920006 | |||||
| STRANGE, John Leland | Geschäftsführer | 2714 Meadow Church Road FOREIGN Duluth Georgia Usa | American | 16958470001 | ||||||
| TRAINER, Martin John | Geschäftsführer | 6 Stone Pine Road MK43 8GG Bromham Bedfordshire | England | British | 124180840001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ISI DISTRIBUTION LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialist Distribution Group (Sdg) Ltd | 06. Apr. 2016 | Guildford Road Normandy GU3 2AW Guildford Redwood 2 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ISI DISTRIBUTION LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A fixed charge on book and other debts | Erstellt am 04. Nov. 2011 Geliefert am 10. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All book debts and other debts and monetary claims and any rent licence fees or other payments due from any lessee, licensee or occupier of any immovable property wherever. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal assignment | Erstellt am 04. Nov. 2011 Geliefert am 10. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any credit balance due under the contract (the contract monies). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge on purchased debts which fail to vest | Erstellt am 04. Nov. 2011 Geliefert am 09. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed equitable charge all purchased debts which fail to vest effectively or absolutely in the security holder pursuant to the agreement see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 14. Okt. 2010 Geliefert am 27. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed & floating charge | Erstellt am 15. Mai 2009 Geliefert am 27. Mai 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Okt. 2007 Geliefert am 03. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Juni 2004 Geliefert am 05. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 15. Nov. 2000 Geliefert am 23. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Nov. 2000 Geliefert am 07. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Mai 1999 Geliefert am 13. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a guarantee agreement of even date and the deed | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Feb. 1999 Geliefert am 16. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 3 february 1999 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 28. Jan. 1999 Geliefert am 02. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 1998 Geliefert am 23. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all book and other debts present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance and by way of floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ISI DISTRIBUTION LTD Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0