CL 2022 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CL 2022 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02480658 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CL 2022 LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich CL 2022 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Salthrop House Hay Lane Basset Down SN4 9QP Swindon Wiltshire United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CL 2022 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CONRAN LIMITED | 13. Dez. 2001 | 13. Dez. 2001 |
TERENCE CONRAN LIMITED | 23. Juli 1990 | 23. Juli 1990 |
BLAKERANGE LIMITED | 13. März 1990 | 13. März 1990 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CL 2022 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CL 2022 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. März 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2022 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hardip Nijjar als Geschäftsführer am 13. Okt. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ground Floor 30a Great Sutton Street London EC1V 0DU England zum Salthrop House Hay Lane Basset Down Swindon Wiltshire SN4 9QP am 13. Dez. 2022 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed conran LIMITED\certificate issued on 17/06/22 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2021 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. März 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Nicholas James Douglas Bull als Direktor am 06. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Patrick Bowder-Ridger als Geschäftsführer am 06. Okt. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy Patrick Bowder-Ridger als Direktor am 29. Sept. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Patrick Bowder-Ridger als Geschäftsführer am 29. Sept. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ground Floor 45 Mitchell Street London EC1V 3QD England zum Ground Floor 30a Great Sutton Street London EC1V 0DU am 07. Juli 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2020 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 22 Shad Thames London SE1 2YU zum Ground Floor 45 Mitchell Street London EC1V 3QD am 09. Dez. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. März 2019 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roger Hugh Knight Seelig als Geschäftsführer am 12. Feb. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2019 bis 30. März 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 024806580002, erstellt am 15. Mai 2019 | 28 Seiten | MR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CL 2022 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULL, Nicholas James Douglas | Geschäftsführer | Hay Lane Basset Down SN4 9QP Swindon Salthrop House Wiltshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 35443110002 | ||||
DUNLEY, Elizabeth | Sekretär | 22 Shad Thames London SE1 2YU | 173167710001 | |||||||
GUNEWARDENA, Desmond Antony Lalith | Sekretär | 17 Copse Hill Wimbledon SW20 0NB London | British | Finance Director | 1514660004 | |||||
HAMILTON, Annalise | Sekretär | 29 Colville Road W11 2BT London | British | 2235970001 | ||||||
HOWE, Thomas John | Sekretär | Sussex Bell House Midhurst Road GU27 3DH Haslemere Surrey | British | Chartered Accountant | 102918530001 | |||||
SCHUITEMAKER, Martijn Anton | Sekretär | 17 Alexandra Wharf 1 Darwen Place E2 9SJ London | Dutch | 97082790001 | ||||||
BOWDER-RIDGER, Timothy Patrick | Geschäftsführer | 30a Great Sutton Street EC1V 0DU London Ground Floor England | England | British | Director | 130123030001 | ||||
BOWDER-RIDGER, Timothy Patrick | Geschäftsführer | 30a Great Sutton Street EC1V 0DU London Ground Floor England | England | British | Director | 202724660001 | ||||
CONRAN, Jasper Alexander Thirlby | Geschäftsführer | 22 Shad Thames London SE1 2YU | United Kingdom | British | Director | 147577130001 | ||||
CONRAN, Terence Orby, The Executors Of Sir | Geschäftsführer | Barton Court Kintbury RG17 9SA Hungerford Berkshire | England | British | Designer & Retailer | 35529410001 | ||||
DUNLEY, Elizabeth Anthea | Geschäftsführer | 22 Shad Thames London SE1 2YU | England | British | Finance Director | 173015770001 | ||||
GUNEWARDENA, Desmond Antony Lalith | Geschäftsführer | 17 Copse Hill Wimbledon SW20 0NB London | England | British | Director | 1514660004 | ||||
HAMILTON, Annalise | Geschäftsführer | 29 Colville Road W11 2BT London | British | Administration | 2235970001 | |||||
HOWE, Thomas John | Geschäftsführer | Sussex Bell House Midhurst Road GU27 3DH Haslemere Surrey | England | British | Finance Director | 102918530001 | ||||
MAVITY, Harold Roger Wallis | Geschäftsführer | 22 Shad Thames London SE1 2YU | England | British | Director | 122138820003 | ||||
NIJJAR, Hardip | Geschäftsführer | Hay Lane Basset Down SN4 9QP Swindon Salthrop House Wiltshire United Kingdom | England | British | Director | 253859240001 | ||||
SCHUITEMAKER, Martijn Anton | Geschäftsführer | 17 Alexandra Wharf 1 Darwen Place E2 9SJ London | Dutch | Finance Director | 97082790001 | |||||
SEELIG, Roger Hugh Knight | Geschäftsführer | 22 Shad Thames London SE1 2YU | England | British | Director | 202724630001 | ||||
WEBB, Jill Elizabeth | Geschäftsführer | Underhill Road SE22 0BT London 25 United Kingdom | England | British | Brand Development | 129295990001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CL 2022 LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conran Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Shad Thames SE1 2YU London 22 Shad Thames England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat CL 2022 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 15. Mai 2019 Geliefert am 20. Mai 2019 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung 4 fixed security. 4.1 as continuing security for the payment of the secured liabilities each chargor with full title guarantee:. 4.1.1 charges to the chargee by way of fixed charge its interest in:. (A) any freehold or leasehold property whether owned at the date of this debenture by any chargor or acquired subsequently, save that where the consent of any landlord is required to any such charge it will not take effect until such consent has been obtained or the need for it under this debenture has been waived by the chargee;. (B) all existing and future fixed assets, stock, intellectual property, goodwill, contracts and debts;. (C) the equipment;. (D) any investment;. (E) its existing and future goodwill and uncalled capital;. (F) all existing and future cash at bank; and. (G) any sum now or at any time after the date of this debenture received by the chargor as a result of any order of the court under sections 213, 214, 238, 239 or 244 of the insolvency act 1986;. 4.1.2 assigns to the chargee by way of security its interest in and the benefit of all agreements entered into on or before the date of this debenture and the benefit of any guarantee or security for the performance of any of such agreements provided that if any such agreement, guarantee or security is expressed to be non-assignable then the relevant chargor charges to the chargee by way of fixed charge its interest in and the benefit of it;. 4.1.3 assigns to the chargee by way of security its interest in the rental income and charges to the chargee by way of fixed charge its interest in all other debts;. 4.1.4 assigns to the chargee all claims and other rights of the chargor (present and future) against or in relation to any third party including all rights and interests of the chargor under all policies of insurance either now or in the future held by or written in favour of the chargor or in which the chargor is otherwise interested; and. 4.1.5 charges to the chargee by way of fixed charge all other existing and future property of the chargor not charged or assigned by the previous paragraphs of this clause (other than the chargor’s stock in trade).. 4.2 each chargor hereby undertakes to use its best endeavours to procure as soon as practical the consent of any landlord that may at any time and from time to time be required for the creation of a charge pursuant to clause 4.1 over any property for the time being of the chargor. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 14. Dez. 2018 Geliefert am 21. Dez. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Any freehold or leasehold property; all fixed assets, stock, intellectual property, goodwill, contracts and debt, equipment, investments and future good will and uncalled capital and cash at bank.. For more details please refer to the instrument. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0